BRENT WALKER BREWERIES LIMITED

BRENT WALKER BREWERIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRENT WALKER BREWERIES LIMITED
    UnternehmensstatusVerwalter bestellt
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01686002
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRENT WALKER BREWERIES LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich BRENT WALKER BREWERIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRENT WALKER BREWERIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ELLERMAN HOLDINGS LIMITED13. Dez. 198313. Dez. 1983
    SHIRESPELL LIMITED11. Okt. 198311. Okt. 1983
    EIGHTH SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED10. Dez. 198210. Dez. 1982

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRENT WALKER BREWERIES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2002
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Okt. 2003
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für BRENT WALKER BREWERIES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis14. Juni 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung28. Juni 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRENT WALKER BREWERIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRENT WALKER BREWERIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    legacy

    3 SeitenLQ02

    legacy

    3 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 14. Dez. 1998

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    Seiten3.6

    Verschiedenes

    Form 3.2 statement of affairs
    8 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    14 Seiten3.10

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 1996

    14 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    Seiten363a

    legacy

    Seiten363(353)

    legacy

    Seiten363(190)

    legacy

    6 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von BRENT WALKER BREWERIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Sekretär
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Geschäftsführer
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    BritishChartered Secretary82410610001
    LEACH, John Leslie
    Dunelm
    Church Road
    KT10 0JP Claygate
    Surrey
    Geschäftsführer
    Dunelm
    Church Road
    KT10 0JP Claygate
    Surrey
    BritishFinance Director1411850002
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    British1812400001
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Geschäftsführer
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritishCompany Director53682420001
    SANDS, John Robert
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    Geschäftsführer
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    United KingdomBritishCompany Director141561650001
    SCOBIE, Kenneth Charles
    Path Hill House Path Hill
    Goring Heath
    RG8 7RE Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Path Hill House Path Hill
    Goring Heath
    RG8 7RE Reading
    Berkshire
    EnglandBritishChartered Accountant8867190001
    SHARMA, Ravi
    82 Crowley Road
    IG1 3JJ Ilford
    Essex
    Geschäftsführer
    82 Crowley Road
    IG1 3JJ Ilford
    Essex
    BritishCompany Director28964500001
    WARD, Charles John Nicholas
    Bacon House Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Bacon House Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishManaging Director78441480001

    Hat BRENT WALKER BREWERIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed supplemental to three composite guarantees and debentures dated 15TH november 1990,28TH march 1991 and 27TH march 1992
    Erstellt am 17. Juni 1997
    Geliefert am 07. Juli 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies,liabilities and other obligations of whatsoever nature due,owing or incurred by the brent walker group PLC and each of it's subsidiaries (other than the company) for the time being and from time to time to the chargee as agent and trustee for itself each of the existing lenders and hambros leasing limited (the new lender)under the term facilities agreement dated 27TH march 1992 and certain related agreements and documents (the "operative agreements")
    Kurze Angaben
    Please refer to form 395 for full details of charged property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 07. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed supplemental to three composite guarantees and debentures dated 15TH november 1990 28TH march 1991 and 27TH march 1992
    Erstellt am 01. Feb. 1995
    Geliefert am 20. Feb. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the term facility agreement dated 27TH march 1992 and the "operative agreements" (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankts B.V.Acting as Agent and Trustee for Emenex Investmen
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 11. März 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The William Hill Group Limited
    Transaktionen
    • 11. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 1993
    Geliefert am 07. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due from pubmaster limited to the chargee under the terms of £115,000,000 floating rate refinanceable secured loan notes 1993-2011 (as defined)
    Kurze Angaben
    The legal mortgage in the legal estates in the l/h and f/h and heritable and other land and buildings etc.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Brent Walker Group PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 14. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 2.1 of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    See for 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The William Hill Group Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 27. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankof the Lenders as Definedacting as Agent and Trustee for Itself and Each
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 1998Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 215. Dez. 2009Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 2
    Debenture
    Erstellt am 09. Dez. 1991
    Geliefert am 19. Dez. 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due from pubmaster limited to the chargee under the terms of the loan notes and loan stock as defined in the debenture
    Kurze Angaben
    The legal estates in the f/h and l/h and heritable or other land etc.. (see form 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Brent Walker Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Nov. 1991
    Geliefert am 28. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement dated 11TH november 1991
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M158 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Juli 1991
    Geliefert am 18. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the brent walker group PLC and certain of its subsidiaries to the chargee under the terms of the facility agreement dated 1/7/91
    Kurze Angaben
    By way of first legal montgage the legal estate in all that f/h, l/h heritage or other land or buildings (see M131 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 18. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 28. März 1991
    Geliefert am 17. Apr. 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of a facility agreement dated 28/03/91 and this deed
    Kurze Angaben
    (Sec doc M157 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 19. Feb. 1991
    Geliefert am 08. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from brent walker limited to the chargee under the terms of the facility agreement dated 19/2/91 and this deed
    Kurze Angaben
    (See doc M151 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 08. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 24. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 13. Feb. 1991
    Geliefert am 05. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in and under the debenture dated 15TH november 1990
    Kurze Angaben
    F/H and l/h land and buildings described against the name of the company (see form 395-ref M196 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Lenders as Defined)(As Agent and Trustee for Itself and Each of The
    Transaktionen
    • 05. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 24. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 13. Feb. 1991
    Geliefert am 05. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC to the chargee under the terms of the standby loan facility agreement and debenture both dated 15/11/90 and this deed
    Kurze Angaben
    All freehold and leasehold land and bldgs, fixtures fixed plant and machinery (see doc m 215 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 05. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 24. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 15. Nov. 1990
    Geliefert am 30. Nov. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See doc M136 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Lenders as Defined)(As Agent and Trustee for Itself and Each of The
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 23. Jan. 1998Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 115. Dez. 2009Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 15. Nov. 1990
    Geliefert am 30. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the brent walker group PLC to the chargee under the terms of the standby facility agreement dated 15/11/90 and this deed
    Kurze Angaben
    (See doc M108 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed supplemental to a memorandum of mortgage and charge
    Erstellt am 29. Sept. 1988
    Geliefert am 12. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    I hereby certify that a deed of variation for varying the terms of a memorandum of mortgage and charge dated 9.6.87 was registered pursuant to chapter 1 part X11 of the companies act 1985 on the 12.10.88
    Kurze Angaben
    (See form 395 ref: M420C for full details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    Deed supplemental to a memorandum of mortgate and charge
    Erstellt am 29. Sept. 1988
    Geliefert am 12. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    I hereby certify that a deed of variation for varying the terms of a memorandum of mortgage and charge dated 9.6.87
    Kurze Angaben
    (See form 395 ref: M419C for full details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    Floating charge
    Erstellt am 29. Sept. 1988
    Geliefert am 12. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies pursuant to a guarantee dated 9/6/87 as amended by a supplemental deed dated 29 sept 1988
    Kurze Angaben
    All the undertaking goodwill assets property and rights present & future uncalled capital all palents application trade marks trade names etc (see form 395 ref M232C for full details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    Memorandum of charge mortgage
    Erstellt am 29. Sept. 1988
    Geliefert am 12. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 9/6/87 as amended by a supplemental deed dated 29/9/88 and under this charge
    Kurze Angaben
    1000 ordinary shares of sterling pounds 1 each representing the entire issued share capital of ellerman's finance limited at 29/9/88 and all other securities and all nights moneys & property whatsoeveer to be derived from accrue on any of the securities (see from 395-M231C).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    Memorandum of charge mortgage
    Erstellt am 09. Juni 1987
    Geliefert am 19. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement and guarantee both dated 9TH june 1987 and this charge
    Kurze Angaben
    12555000 ordinary shares of 50 pence and 511700 6 1/2% preference shares of sterling pounds 1 each representing the entire issued share capital of tollemoche & cobbold breweries limited and all other securities and all rights, moneys and property whatsoever (see from M395 for futther details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 19. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    Memorandum of charge mortgage
    Erstellt am 09. Juni 1987
    Geliefert am 19. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement and guarantee both dated 09TH june 1987 and this charge
    Kurze Angaben
    44612112 ordinary shares of 25 pence each, 253274 5% preference shares of sterling pounds 1 each and 300000 6% preference shares of sterling pounds 1 each representing the entire issued share capital J.W. cameron & co., Limited and all other securities and all rights, moneys and property (see from M395 for further details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 19. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    Deed
    Erstellt am 31. Dez. 1984
    Geliefert am 17. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from M.F. north PLC to the chargee under the terms of the financing documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • First National Boston Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 11. Nov. 1983
    Geliefert am 01. Dez. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to first national boston limited acting as agent for itself and several other lenders under the terms of a credit agreement and a guarantee and consent agreement both dated 11-11-83 the royal bank of scotland PLC facilities the debenture itself and the other agreements and mortgage debentures defined therein and other monies due under the terms of the change
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, and the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston
    • Trust National Boston Limited
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1983Registrierung einer Belastung

    Hat BRENT WALKER BREWERIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Nov. 1990Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Scott Barnes
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praktiker
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Martin Gilbert Ellis
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    2
    DatumTyp
    27. März 1992Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Scott Barnes
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praktiker
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Martin Gilbert Ellis
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0