LINPAC MOULDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LINPAC MOULDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01696691 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LINPAC MOULDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LINPAC MOULDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Linpac Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LINPAC MOULDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LIN PAC MOULDINGS LIMITED | 06. Mai 1983 | 06. Mai 1983 |
| CASTLEFORUM LIMITED | 03. Feb. 1983 | 03. Feb. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LINPAC MOULDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LINPAC MOULDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Aug. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Juni 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roxane Manuela Tamas als Sekretär am 17. Juni 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Victor Khosla as a person with significant control on 30. Juni 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Linpac Finance (No. 3) Ltd as a person with significant control on 30. Juni 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Burton Lence als Sekretär am 31. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Ms. Roxane Manuela Tamas als Sekretär am 01. Nov. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Philip Nicholls als Geschäftsführer am 01. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr. Adam Richard Barnett als Direktor am 01. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LINPAC MOULDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNETT, Adam Richard | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | England | British | 154433520001 | |||||
| FENSOME, Richard James | Sekretär | Ravenscroft 15 Fulmer Drive SL9 7HH Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 84096960001 | ||||||
| JOSEPH, Simon Elliot | Sekretär | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | British | 113862500001 | ||||||
| LENCE, Robert Burton | Sekretär | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | 242297990001 | |||||||
| SMITH, Andrew Tyler | Sekretär | Saint Osyth Legbourne LN11 8LL Louth Lincolnshire | British | 726320001 | ||||||
| TAMAS, Roxane Manuela, Ms. | Sekretär | Kingdom Street W2 6BD London 4 England | 264218130001 | |||||||
| TENTORI, Mark Ian | Sekretär | Holly Hedges Tingrith Road Evershot MK17 9EF Milton Keynes Buckinghamshire | British | 119564310001 | ||||||
| BRADLEY, David | Geschäftsführer | Hambleton Grange Burton Leonard HG3 3RX Harrogate North Yorkshire | British | 65302630001 | ||||||
| CARR, Nigel Edmund | Geschäftsführer | 3180 Park Square Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 146677560001 | |||||
| COOPER, Rodney | Geschäftsführer | Cornerways The Paddock, Willaston CW5 7HJ Nantwich Cheshire | British | 78924710001 | ||||||
| CORNISH, Herbert Evan | Geschäftsführer | Kenilworth Sylvan Avenue LN10 6SL Woodhall Spa Lincolnshire | British | 3789040001 | ||||||
| CORNISH, Michael John | Geschäftsführer | Mistlethwaite House Edlington LN9 5RJ Horncastle Lincolnshire | England | British | 16627750004 | |||||
| DOUGHTY, John Leslie | Geschäftsführer | 1 Pine Walk Histons Hill WV8 2HB Codsall Staffordshire | British | 16979510001 | ||||||
| HANKS, Robert Sinclair | Geschäftsführer | 3 Green Park Road Parklands B60 2RD Bromsgrove Worcestershire | British | 26392220004 | ||||||
| HEATON, Ronald | Geschäftsführer | Greystones 97 Bourn View Road Netherton HD4 7LA Huddersfield West Yorkshire | British | 35068350001 | ||||||
| HOLLOWAY, Robin Charles Alexander | Geschäftsführer | 47 Silhill Hall Road B91 1JX Solihull West Midlands | British | 62546520001 | ||||||
| JARRETT, John | Geschäftsführer | 4 The Orchards Eaton Bray LU6 2DD Dunstable Bedfordshire | British | 16979520001 | ||||||
| JOSEPH, Simon Elliot | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | United Kingdom | British | 113862500001 | |||||
| LANG, Robert Alexander | Geschäftsführer | 6360 River Overlook Drive FOREIGN Atlanta Ga30328 Georgia Usa | British | 102537350001 | ||||||
| NICHOLLS, Michael Philip | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | United Kingdom | British | 133570750001 | |||||
| PALMER, Ian Rodney | Geschäftsführer | Dairy Barn Upper Harlestone NN7 4EL Northampton | England | British | 9138760001 | |||||
| PAUL, Richard Neil | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | England | British | 43099210003 | |||||
| POOLE, Richard John | Geschäftsführer | 20 Thorpe Court B91 1SU Solihull West Midlands | British | 61056100003 | ||||||
| RAY, Stephen Douglas | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | England | British | 147866070001 | |||||
| ROBINSON, Ian | Geschäftsführer | 3180 Park Square Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 116037630001 | |||||
| SHANLEY, Patrick | Geschäftsführer | Stratford Road Wootton Wawen B95 6AP Henley-In-Arden Clover Bank House West Midlands | England | British | 130362780001 | |||||
| SMITH, Andrew Tyler | Geschäftsführer | Saint Osyth Legbourne LN11 8LL Louth Lincolnshire | British | 726320001 | ||||||
| STERN, Peter Alan Powell | Geschäftsführer | Acre End Back Lane Cammeringham LN1 2SH Lincoln Lincolnshire | British | 9581840001 | ||||||
| STOKE, Jeremy Michael | Geschäftsführer | The Round House 16 St James Road Edgbaston B15 1JR Birmingham West Midlands | British | 1389890001 | ||||||
| STOKES, Gary Martin | Geschäftsführer | 16a Fiery Hill Road Barnt Green B45 8LG Birmingham West Midlands | England | British | 71396660002 | |||||
| TAYLOR, Brian | Geschäftsführer | 2 The Copse Tyms Way SS6 8DG Rayleigh Essex | England | British | 208320810001 | |||||
| TENTORI, Mark Ian | Geschäftsführer | Holly Hedges Tingrith Road Evershot MK17 9EF Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 119564310001 | |||||
| THORP, John Peter | Geschäftsführer | 8 The Oaks Silsoe MK45 4EL Bedford Bedfordshire | British | 35068340001 | ||||||
| WILLIAMS, David Arthur | Geschäftsführer | 9 The Crescent Hartford CW8 1QS Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 16979530001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LINPAC MOULDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Victor Khosla | 30. Juni 2016 | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Linpac Finance (No. 3) Ltd | 30. Juni 2016 | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Wakefield Road England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LINPAC MOULDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Share mortgage | Erstellt am 19. März 2010 Geliefert am 31. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and any other obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The mortgaged property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2009 Geliefert am 23. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 25 september 2003 and | Erstellt am 01. März 2007 Geliefert am 07. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 25 september 2003 | Erstellt am 20. Apr. 2005 Geliefert am 26. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any money or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee of set -off agreement dated 25 september 2003 | Erstellt am 07. Jan. 2005 Geliefert am 13. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Sept. 2003 Geliefert am 16. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and any other obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First legal mortgage all real property, all of the charged deposits, all investments and all related rights, all of its rights title interest and benefits in to or in respect of the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 20 march 2002 | Erstellt am 18. Mai 2003 Geliefert am 30. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 20TH march 2002 and | Erstellt am 25. Juli 2002 Geliefert am 07. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0