HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01697114 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HIGHWAY VEHICLE LEASING (1996) LIMITED | 24. Jan. 1997 | 24. Jan. 1997 |
| HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED | 30. Aug. 1994 | 30. Aug. 1994 |
| HIGHWAY FINANCE HOLDINGS PLC | 02. Aug. 1983 | 02. Aug. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Sutton als Geschäftsführer am 11. Aug. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom zum 25 Gresham Street London EC2V 7HN geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Gresham Street London EC2V 7HN zum 1 More London Place London SE1 2AF am 21. Jan. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Sutton am 28. Feb. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare am 24. Jan. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Staples als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Lloyds Secretaries Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Blackwell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Sutton als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOYDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom |
| 73512200003 | ||||||||||
| SARFO-AGYARE, Claude Kwasi | Geschäftsführer | Hatchford Way B26 3RZ Birmingham Blake House United Kingdom | United Kingdom | British | 170061790001 | |||||||||
| HOPKINS, Stephen John | Sekretär | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 149222580001 | |||||||||||
| MACLEOD, Donald Miller | Sekretär | 37 Kenningknowes Road FK7 9JF Stirling Stirlingshire | British | 319620001 | ||||||||||
| SAUNDERS, Deborah Ann | Sekretär | 25 Gresham Street EC2V 7HN London | Other | 38589290002 | ||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||||||
| ANDERSON, David Gordon | Geschäftsführer | 16 The Ness FK14 7EB Dollar Clackmannanshire | British | 177360001 | ||||||||||
| BLACKWELL, Timothy Mark | Geschäftsführer | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | England | British | 124967310001 | |||||||||
| BOON, Dennis Antony | Geschäftsführer | 5 Knights Way Stoneywood FK6 5HG Denny Stirlingshire | British | 20616040001 | ||||||||||
| CUMMING, Robert George | Geschäftsführer | The Granary West Moss-Side Thornhill FK8 3QJ Stirling | British | 41709670002 | ||||||||||
| DAVIES, John Lewis | Geschäftsführer | 68 The Plain CM16 6TW Epping Essex | British | 51486560001 | ||||||||||
| DUNN, Alastair Andrew | Geschäftsführer | Braishfield Manor Braishfield SO51 0PS Romsey Hampshire | United Kingdom | British | 178790002 | |||||||||
| FINCHAM, Nigel | Geschäftsführer | The Shambles 34 Treves Close Winchmore Hill N21 1TT London | British | 69282810001 | ||||||||||
| GRAHAM, Roderick Neil | Geschäftsführer | 5 Loneacre Chertsey Road GU20 6JH Windlesham Surrey | British | 51466570001 | ||||||||||
| GRANT, Ian Alfred | Geschäftsführer | Luangwa Coed Y Garth Furnace SY20 8PG Machynlleth Powys | British | 9559200002 | ||||||||||
| KILBEE, Michael Peter | Geschäftsführer | Wychway Cavendish Road KT13 0JW Weybridge Surrey | British | 19310990002 | ||||||||||
| MACLEOD, Donald Miller | Geschäftsführer | 37 Kenningknowes Road FK7 9JF Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 319620001 | |||||||||
| MACLEOD, Donald Miller | Geschäftsführer | 37 Kenningknowes Road FK7 9JF Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 319620001 | |||||||||
| MCLEAN, Colin Richard | Geschäftsführer | 18 Springfield GU18 5XP Lightwater Surrey | British | 5382220001 | ||||||||||
| ORR, Andrew | Geschäftsführer | 4 Allandale Crescent Greenloaning FK15 0LR Dunblane Perthshire | British | 41709940001 | ||||||||||
| POTTS, David Keith | Geschäftsführer | 23 Woodchester Park Knotty Green HP9 2TU Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 5774320002 | |||||||||
| STAPLES, Martin Kenneth | Geschäftsführer | 1 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh Princes Exchange Scotland | Scotland | British | 110383950001 | |||||||||
| STEAD, Nigel Cleator | Geschäftsführer | Northend Timble LS21 2NN Otley West Yorkshire | England | British | 47582470001 | |||||||||
| STEWART, David Howat | Geschäftsführer | 6 Carew Lodge Carew Road HA6 3NH Northwood Middlesex | England | British | 108672850001 | |||||||||
| STURT SCOBIE, James | Geschäftsführer | Hazelhurst Willow Hall Drive HX6 2BL Halifax West Yorkshire | British | 65652830001 | ||||||||||
| SUTTON, Christopher | Geschäftsführer | Orchard Brae EH4 1PF Edinburgh Finance House United Kingdom | Scotland | British | 130660440002 | |||||||||
| WEIGH, Peter Langford | Geschäftsführer | 191 Windlehurst Road High Lane SK6 8AG Stockport Cheshire | British | 318550002 | ||||||||||
| WHITE, Adrian Patrick | Geschäftsführer | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | England | British | 130578200001 | |||||||||
| FIRST NATIONAL CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | 53-61 College Road HA1 1FB Harrow Middlesex | 79989520002 |
Hat HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of assignment | Erstellt am 03. Dez. 1996 Geliefert am 18. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of any hiring agreements | |
Kurze Angaben All right title and benefit under the sub hire agreements the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 12. Sept. 1996 Geliefert am 19. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements in respect of goods and all other monies payable under or in respect of all hire purchase and conditional sale agreements | |
Kurze Angaben The sub hiring agreements in respect of the goods all monies payable the benefit of all guarantees indemnities and other securities and the benefit of all insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 09. Juli 1996 Geliefert am 11. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 28TH november 1994 | |
Kurze Angaben All rights benefits and interest of the company present and future in and to sub-hire agreements (as defined) and the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection therewith. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 02. Juli 1996 Geliefert am 03. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements in respect of goods ("the goods") | |
Kurze Angaben The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods: vauxhall cavalier 1.8 5DR hatch 5SP reg no piw 4080 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements: date of sub-hiring agreement 01/06/95 ref no 106780. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 02. Juli 1996 Geliefert am 03. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements in respect of goods ("the goods") | |
Kurze Angaben The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods: vauxhall cavalier 1.6LS dr hatch reg no M992 gnr and the full benefit and advantage of the said hiring agreements: date of sub-hiring agreement 01/10/95 ref no 106868. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 02. Jan. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or lease purchase agreements in respect of goods | |
Kurze Angaben The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods as listed in the schedule to the form 395 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements (the goods including daimler 4.0, reg. No. 66BWC). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 02. Jan. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or lease purchase agreements in respect of goods | |
Kurze Angaben The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods listed in the schedule to the form 395 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements (the goods including mercedes benz c class 2.2 c, reg. No. M134 tgm). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 02. Jan. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or lease purchase agreements in respect of goods | |
Kurze Angaben The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods as listed in the schedule to the form 395 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements (the goods including mercedes benz e series 3.0 e, reg. No. M135 tgm). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 02. Jan. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or lease purchase agreements in respect of goods | |
Kurze Angaben The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods as listed in the schedule to the form 395 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements (the goods including ford scorpio 2.0 16V ultima reg. No. M125 sna). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 04. Aug. 1995 Geliefert am 05. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the credit agreements (as defined) | |
Kurze Angaben All sub-lease agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 28. Juli 1995 Geliefert am 31. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 28TH november 1994 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest in and to sub-hire agreements between the company and various sub-hirers as specified in the schedule to the assignment and the benefit of all guarantees indemnities etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on hiring agreements. | Erstellt am 09. März 1995 Geliefert am 11. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title and interest in respect of motor vehicles which are from time to time during the continuance of this security in the possession (actual or constructive) ownership or otherwise of the company in whatsoever capacity provided that the motor vehicles charged shall be limited to those motor vehicles which are comprised in the contracts. Please see doc for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Master agreement and certificate of assignment | Erstellt am 30. Nov. 1994 Geliefert am 08. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement 28TH november 1994 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest in and to sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Master agreement and charge | Erstellt am 31. Okt. 1994 Geliefert am 31. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to any lease purchase conditional sale or bailement agreement (as defined) and/or this charge | |
Kurze Angaben Any agreement made whether before on or after the date of the charge between the customer (as defined in the charge) and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire (the sub lessee) whereby the customer lets or agrees to let the goods. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 03. Okt. 1994 Geliefert am 05. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Interest from time to time of the company in all motor vehicles which are now or hereafer becomee mater of a hiring agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0