SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01700975 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?
- Herstellung von Papierwaren (17230) / Verarbeitendes Gewerbe
- Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1580 Parkway Solent Business Park Whiteley PO15 7AG Fareham Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MINKFLOW LIMITED | 21. Feb. 1983 | 21. Feb. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 22 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 22 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | AM06 | ||
Vorschlag des Verwalters | 48 Seiten | AM03 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA/AM02SOC | 13 Seiten | AM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit B5 Millbrook Close Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 4BZ England zum 1580 Parkway Solent Business Park Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AG am 24. März 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Dez. 2021 bis 29. Dez. 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Mr Maxwell Middleton as a person with significant control on 31. Dez. 2021 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 12 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maxwell Middleton am 15. März 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Change of details for Mr Maxwell Middleton as a person with significant control on 15. März 2020 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 13 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 12 Seiten | AA | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2018 bis 30. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Snows Business Forms Limited Manor House Avenue Millbrook Southampton SO15 0DF England zum Unit B5 Millbrook Close Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 4BZ am 19. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 13 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUTTS, Linda Anne Rachel | Geschäftsführer | Cull Lane BH25 5QH New Milton 62 Hampshire United Kingdom | England | British | 150994450001 | |||||
| MIDDLETON, Maxwell | Geschäftsführer | Solent Business Park Whiteley PO15 7AG Fareham 1580 Parkway Hampshire | England | British | 62972490010 | |||||
| CUTTS, Grahame Lindsay | Sekretär | 62 Cull Lane BH25 5QH New Milton Hampshire | Australian | 34864180002 | ||||||
| CUTTS, Linda Anne Rachel | Sekretär | 62 Cull Lane BH25 5QH New Milton Hampshire | British | 59075960001 | ||||||
| WESTWOOD SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Numerica Secretaries Limited 66 Wigmore Street W1U 2HQ London | 72462860002 | |||||||
| ASKHAM, Francis Guy Lewis | Geschäftsführer | 10 Love Lane SO51 8DE Romsey Hampshire | British | 15237500002 | ||||||
| ASKHAM, Francis Guy Lewis | Geschäftsführer | Spinney Corner Church Lane Braishfield SO51 0QH Romsey Hampshire | United Kingdom | British | 15237500001 | |||||
| CARMICHAEL, Robert Neil Bruce | Geschäftsführer | 82 Stanhope Mews East SW7 5QT London | United Kingdom | British | 65088590001 | |||||
| CUTTS, Grahame Lindsay | Geschäftsführer | 62 Cull Lane BH25 5QH New Milton Hampshire | United Kingdom | Australian | 34864180002 | |||||
| JUDD, David | Geschäftsführer | 66 Sunderton Lane PO8 0NT Waterlooville Hampshire | British | 62972310001 | ||||||
| JUPE, Andrew Ian | Geschäftsführer | 27 Brook Court Brook Valley SO16 6SR Southampton | British | 62972580001 | ||||||
| LANDAU, David Aaron | Geschäftsführer | 38 North Audley Street Mayfair W1K 6ZN London | United Kingdom | British | 10648180003 | |||||
| SINGH, Sarvindra | Geschäftsführer | 5 Somerset Gardens Highgate Gardens N6 5EQ London | England | British | 43283210001 | |||||
| SMITH, Neil Jonathan | Geschäftsführer | 3 Kestrel Close Marchwood SO40 4XL Southampton | England | British | 62976820003 | |||||
| STRANGE, Alan Lee | Geschäftsführer | 67 Ardingly Crescent Hedge End SO30 2TE Southampton Hampshire | British | 73649120001 | ||||||
| WINTERIDGE, Brian Jack | Geschäftsführer | St Jaques Cottage Old Romsey Road SO4 2ND Cadnam Hampshire | British | 16732920001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mrs Linda Anne Rachel Cutts | 06. Apr. 2016 | Solent Business Park Whiteley PO15 7AG Fareham 1580 Parkway Hampshire | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Maxwell Middleton | 06. Apr. 2016 | Solent Business Park Whiteley PO15 7AG Fareham 1580 Parkway Hampshire | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 13. Aug. 2015 Geliefert am 26. Aug. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung F/H land and buildings lying to the south of millbrook road southampton t/no HP203449. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Feb. 2015 Geliefert am 09. Feb. 2015 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Jan. 2015 Geliefert am 12. Jan. 2015 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 15. Sept. 2005 Geliefert am 21. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Manor house avenue southampton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Sept. 2005 Geliefert am 21. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildingd lying to the south at hillbrook road southampton k/a manor house avenue southampton t/n HP203449. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 30. Juli 1998 Geliefert am 07. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due or payable by virtue of any guarantee or indemnity given to the chargee by the company under the debt purchase agreement dated 30TH july 1998 | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 30. Juli 1998 Geliefert am 07. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Juli 1998 Geliefert am 07. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a manor house avenue or as land and buildings lying to the south of millbrook road southampton t/no.HP203449. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 1993 Geliefert am 16. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 22. Apr. 1992 Geliefert am 23. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 new drent gazelle 6 imr continuous paper printing machine serial no P11257335 833. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Juni 1989 Geliefert am 13. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings on south side of millbrook road, southampton, hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Juni 1989 Geliefert am 13. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H premises k/a unit 2 mayflower close, clandlers ford, eastleigh, hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 10. Mai 1989 Geliefert am 17. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all book and other debts. Flaotinig charge on all other the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Mai 1984 Geliefert am 19. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts legal mortgage over land & buioldings at the south of milbrook road southampton title no hp 203449 and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 31. Mai 1984 Geliefert am 01. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H unit 2 mayflower close, chandlersford industrial, estate, chandlers ford, hampshire and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 16. Juni 1983 Geliefert am 18. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 14 june 1983. | |
Kurze Angaben Property lying to the south of millrook road, saithampton, tog. With all building, fixtures, fixed plant & machinery thereon title no: 263499. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 14. Juni 1983 Geliefert am 04. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge all book debts and other debts floating charge on (please see doc M13). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Juni 1983 Geliefert am 04. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings at the south of middbook road, southampton. Title no hp 203449. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juni 1983 Geliefert am 18. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, stock in trade work-in progress, investments, cash & pre-payments, tog. With all buildings & fuxtures, fixed plant and machinery (see doc M11). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0