JARDINERIE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | JARDINERIE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01706932 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JARDINERIE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich JARDINERIE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JARDINERIE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KEN ALLEN GARDEN CENTRES LIMITED | 16. März 1983 | 16. März 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JARDINERIE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JARDINERIE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Roger Mclaughlan als Geschäftsführer am 01. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Mary Elizabeth Bourlet als Sekretär am 01. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Laura Harradine-Greene als Sekretär am 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 25. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Mary Elizabeth Murray am 12. Mai 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Gerald Jones am 03. Apr. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Justin Matthew King als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mary Elizabeth Murray als Sekretär am 25. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Dez. 2015 | 8 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Justin Matthew King als Direktor am 18. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Thomas Murphy als Geschäftsführer am 18. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Gerald Jones am 22. Juli 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Roger Mclaughlan als Direktor am 10. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Nils Olin Steinmeyer als Geschäftsführer am 01. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Kevin Michael Bradshaw als Geschäftsführer am 09. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Anthony Gerald Jones als Direktor am 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Stephen Thomas Murphy als Direktor am 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Garden Centre Group, Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF zum Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF am 24. Feb. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von JARDINERIE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRADINE-GREENE, Laura | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 242726240001 | |||||||
| JONES, Anthony Gerald | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 212265950002 | |||||
| ALLEN, Ann Elizabeth | Sekretär | Brook Cottage Kilcot GL18 1NR Newent Gloucestershire | British | 5527460001 | ||||||
| BOURLET, Mary Elizabeth | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 217312210002 | |||||||
| FOALE, Stephen John | Sekretär | 42 Holmbury Avenue RG45 6TQ Crowthorne Berkshire | British | 37403500001 | ||||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Sekretär | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | 76162020001 | ||||||
| ALLEN, Ann Elizabeth | Geschäftsführer | Brook Cottage Kilcot GL18 1NR Newent Gloucestershire | United Kingdom | British | 5527460001 | |||||
| ALLEN, Kenneth Henry | Geschäftsführer | Brook Cottage Kilcot GL18 1NR Newent Gloucestershire | United Kingdom | British | 5527470001 | |||||
| BERTRAM, Richard Christiaan | Geschäftsführer | 18 Ham Island Old Windsor SL4 2JY Windsor Berkshire | British | 6217370002 | ||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 124019940001 | |||||
| BRAID, William | Geschäftsführer | Beechwood House Springfields GL17 9BW Drybrook Gloucestershire | British | 72263080001 | ||||||
| BRIGDEN, Peter | Geschäftsführer | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 195802400001 | |||||
| FOALE, Stephen John | Geschäftsführer | 42 Holmbury Avenue RG45 6TQ Crowthorne Berkshire | England | British | 37403500001 | |||||
| HODKINSON, James Clifford | Geschäftsführer | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Geschäftsführer | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| KING, Justin Matthew | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 213157990001 | |||||
| KING, Wendy | Geschäftsführer | 9 Fielden Abbeydale GL4 5EW Gloucester Gloucestershire | England | British | 89910600001 | |||||
| KITCHING, Jonathan Andrew | Geschäftsführer | Beech House Harp Hill GL52 6PR Cheltenham | England | British | 68271660002 | |||||
| KITCHING, Julie | Geschäftsführer | Hill View Cottage Pamington GL20 8LT Tewkesbury Gloucestershire | British | 32857190001 | ||||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Geschäftsführer | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LIVINGSTON, William Andrew | Geschäftsführer | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | 111439220001 | |||||
| LORIMER, Alistair Martin | Geschäftsführer | 3 Aston Cantlow Road Wilmcote CV37 9XN Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 64929030001 | |||||
| LORIMER, Alistair Martin | Geschäftsführer | 3 Aston Cantlow Road Wilmcote CV37 9XN Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 64929030001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Geschäftsführer | Glan Honddu House Llandefaelog Fach LD3 9PP Brecon Powys | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 206428840001 | |||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 207509410001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Geschäftsführer | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Geschäftsführer | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | 76162020001 | |||||
| SAJID, Salim | Geschäftsführer | Apple Croft 9 High Street HP17 8ES Haddenham | British | 75730550003 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| STEVENSON, Barry John | Geschäftsführer | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | 102595670001 | |||||
| ULYATT, Patricia Mary | Geschäftsführer | Northington Cottage Awre GL14 1BN Newham On Severn Gloucestershire | British | 24998620001 | ||||||
| ULYATT, Peter Nicholas | Geschäftsführer | Northington Cottage Awre GL14 1BN Newham On Severn Gloucestershire | British | 24998630001 | ||||||
| WARES, Hugh David Mcdonald | Geschäftsführer | 12 Old Sneed Park BS9 1RF Bristol | British | 84123870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei JARDINERIE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blooms Of Bressingham Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Limited England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat JARDINERIE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 24. Feb. 2009 Geliefert am 04. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to the debenture | Erstellt am 12. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (For details of properties charged pleas. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 29. Mai 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 29. Mai 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Feb. 2007 Geliefert am 24. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Juli 2003 Geliefert am 05. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a finebush nurseries hay lane studley grange swindon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as the garden centre at kenilworth rd,hampton in arden,solihull; wm 396108. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as st mellons garden centre,newport rd,cardiff. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as studley garden centre,studley green,high wycombe,buckinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as the garden centre at kenilworth rd,hampton in arden,solihull; wm 402338. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as jardinerie garden centre,evesham rd,bishop cleve together with additional land at evesham rd,bishop cleve,cheltenham,gloucestershire; t/no gr 221868. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as three crowns garden centre,walsall; t/no wm 402337. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as finebush nurseries,hay lane,studley grange,swindon; t/nos wt 140708 and wt 142181. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as haresfield garden centre,haresfield,gloucester; t/no gr 183956. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 18. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargee as trustee for the holders of the convertible secured loan stock of blooms of bressingham holdings PLC as the same is contributed by an instrument of even date and executed by blooms of bressingham holdings PLC | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the property st mellons garden centre newport road cardiff jardinerie garden centre evesham road bishop cleve together with additional land at evesham road bishop cleve cheltenham gloucestershire haresfield garden centre haresfield gloucester please refer to the form 395 for further details of the property charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Jan. 2001 Geliefert am 04. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben St mellons park garden centre st mellons cardiff. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Aug. 2000 Geliefert am 05. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a land on the south side of kenilworth road hampton in arden solihull west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. März 2000 Geliefert am 22. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a jardinerie garden centre evesham road cheltenham gloucestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1998 Geliefert am 22. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Jardinerie garden centre hay lane swindon wiltshire t/n WT140708 WT142181. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Nov. 1995 Geliefert am 08. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Nov. 1995 Geliefert am 06. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the south side of kenilworth road, hampton in arden, solihull, west midlands t/no. WM396108. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Nov. 1995 Geliefert am 06. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the south side of kenilworth road, hampton in arden, solihull, west midlands t/no. WM402338. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. März 1995 Geliefert am 24. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a finebush garden centre hay lane swindon and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Dez. 1993 Geliefert am 04. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a st. Mellons garden centre newport road cardiff t/n WA683954 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0