NEW CRANE WHARF LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNEW CRANE WHARF LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01708589
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NEW CRANE WHARF LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich NEW CRANE WHARF LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Fisher Partners Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NEW CRANE WHARF LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CONRAN ROCHE DEVELOPMENTS LIMITED22. März 198322. März 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEW CRANE WHARF LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NEW CRANE WHARF LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für NEW CRANE WHARF LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Kapitalaufstellung am 07. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    Reduce share capital a/c 24/03/2014
    RES14

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Heron House 4 Bentinck Street London W1U 2EF United Kingdom am 28. März 2014

    1 SeitenAD01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Simon Goldstein als Geschäftsführer am 31. Dez. 2013

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Daniel Simon Samson als Direktor am 31. Dez. 2013

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Lionel Harvey Zeltser am 27. Sept. 2010

    2 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Simon Goldstein am 27. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Heron House 19 Marylebone Road London NW1 5JL am 04. Okt. 2010

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von NEW CRANE WHARF LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ZELTSER, Lionel Harvey
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Sekretär
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    British82318190001
    RONSON, Gerald Maurice, Sir
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector33068600002
    SAMSON, Daniel Simon
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor183982890001
    BROWN, Steven Andrew
    36 St Marys Avenue
    N3 1SN London
    Sekretär
    36 St Marys Avenue
    N3 1SN London
    British107162240001
    FENCHELLE, Mark Stephen
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    Sekretär
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    British40682770001
    MORTON, Christopher John
    8 Wighton Mews
    TW7 4DZ Isleworth
    Middlesex
    Sekretär
    8 Wighton Mews
    TW7 4DZ Isleworth
    Middlesex
    British71879280001
    PARSONS, Neil
    12 The Warren
    SM5 4EH Carshalton
    Surrey
    Sekretär
    12 The Warren
    SM5 4EH Carshalton
    Surrey
    BritishSecretary67799270001
    ROBERTSON, Ian Donald Winton
    Ashley Gate 17 Ashley Park Road
    KT12 1JN Walton On Thames
    Surrey
    Sekretär
    Ashley Gate 17 Ashley Park Road
    KT12 1JN Walton On Thames
    Surrey
    British35557760001
    GOLDMAN, Alan Irving
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director8958700001
    GOLDMAN, Alan Irving
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector8958700001
    GOLDSTEIN, Jonathan Simon
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor68352140004
    KITCHEN, Daniel John
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Geschäftsführer
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    United KingdomBritishCompany Director153028260001
    LEWIS, Peter George Henry
    Mulberry House High Street
    Iron Acton
    BS17 1UQ Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    Mulberry House High Street
    Iron Acton
    BS17 1UQ Bristol
    Avon
    BritishDirector4783680001
    MARX, Michael Henry
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCo Director35019090001
    WATTS, Robert Alan
    19 Uplands Road
    West Moors
    BH22 0BB Ferndown
    Dorset
    Geschäftsführer
    19 Uplands Road
    West Moors
    BH22 0BB Ferndown
    Dorset
    BritishDirector28646160001

    Hat NEW CRANE WHARF LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Sept. 1993
    Geliefert am 08. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Exchange Trust Company Limitedas Trustee on Behalf of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Sept. 1993
    Geliefert am 08. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alnery No. 1283 Limited
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Sept. 1993
    Geliefert am 08. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as ssc trustee on behalf of the secured parties under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Sept. 1993
    Geliefert am 08. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee on behalf of the secured parties under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Juli 1987
    Geliefert am 14. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the guarantee and the facility letter of even date and under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    The land at new crane wharf, wapping, london E1 title no egl 182287 and all buildings, fixtures and fittings. All future f/h & l/h property of the company together with all buildings, fixtures & fittings (including trade fixtures & fittings) & fixed plant & machinery, goodwill & uncalled capital and all bookdebts & other debts due or owing to the company.
    Berechtigte Personen
    • Heron Corporation PLC.
    Transaktionen
    • 14. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 14. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment & charge.
    Erstellt am 02. Juli 1987
    Geliefert am 14. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the project agreement of evendate
    Kurze Angaben
    All moneys for the time being and from time to time standing to the credit of the proceeds account with lloyds bank PLC "(the bank)" numbered 1532044) (see form 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Heron Homes Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 25. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 02. Juli 1987
    Geliefert am 09. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures) see form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 25. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Proceeds account assignment and charge.
    Erstellt am 02. Juli 1987
    Geliefert am 09. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 2/7/87.
    Kurze Angaben
    All moneys for the time being and from time to time standing to the credit of the proceeds account with the bank numbered 1532044.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 25. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed
    Erstellt am 24. März 1987
    Geliefert am 25. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 15/8/86 & the facility letter dated 13/8/86
    Kurze Angaben
    Land at new crane wharf & the three suns public house, wapping E1 title no:- egl 182287.
    Berechtigte Personen
    • Heron Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1987Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 15. Aug. 1986
    Geliefert am 29. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at new crane wharf and the three suns public house wapping E1 title no's 168816, 300680 21358, ln 70267, ngl 312721, 245126.
    Berechtigte Personen
    • Heron Corporation PLC
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 15. Aug. 1986
    Geliefert am 29. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/7/86
    Kurze Angaben
    Land at new crane wharf and the three suns public house wapping E1 title no's 168816, 300680 21358, ln 70267, ngl 312721, 245126.
    Berechtigte Personen
    • Kestrel Properties Limited
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    • 07. Apr. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NEW CRANE WHARF LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. März 2014Beginn der Liquidation
    19. Dez. 2014Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0