ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED

ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01713670
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALBEMARLE & BOND PAWNBROKERS LIMITED08. Juni 198808. Juni 1988
    ALBEMARLE PAWNBROKERS LIMITED18. Feb. 198818. Feb. 1988
    ALBEMARLE & BOND PAWNBROKERS LIMITED04. Sept. 198604. Sept. 1986
    ALBEMARLE PAWNBROKERS LIMITED24. Nov. 198324. Nov. 1983
    DIGPOND LIMITED11. Apr. 198311. Apr. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 22. Sept. 2016

    15 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Juli 2016

    14 Seiten2.24B

    **Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 26

    8 SeitenMR05

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Jan. 2016

    15 Seiten2.24B

    Kündigung eines Administrators

    1 Seiten2.38B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Juli 2015

    15 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. März 2015

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. Sept. 2014

    20 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Nygel Scourfield als Geschäftsführer am 01. Aug. 2014

    2 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    11 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    24 Seiten2.17B

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 26

    11 SeitenMR05

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2Nd Floor 2 Burgage Square Merchant Gate Wakefield WF1 2TS* am 29. Apr. 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Paula Watts als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    29 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 15. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 200,000
    SH01

    Erfüllung der Belastung 21 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MORAN, Liam Kevin
    County House
    17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd Floor
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    County House
    17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd Floor
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish149505190001
    ARMOUR, Douglas William
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    170354660001
    FLANAGAN, Michael Anthony
    7a Hamilton Road
    Ealing
    W5 2EE London
    Sekretär
    7a Hamilton Road
    Ealing
    W5 2EE London
    Irish34791200003
    WALLACE, Susan Margaret
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    British95024880001
    WATTS, Paula Mary
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Sekretär
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    174916620001
    DAMARIO, Lynda
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Geschäftsführer
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    United KingdomBritish76785710002
    MARDON TAYLOR, Nicholas John
    6 Millers Court Chiswick Mall
    W4 2PF London
    Geschäftsführer
    6 Millers Court Chiswick Mall
    W4 2PF London
    EnglandBritish105294260003
    MURPHY, Jean Louise
    1 Monmouth Road
    Bishopston
    BS7 8LF Bristol
    Geschäftsführer
    1 Monmouth Road
    Bishopston
    BS7 8LF Bristol
    British55811680001
    MURPHY, Philip Patrick
    53 Pooles Wharf Court
    Hotwells
    BS8 4PB Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    53 Pooles Wharf Court
    Hotwells
    BS8 4PB Bristol
    Avon
    British21524180003
    NICHOLLS, Greville Vincent
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Geschäftsführer
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    United KingdomBritish51899820004
    PAGE, David Alistair Louden
    19 Harwell Road
    Sutton Courtenay
    OX14 4BN Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    19 Harwell Road
    Sutton Courtenay
    OX14 4BN Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish173283710001
    PATTINSON, David Phillip
    23 Blewbury Road
    OX11 9LE East Hagbourne
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    23 Blewbury Road
    OX11 9LE East Hagbourne
    Oxfordshire
    United KingdomNew Zealand76785870001
    SCOURFIELD, Nygel Paul
    Floor
    County House 17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    County House 17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish164256290001
    STEVENSON, Barry John
    2 Burgage Square
    Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2 Burgage Square
    Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish102595670001

    Hat ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent security deposit deed
    Erstellt am 18. März 2013
    Geliefert am 27. März 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest in the deposit account (initial deposit of £1,833.33) and all money from time to time withdrawn from the deposit account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clerical Medical Investment Group Limited
    Transaktionen
    • 27. März 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. Aug. 2012
    Geliefert am 11. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest in the amount from time to time standing to the credit of the separate bearing deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Arshad Mohammed
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 17. Nov. 2011
    Geliefert am 25. Nov. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights,all plant machinery vehicles computers,office and other equipment see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Parties
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 30. Apr. 2014Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 05. Mai 2016Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Rent security deposit deed
    Erstellt am 26. Jan. 2011
    Geliefert am 03. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clerical Medical Investment Group Limited
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 3RD november 2000 and
    Erstellt am 17. Juli 2007
    Geliefert am 25. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 07. Apr. 2004
    Geliefert am 08. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 603 cheetham hill road cheetham hill manchester t/n GM742678. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 20. März 2001
    Geliefert am 22. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7 and 9 havelock street blythe. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 20. März 2001
    Geliefert am 22. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    122 rushey green catford london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 03. Nov. 2000
    Geliefert am 22. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being 13/15 east street bedminster bristol. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Sept. 2000
    Geliefert am 28. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 07. Okt. 1996
    Geliefert am 12. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any agreement the debenture and the guarantee
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Brown Shipley & Co Limited
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 1996
    Geliefert am 10. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 13 east street bedminster bristol t/no. AV68953 and all buildings and fixtures and goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 21. Apr. 1994
    Geliefert am 27. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Lease
    Erstellt am 22. Dez. 1993
    Geliefert am 24. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £5,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 22 december 1993
    Kurze Angaben
    The sum of £5,000 plus interest thereon in the event that there is a claim under the lease or any sum owing under the lease which sum is to be deposited by the mortgagee with barclays bank PLC or such other clearing bank as the mortgagee shall nominate.
    Berechtigte Personen
    • Ilmaquil Investments Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 08. Juli 1991
    Geliefert am 10. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter dated 8/7/91
    Kurze Angaben
    Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Central Europe Corporation Sa
    Transaktionen
    • 10. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 13. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 06. Feb. 1991
    Geliefert am 16. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    An amount of up to sterling pounds 50000 due or to become due from the company to the chargee under a loan facility of even date and any other sums due thereunder
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • J S Gadd Holdings Limited
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 13. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 1988
    Geliefert am 16. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises situate at & k/a 124 city road, cardiff south glamorgan t/n wa 253035 & others (please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Fennoscandia Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 15. Sept. 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Apr. 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 1988
    Geliefert am 16. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises situate at & k/a 124 city road, cardiff south glamorgan t/n wa 253035 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including buildings fixtures fixed plant and machinery (please see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Fennoscandia Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 15. Sept. 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Apr. 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1987
    Geliefert am 25. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1030 stockport road levenshulme manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Henry Ausbacher & Co Limited
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 02. Nov. 1987
    Geliefert am 09. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1030 stockport road, levenshulme manchester greater manchester t/n p 199565.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1987Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 1987
    Geliefert am 22. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transaktionen
    • 22. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 1987
    Geliefert am 07. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    274 shirley road, southampton, hampshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 08. Apr. 1987
    Geliefert am 23. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1986
    Geliefert am 27. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    124, city road, roath, cardiff, south glamorgan. T/n :- wa 253035.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1986
    Geliefert am 27. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15, east street, bedminster, bristol t/n:- av 48213.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1986Registrierung einer Belastung

    Hat ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Sept. 2016Ende der Verwaltung
    25. März 2014Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Toby Scott Underwood
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praktiker
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Stuart David Maddison
    One Reading Central
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Praktiker
    One Reading Central
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter David Dickens
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0