KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01714140 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EDENFRET LIMITED | 12. Apr. 1983 | 12. Apr. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 3 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 3 Seiten | AA | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 11 Seiten | 288a | ||
legacy | 11 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 4 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 4 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 4 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363s | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE, Timothy Francis | Sekretär | Blackbarn House Main Street Bishampton WR10 2NH Pershore Worcestershire | British | 24075160004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Geschäftsführer | Blackbarn House Main Street Bishampton WR10 2NH Pershore Worcestershire | England | British | 24075160004 | |||||
| MILLS, Lee James | Geschäftsführer | 4 Kings Court CM23 2AA Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Sekretär | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Sekretär | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| KIRKIN, Richard William | Sekretär | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | British | 1180700001 | ||||||
| AM SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 28265670010 | |||||||
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Geschäftsführer | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| BEIRNE, Michael | Geschäftsführer | 52 Lock Road Broadheath WA14 4HD Altrincham Cheshire | British | 61171370001 | ||||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Geschäftsführer | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| FORREST, David Robert | Geschäftsführer | 42 Broad Walk SK9 5PL Wilmslow Cheshire | British | 12949720001 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Geschäftsführer | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Geschäftsführer | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| KENNEDY, Patrick James | Geschäftsführer | Mayo Brooks Drive Halebarns WA15 8TL Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 47720560001 | |||||
| PARSONS, James Christopher | Geschäftsführer | Chudleigh 34 Arthog Road Hale WA15 0LY Altrincham | British | 1180670002 | ||||||
| REID, John Watson | Geschäftsführer | The Laurels Park Gates Drive Cheadle Hulme SK8 7DF Cheadle Cheshire | England | British | 12949730002 | |||||
| AM NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 34427260007 | |||||||
| AM SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 28265670010 |
Hat KENNEDY PIPELINING SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 1997 Geliefert am 16. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities for the time being, owing or incurred by the obligors (as defined therein) to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined therein) and/or on any other account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Cash collateral security | Erstellt am 13. Aug. 1997 Geliefert am 15. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns the charged account being the account of the company with the depository (being the royal bank of scotland international limited) which account is blocked or designated as charged to the bank and the deposit being all sums at the date of the cash collateral security or thereafter standing to the credit of the charged account together with all interest and other amounts accruing on such sums (in whatever currency) together with all the rights titles and benefits of the company whatsoever present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0