BL (SP) PROPERTIES PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBL (SP) PROPERTIES PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01719789
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BL (SP) PROPERTIES PLC?

    • (7011) /

    Wo befindet sich BL (SP) PROPERTIES PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BDO STOY HAYWARD LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BL (SP) PROPERTIES PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STANHOPE PROPERTIES PLC23. Sept. 198723. Sept. 1987
    STANHOPE SECURITIES PLC09. Juni 198309. Juni 1983
    BOSTONPRESS LIMITED03. Mai 198303. Mai 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BL (SP) PROPERTIES PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für BL (SP) PROPERTIES PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    13 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2021

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2016

    5 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    12 SeitenLIQ MISC OC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Juni 2016

    5 Seiten4.68

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2016

    12 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2015

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2014

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2012

    5 Seiten4.68

    Wer sind die Geschäftsführer von BL (SP) PROPERTIES PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Sekretär
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Geschäftsführer
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Sekretär
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    British52294450003
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British166550001
    BOTTS, John Chester
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    Geschäftsführer
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    United KingdomAmerican2943960001
    CAMP, David John
    11 Walham Grove
    SW6 London
    Geschäftsführer
    11 Walham Grove
    SW6 London
    British4807190002
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Geschäftsführer
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    British52294450003
    GRIMSDYKE, Sharp Of, Lord
    Garden House
    51 Dennis Lane
    HA7 4JU Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Garden House
    51 Dennis Lane
    HA7 4JU Stanmore
    Middlesex
    British32975020001
    HONEYMAN, Stanley Holmes
    157 Old Church Street
    SW3 6EH London
    Geschäftsführer
    157 Old Church Street
    SW3 6EH London
    British2530760001
    JOHN, Robert Llewellyn
    15 Richmond Crescent
    N1 0LZ London
    Geschäftsführer
    15 Richmond Crescent
    N1 0LZ London
    United KingdomBritish2591710001
    LIPTON, Stuart Anthony, Sir
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    Geschäftsführer
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritish2068540001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Geschäftsführer
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    REICHMANN, Paul
    241 Strathallan Wood
    Boulevard
    FOREIGN Toronto
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    241 Strathallan Wood
    Boulevard
    FOREIGN Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian20356770001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    Flat 1
    173 Sutherland Avenue
    W9 1ET London
    Geschäftsführer
    Flat 1
    173 Sutherland Avenue
    W9 1ET London
    British35758050001
    ROGERS, Peter William
    10 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    Geschäftsführer
    10 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    EnglandBritish118055820001
    WANG, Vincent Antonio
    15 St Johns Wood Terrace
    NW8 6JJ London
    Geschäftsführer
    15 St Johns Wood Terrace
    NW8 6JJ London
    British8994770001

    Hat BL (SP) PROPERTIES PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 06. Jan. 1993
    Geliefert am 19. Jan. 1993
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the beneficiaries) and to the beneficiaries (as defined) or any of them under or pursuant to any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    See form 395 M8 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 05. Jan. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    A memorandum of deposit of loan stock
    Erstellt am 20. Juli 1992
    Geliefert am 31. Juli 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from stanhope kajima PLC to kajima europe B.V. under any of the finance documents as defined and the reimbursement to kajima europe B.V. of all other sums for the reimbursement of which the agreement is expressed to be a security by clause 8.3 of the agreement
    Kurze Angaben
    All of the chargors right's title and interest in and to the loan stock and all documents evidencing the chargor's title thereto including all monies paid or payable in respect of the loan stock.
    Berechtigte Personen
    • Kajima Europe B.V.
    Transaktionen
    • 31. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Coordination deed
    Erstellt am 13. Juli 1989
    Geliefert am 17. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and on behalf of the banks (as defined) under the terms of the finance documents or under any variations however fundamental
    Kurze Angaben
    Any payment, distribution or security or the benefit or proceeds thereof received by the second mortgagee upon or with respect to all present & future obligations (please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Sumitomo Bank Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 17. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 13. Juli 1989
    Geliefert am 17. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or stanhope grays inn limited to the chargee. As agent and trustee for itself and the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 6.4.89
    Kurze Angaben
    All dividends paid or payable after the date of the creation of this mortgage on all or any of the shares and all stocks, shares, securities (please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Sumitomo Bank Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 17. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 09. Nov. 1988
    Geliefert am 21. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and stanhope kajima developments limited to the sumitomo bank limited as agent and trustee for itself and the banks under the terms of a loan agreement dated 30.9.88, the debenture (as stated in the deed) and this mortgage
    Kurze Angaben
    1A, all shares of the borrower issued to or beneficially owned by the chargor. 1B. all dividends paid or payable after the date of the creation of this mortgage on all or any of the shares and all stocks, shares, securities. (Please see doc M395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Kyowa Bank LTD
    • Kleinwort Benson Limited
    • The Mitsui Bank Limitedand Their Successors and Assigns
    • The Sumitomo Bank Limitedas Agent & Trustee for Itself
    • The Bank of Tokyo
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of charge
    Erstellt am 12. Aug. 1987
    Geliefert am 26. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    Shares in the capital of rosehaugh stanhope developments (holdings) PLC (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • Kleinwort Benson Limited
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    Memorandum of charge
    Erstellt am 21. Nov. 1986
    Geliefert am 05. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 6/11/86.
    Kurze Angaben
    Shares in the capital of rosehaugh stanhope developments PLC (see form 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Kleinwort Benson Limited.
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Apr. 1985
    Geliefert am 03. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (1) a fixed charge over the company's holding of shares in rosehaugh stanhope developments PLC ("rsd") and of loan stock of rsd and of all indebtedness from time to time owing to the company by rsd (ii) a floating charge over all the undertaking and all other property and assets of the company both present and future (see M23 for further details).
    Berechtigte Personen
    • Globe Investment Trust P.L.C.
    • Kleinwort Benson Investment Management Limited.
    • Robert Fleming & Co, LTD.
    Transaktionen
    • 03. Mai 1985Registrierung einer Belastung

    Hat BL (SP) PROPERTIES PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Feb. 1999Beginn der Liquidation
    16. Sept. 2021Soll aufgelöst werden am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Harry Gilbert
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praktiker
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Anthony Peter Supperstone
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praktiker
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0