BL (SP) PROPERTIES PLC
Überblick
| Unternehmensname | BL (SP) PROPERTIES PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 01719789 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BL (SP) PROPERTIES PLC?
- (7011) /
Wo befindet sich BL (SP) PROPERTIES PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o BDO STOY HAYWARD LLP 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BL (SP) PROPERTIES PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| STANHOPE PROPERTIES PLC | 23. Sept. 1987 | 23. Sept. 1987 |
| STANHOPE SECURITIES PLC | 09. Juni 1983 | 09. Juni 1983 |
| BOSTONPRESS LIMITED | 03. Mai 1983 | 03. Mai 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BL (SP) PROPERTIES PLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | |
Welche sind die letzten Einreichungen für BL (SP) PROPERTIES PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | LIQ13 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2021 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2020 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2019 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2020 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2019 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2018 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2018 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2017 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2017 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2016 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq | 12 Seiten | LIQ MISC OC | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Juni 2016 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2016 | 12 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2015 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2015 | 6 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2014 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2014 | 8 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Aug. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Feb. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von BL (SP) PROPERTIES PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAINE, Anthony | Sekretär | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Geschäftsführer | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||
| WAGMAN, Colin Barry | Geschäftsführer | North Lodge 25 Ringwood Avenue N2 9NT London | United Kingdom | British | 39329840001 | |||||
| DANTZIC, Roy Matthew | Sekretär | 65 Springfield Road St Johns Wood NW8 0QJ London | British | 52294450003 | ||||||
| BERRY, David Charles | Geschäftsführer | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 166550001 | ||||||
| BOTTS, John Chester | Geschäftsführer | 21 Argyll Road W8 7DA London | United Kingdom | American | 2943960001 | |||||
| CAMP, David John | Geschäftsführer | 11 Walham Grove SW6 London | British | 4807190002 | ||||||
| DANTZIC, Roy Matthew | Geschäftsführer | 65 Springfield Road St Johns Wood NW8 0QJ London | British | 52294450003 | ||||||
| GRIMSDYKE, Sharp Of, Lord | Geschäftsführer | Garden House 51 Dennis Lane HA7 4JU Stanmore Middlesex | British | 32975020001 | ||||||
| HONEYMAN, Stanley Holmes | Geschäftsführer | 157 Old Church Street SW3 6EH London | British | 2530760001 | ||||||
| JOHN, Robert Llewellyn | Geschäftsführer | 15 Richmond Crescent N1 0LZ London | United Kingdom | British | 2591710001 | |||||
| LIPTON, Stuart Anthony, Sir | Geschäftsführer | 40 Queens Grove NW8 6HH London | England | British | 2068540001 | |||||
| METLISS, Cyril | Geschäftsführer | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||
| REICHMANN, Paul | Geschäftsführer | 241 Strathallan Wood Boulevard FOREIGN Toronto Ontario Canada | Canadian | 20356770001 | ||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Geschäftsführer | Flat 1 173 Sutherland Avenue W9 1ET London | British | 35758050001 | ||||||
| ROGERS, Peter William | Geschäftsführer | 10 Marryat Road Wimbledon SW19 5BD London | England | British | 118055820001 | |||||
| WANG, Vincent Antonio | Geschäftsführer | 15 St Johns Wood Terrace NW8 6JJ London | British | 8994770001 |
Hat BL (SP) PROPERTIES PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 06. Jan. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1993 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the beneficiaries) and to the beneficiaries (as defined) or any of them under or pursuant to any of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben See form 395 M8 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A memorandum of deposit of loan stock | Erstellt am 20. Juli 1992 Geliefert am 31. Juli 1992 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from stanhope kajima PLC to kajima europe B.V. under any of the finance documents as defined and the reimbursement to kajima europe B.V. of all other sums for the reimbursement of which the agreement is expressed to be a security by clause 8.3 of the agreement | |
Kurze Angaben All of the chargors right's title and interest in and to the loan stock and all documents evidencing the chargor's title thereto including all monies paid or payable in respect of the loan stock. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Coordination deed | Erstellt am 13. Juli 1989 Geliefert am 17. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and on behalf of the banks (as defined) under the terms of the finance documents or under any variations however fundamental | |
Kurze Angaben Any payment, distribution or security or the benefit or proceeds thereof received by the second mortgagee upon or with respect to all present & future obligations (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 13. Juli 1989 Geliefert am 17. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or stanhope grays inn limited to the chargee. As agent and trustee for itself and the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 6.4.89 | |
Kurze Angaben All dividends paid or payable after the date of the creation of this mortgage on all or any of the shares and all stocks, shares, securities (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 09. Nov. 1988 Geliefert am 21. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and stanhope kajima developments limited to the sumitomo bank limited as agent and trustee for itself and the banks under the terms of a loan agreement dated 30.9.88, the debenture (as stated in the deed) and this mortgage | |
Kurze Angaben 1A, all shares of the borrower issued to or beneficially owned by the chargor. 1B. all dividends paid or payable after the date of the creation of this mortgage on all or any of the shares and all stocks, shares, securities. (Please see doc M395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of charge | Erstellt am 12. Aug. 1987 Geliefert am 26. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Kurze Angaben Shares in the capital of rosehaugh stanhope developments (holdings) PLC (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of charge | Erstellt am 21. Nov. 1986 Geliefert am 05. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 6/11/86. | |
Kurze Angaben Shares in the capital of rosehaugh stanhope developments PLC (see form 395 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Apr. 1985 Geliefert am 03. Mai 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (1) a fixed charge over the company's holding of shares in rosehaugh stanhope developments PLC ("rsd") and of loan stock of rsd and of all indebtedness from time to time owing to the company by rsd (ii) a floating charge over all the undertaking and all other property and assets of the company both present and future (see M23 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BL (SP) PROPERTIES PLC Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0