BEESON GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BEESON GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01721453 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BEESON GROUP LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich BEESON GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Glenthorn Farm Whittlesey Road PE15 0AW March Cambridgeshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BEESON GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CAVECRAFT LIMITED | 09. Mai 1983 | 09. Mai 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BEESON GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BEESON GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Konten eines kleinen Unternehmens mit voller Befreiung erstellt bis 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AAMD | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 395 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 10 Seiten | 155(6)a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 |
Wer sind die Geschäftsführer von BEESON GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERSLUIS, Klaus Christian | Sekretär | Brooklands Lane Menston LS29 6PL Ilkley 19 West Yorkshire | Dutch | 104302950001 | ||||||
BASCETTA, Emanuele | Geschäftsführer | Abbanoy House 52 Kibbleston Road PA10 2PW Kilbarchan Renfrewshire | United Kingdom | British | Managing Director | 102843530001 | ||||
BEVERSLUIS, Klaus Christian | Geschäftsführer | Brooklands Lane Menston LS29 6PL Ilkley 19 West Yorkshire | United Kingdom | Dutch | Director | 104302950001 | ||||
BEESON, Robert John | Sekretär | The Old Rectory Saxlingham NR25 7JZ Holt Norfolk | British | Chairman/Director | 29846960001 | |||||
CAMPBELL, Rosalind Ilona | Sekretär | 6 Hawthorn Close WD17 4SB Watford Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 58191970001 | |||||
COMPSON, Christopher John | Sekretär | Old Mill Farmhouse Tuddenham IP28 6SQ Bury St Edmunds Suffolk | British | Chartered Accountant | 72803320001 | |||||
HILLS, David Edward | Sekretär | Lantern Barn Sharrington NR24 2BU Melton Constable Norfolk | British | 10816830001 | ||||||
HINES, Christine Anne | Sekretär | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
MUSK, Michael John | Sekretär | Torwood Limbourne Lane Fittleworth RH20 1HR Pulborough West Sussex | British | Finance Director | 42341410001 | |||||
ROSEN, Andrew Scott | Sekretär | 301 West 53rd Street New York Ny 10019 United States | American | Director | 64268220001 | |||||
BEESON, Robert John | Geschäftsführer | The Old Rectory Saxlingham NR25 7JZ Holt Norfolk | British | Chairman | 29846960001 | |||||
BOLTON, Stephen Thomas | Geschäftsführer | 63 Bottrells Lane HP8 4EJ Chalfont St. Giles Buckinghamshire | Irish | Commercial Director | 83366100002 | |||||
CAMPBELL, Rosalind Ilona | Geschäftsführer | 6 Hawthorn Close WD17 4SB Watford Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 58191970001 | |||||
COMPSON, Christopher John | Geschäftsführer | Old Mill Farmhouse Tuddenham IP28 6SQ Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 72803320001 | ||||
COOKE, John Edwin | Geschäftsführer | The Old Cottage Hough Lane SK9 7JD Alderley Edge Cheshire | British | Director | 6833190001 | |||||
CRAIG, Ian Alexander | Geschäftsführer | 11 Manor View Whittlesey PE7 1TF Peterborough Cambridgeshire | England | British | Company Director | 57329350002 | ||||
GOULD, John Dudley Ernest | Geschäftsführer | 6 New Street CT14 6JY Deal Kent | British | Director | 13790770002 | |||||
HILLS, David Edward | Geschäftsführer | Lantern Barn Sharrington NR24 2BU Melton Constable Norfolk | British | Financial Director | 10816830001 | |||||
HOLLYWOOD, James Bunce | Geschäftsführer | 7 Maryfield Road Broughty Ferry DD5 2JJ Dundee Angus | British | Director | 15697450002 | |||||
LEACH, Paul Alan | Geschäftsführer | 58 Donnington Road CV36 4BG Shipston On Stour Warwickshire | British | Treasurer | 60788330002 | |||||
LEACH, Paul Alan | Geschäftsführer | 20 Malvern Road SL6 7RH Maidenhead Berkshire | British | Treasurer | 60788330001 | |||||
MUSK, Michael John | Geschäftsführer | Torwood Limbourne Lane Fittleworth RH20 1HR Pulborough West Sussex | British | Finance Director | 42341410001 | |||||
OLINS, Laurence Stephen | Geschäftsführer | 32 Hendon Avenue Finchley N3 1UE London | British | Director | 4716420001 | |||||
ROSEN, Andrew Scott | Geschäftsführer | 301 West 53rd Street New York Ny 10019 United States | American | Director | 64268220001 | |||||
SIMPSON, Andrew John | Geschäftsführer | Pine Tree Barns Harts Lane Bawburgh NR9 3LT Norwich Norfolk | England | British | Director | 105165150001 |
Hat BEESON GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Standard security which was presented for registration in scotland on 27 september 2007 and dated 15 august 2007 and | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 06. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and abbanoy to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 0.806 hectare lying to the east of the A932 dundee to forfar road part of the farm and lands of west craig in forfar. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 11TH april 2007 and | Erstellt am 30. März 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Office premises, west craig, dundee road, forfar, angus. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 30. März 2007 Geliefert am 13. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and abbanoy to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Over all and whole of the security subjects that plot or area of ground lying gernerally to the east of the A932 dundee to forfar road part of the farm and lands of west craig in the parish of forfar and county of angus. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. März 2007 Geliefert am 07. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. März 2007 Geliefert am 05. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Hangar no 2 litle snoring airfield little snoring t/no NK167966. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. März 2007 Geliefert am 07. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H no 2 hangar old airfield thursford road little snoring fakenham norfolk t/n NK167966. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Group debenture | Erstellt am 26. Nov. 2003 Geliefert am 15. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Aug. 1999 Geliefert am 26. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 28. Sept. 1983 Geliefert am 04. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0