BEESON GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBEESON GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01721453
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BEESON GROUP LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich BEESON GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Glenthorn Farm
    Whittlesey Road
    PE15 0AW March
    Cambridgeshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BEESON GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CAVECRAFT LIMITED09. Mai 198309. Mai 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BEESON GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für BEESON GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Geänderte Konten eines kleinen Unternehmens mit voller Befreiung erstellt bis 31. Dez. 2008

    5 SeitenAAMD

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    5 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Docs approved 30/03/07
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07

    legacy

    10 Seiten155(6)a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    11 Seiten395

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von BEESON GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BEVERSLUIS, Klaus Christian
    Brooklands Lane
    Menston
    LS29 6PL Ilkley
    19
    West Yorkshire
    Sekretär
    Brooklands Lane
    Menston
    LS29 6PL Ilkley
    19
    West Yorkshire
    Dutch104302950001
    BASCETTA, Emanuele
    Abbanoy House
    52 Kibbleston Road
    PA10 2PW Kilbarchan
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    Abbanoy House
    52 Kibbleston Road
    PA10 2PW Kilbarchan
    Renfrewshire
    United KingdomBritishManaging Director102843530001
    BEVERSLUIS, Klaus Christian
    Brooklands Lane
    Menston
    LS29 6PL Ilkley
    19
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Brooklands Lane
    Menston
    LS29 6PL Ilkley
    19
    West Yorkshire
    United KingdomDutchDirector104302950001
    BEESON, Robert John
    The Old Rectory
    Saxlingham
    NR25 7JZ Holt
    Norfolk
    Sekretär
    The Old Rectory
    Saxlingham
    NR25 7JZ Holt
    Norfolk
    BritishChairman/Director29846960001
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant58191970001
    COMPSON, Christopher John
    Old Mill Farmhouse Tuddenham
    IP28 6SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Sekretär
    Old Mill Farmhouse Tuddenham
    IP28 6SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishChartered Accountant72803320001
    HILLS, David Edward
    Lantern Barn
    Sharrington
    NR24 2BU Melton Constable
    Norfolk
    Sekretär
    Lantern Barn
    Sharrington
    NR24 2BU Melton Constable
    Norfolk
    British10816830001
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Sekretär
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MUSK, Michael John
    Torwood Limbourne Lane
    Fittleworth
    RH20 1HR Pulborough
    West Sussex
    Sekretär
    Torwood Limbourne Lane
    Fittleworth
    RH20 1HR Pulborough
    West Sussex
    BritishFinance Director42341410001
    ROSEN, Andrew Scott
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    Sekretär
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    AmericanDirector64268220001
    BEESON, Robert John
    The Old Rectory
    Saxlingham
    NR25 7JZ Holt
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Saxlingham
    NR25 7JZ Holt
    Norfolk
    BritishChairman29846960001
    BOLTON, Stephen Thomas
    63 Bottrells Lane
    HP8 4EJ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    63 Bottrells Lane
    HP8 4EJ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    IrishCommercial Director83366100002
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant58191970001
    COMPSON, Christopher John
    Old Mill Farmhouse Tuddenham
    IP28 6SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Old Mill Farmhouse Tuddenham
    IP28 6SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritishChartered Accountant72803320001
    COOKE, John Edwin
    The Old Cottage
    Hough Lane
    SK9 7JD Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Old Cottage
    Hough Lane
    SK9 7JD Alderley Edge
    Cheshire
    BritishDirector6833190001
    CRAIG, Ian Alexander
    11 Manor View
    Whittlesey
    PE7 1TF Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    11 Manor View
    Whittlesey
    PE7 1TF Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director57329350002
    GOULD, John Dudley Ernest
    6 New Street
    CT14 6JY Deal
    Kent
    Geschäftsführer
    6 New Street
    CT14 6JY Deal
    Kent
    BritishDirector13790770002
    HILLS, David Edward
    Lantern Barn
    Sharrington
    NR24 2BU Melton Constable
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Lantern Barn
    Sharrington
    NR24 2BU Melton Constable
    Norfolk
    BritishFinancial Director10816830001
    HOLLYWOOD, James Bunce
    7 Maryfield Road
    Broughty Ferry
    DD5 2JJ Dundee
    Angus
    Geschäftsführer
    7 Maryfield Road
    Broughty Ferry
    DD5 2JJ Dundee
    Angus
    BritishDirector15697450002
    LEACH, Paul Alan
    58 Donnington Road
    CV36 4BG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    58 Donnington Road
    CV36 4BG Shipston On Stour
    Warwickshire
    BritishTreasurer60788330002
    LEACH, Paul Alan
    20 Malvern Road
    SL6 7RH Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    20 Malvern Road
    SL6 7RH Maidenhead
    Berkshire
    BritishTreasurer60788330001
    MUSK, Michael John
    Torwood Limbourne Lane
    Fittleworth
    RH20 1HR Pulborough
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Torwood Limbourne Lane
    Fittleworth
    RH20 1HR Pulborough
    West Sussex
    BritishFinance Director42341410001
    OLINS, Laurence Stephen
    32 Hendon Avenue
    Finchley
    N3 1UE London
    Geschäftsführer
    32 Hendon Avenue
    Finchley
    N3 1UE London
    BritishDirector4716420001
    ROSEN, Andrew Scott
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    Geschäftsführer
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    AmericanDirector64268220001
    SIMPSON, Andrew John
    Pine Tree Barns Harts Lane
    Bawburgh
    NR9 3LT Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Pine Tree Barns Harts Lane
    Bawburgh
    NR9 3LT Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishDirector105165150001

    Hat BEESON GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Standard security which was presented for registration in scotland on 27 september 2007 and dated 15 august 2007 and
    Erstellt am 19. Sept. 2007
    Geliefert am 06. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and abbanoy to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    0.806 hectare lying to the east of the A932 dundee to forfar road part of the farm and lands of west craig in forfar. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Premier Financing Limited
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 11TH april 2007 and
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 17. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Office premises, west craig, dundee road, forfar, angus.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 13. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and abbanoy to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Over all and whole of the security subjects that plot or area of ground lying gernerally to the east of the A932 dundee to forfar road part of the farm and lands of west craig in the parish of forfar and county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Premier Financing Limited
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 07. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Premier Financing Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 05. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hangar no 2 litle snoring airfield little snoring t/no NK167966.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 07. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H no 2 hangar old airfield thursford road little snoring fakenham norfolk t/n NK167966. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Premier Financing Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Group debenture
    Erstellt am 26. Nov. 2003
    Geliefert am 15. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 10. Aug. 1999
    Geliefert am 26. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuantto the Facilities Agreement
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 28. Sept. 1983
    Geliefert am 04. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    • 31. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0