FORECOURT PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FORECOURT PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01723832 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FORECOURT PROPERTIES LIMITED?
- (7020) /
Wo befindet sich FORECOURT PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FORECOURT PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JADEFUN LIMITED | 17. Mai 1983 | 17. Mai 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FORECOURT PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FORECOURT PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2011 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2010 bis 30. März 2010 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 22. Juni 2010 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 8 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FORECOURT PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870006 | ||||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | 57/63 Line Wall Road Gibraltar Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135316290001 | ||||||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Sekretär | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||||||
| HOLLAND, Philip John | Sekretär | 9 Royle Close Chalfont St. Peter SL9 0BA Buckinghamshire | British | 74688330002 | ||||||||||
| ROBERTS, Geoffrey Michael | Sekretär | Brenchley 8 Hamilton Road DA15 7HB Sidcup Kent | British | 29217560001 | ||||||||||
| WHITE, Christine | Sekretär | 31 Denmark Street WD17 4YA Watford Hertfordshire | British | 74900200002 | ||||||||||
| BLOOMFIELD, David William | Geschäftsführer | Hillcroft The Drive Harefield Place UB10 8AQ Ickenham Middlesex | British | 7927670001 | ||||||||||
| CLEGG, Barry Stuart | Geschäftsführer | The Gate House 18a Ducks Hill Road HA6 2NR Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11296610002 | |||||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||||||
| DOSSETT, Roger John | Geschäftsführer | Charlecote Harewood Road HP8 4UA Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 116927100001 | |||||||||
| HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | 61 Badgers Gate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | England | British | 163838050001 | |||||||||
| MALONE, Kenneth Daniel | Geschäftsführer | One Tree Cottage 18 Woodside Avenue HP9 1JJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 60687110001 | ||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat FORECOURT PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 15. Sept. 2004 Geliefert am 29. Sept. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Jan. 2000 Geliefert am 31. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land k/a brimrod high street chalfont st peter and land k/a the grange garage high street chalfont st peter t/nos.BM171862 and BM2130. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Jan. 2000 Geliefert am 20. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land k/a brimrod high street chalfont st peter and land k/a the grange garage high street chalfont st peter t/nos: BM171862 and BM2130. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 18. Okt. 1999 Geliefert am 23. Okt. 1999 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1992 Geliefert am 19. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as "security trustee" for itself and the secured parties (all as defined therein ) and to the secured parties on any account whatsoever under the terms of this deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Feb. 1992 Geliefert am 24. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the 02 goodwill book and other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Dez. 1988 Geliefert am 06. Dez. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 197 high street uxbridge middlesex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Jan. 1986 Geliefert am 20. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property k/a 6 chippendale waye, uxbridge, london borough of hillingdon. T/n: ngl 443478. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 1985 Geliefert am 03. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 7 chippendale waye uxbridge middlesex t/n:- ngl 360288. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. März 1985 Geliefert am 26. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H propety k/a 8 chippendale waye uxbridge middlesex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. März 1984 Geliefert am 13. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 214-218 high street uxbridge. 4-13 the square, uxbridge and land at the rear tog. With the land edged red on the plan annexed to a transfer dated 9/3/84. title nos:- ngl 229008, mx 79874, mx 95436, mx 223252, mx 113581, mx 270848, mx 108001. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 1983 Geliefert am 23. Dez. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H - 207-211 high street uxbridge L.B. of hillingdon inc. Land at the rear thereof. Title nos:- mx 428528 mx 474398 mx 153714 ngl 118243. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0