PREMIER HAZARD LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PREMIER HAZARD LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01725643 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PREMIER HAZARD LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PREMIER HAZARD LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 1 Green Park Coal Road LS14 1FB Leeds United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PREMIER HAZARD LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PREMIER HAZARD LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 017256430008 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Juni 2020 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Juni 2019 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Juni 2018 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Britax Bessingby Industrial Estate Bridlington North Humberside YO16 4SJ zum Unit 1 Green Park Coal Road Leeds LS14 1FB am 04. Apr. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 31. März 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Miss Gayle Broadhurst als Sekretär am 09. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Mazzei als Sekretär am 09. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Edward Marshall als Geschäftsführer am 01. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Keith Hoult als Geschäftsführer am 08. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 017256430008, erstellt am 24. Feb. 2015 | 7 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PREMIER HAZARD LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROADHURST, Gayle | Sekretär | Heath Court Warmsworth DN4 9GE Doncaster 15 South Yorkshire England | 211894240001 | |||||||||||
CAMPBELL, Robert | Geschäftsführer | Green Park Coal Road LS14 1FB Leeds Unit 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 115389730001 | ||||||||
MAZZEI, Thomas | Geschäftsführer | Green Park Coal Road LS14 1FB Leeds Unit 1 United Kingdom | United States | American | Cfo | 186558330001 | ||||||||
FAWELL, Richard | Sekretär | 5 Barfield Avenue Yeadon LS19 7SH Leeds West Yorkshire | British | 33091410001 | ||||||||||
HAGGIS, Robert Arthur | Sekretär | 16 Moorfield Business Park Yeadon LS19 7YA Leeds Lancaster House West Yorkshire England | 162599720001 | |||||||||||
LEAVESLEY, Annette Susan | Sekretär | 16 Moorfield Business Park Yeadon LS19 7YA Leeds Lancaster House West Yorkshire England | 164762220001 | |||||||||||
MAZZEI, Thomas | Sekretär | Bessingby Industrial Estate YO16 4SJ Bridlington Britax North Humberside England | 186562620001 | |||||||||||
TENNANT, Edith | Sekretär | 19 Mavis Avenue Cookridge LS16 7LJ Leeds West Yorkshire | British | 13675930001 | ||||||||||
PUBLIC SAFETY HOLDINGS LIMITED | Sekretär | Moorfield Business Park Yeadon LS19 7YA Leeds 16 Lancaster House West Yorkshire United Kingdom |
| 121469110002 | ||||||||||
SETON HOUSE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Seton House Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DE Warwick | 109290007 | |||||||||||
BALLARD, Peter Edwin | Geschäftsführer | 5 Wyncroft Grove Bramhope LS16 9DG Leeds | United Kingdom | British | Director | 58170440002 | ||||||||
BROGAN, Bernard Desmond | Geschäftsführer | Blakeley Lodge Egginton Road Etwall DE65 6NQ Derby Derbyshire | England | British | Chartered Engineer | 70252730001 | ||||||||
BROWN, Roy Frederick | Geschäftsführer | Westmorland House Westmorland Road SL6 4HB Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 41549370002 | ||||||||
CLEMIE, John Paul | Geschäftsführer | Firs Hill Court Pool In Wharfedale LS21 1EX Otley West Yorkshire | United Kingdom | British | Paper Distributor | 77765840001 | ||||||||
DUFFIELD, Stephen Leslie | Geschäftsführer | Jacknett Barn 1820 Warwick Road Knowle B93 0DX Solihull West Midlands | England | British | Company Director | 24487000002 | ||||||||
ELLSMORE, Mark Anthony | Geschäftsführer | Moor Cottage Eversley Centre RG27 0NB Hook | British | Finance Director | 58979090001 | |||||||||
FAWELL, Richard | Geschäftsführer | Rowan Tree Cottage 30 Batter Lane Rawdon LS19 6EJ Leeds | British | Director | 33091410003 | |||||||||
HENSHALL, Leonard Ernest | Geschäftsführer | 120 West Crayke Wharfdale Drive YO16 6XW Bridlington East Yorkshire | England | British | Director | 73864930001 | ||||||||
HOULT, David Keith | Geschäftsführer | Bessingby Industrial Estate YO16 4SJ Bridlington Britax North Humberside England | England | British | Finance Director | 170336000001 | ||||||||
JONES, Evan Taylor | Geschäftsführer | Ash Lea Barbon LA6 2LW Kirby Lonsdale Cumbria | British | Director | 40267750001 | |||||||||
MARSHALL, Christopher Edward | Geschäftsführer | Bessingby Industrial Estate YO16 4SJ Bridlington Britax North Humberside England | Usa | British | President & Chief Executive Officer | 95001410002 | ||||||||
MARTON, Richard Egerton Christopher | Geschäftsführer | Capernwray 6 Kier Park SL5 7DS Ascot Berkshire | British | Director | 34653220001 | |||||||||
MILLINGTON, Anthony Geoffrey | Geschäftsführer | 16 Moorfield Business Park Yeadon LS19 7YA Leeds Lancaster House West Yorkshire England | England | British | Accountant | 47299970005 | ||||||||
MILNER, Andrew Rex | Geschäftsführer | 16 Moorfield Business Park Yeadon LS19 7YA Leeds Lancaster House West Yorkshire England | England | British | Director | 49695760003 | ||||||||
NOON, Rodney Ernest | Geschäftsführer | 191 Martongate YO15 1DP Bridlington East Yorkshire | England | British | Managing Director | 15300520002 | ||||||||
RAYNER, Michael | Geschäftsführer | 4 Walton Croft B91 3GW Solihull West Midlands | England | British | Company Director | 42404830002 | ||||||||
ROBERTSON, Douglas Grant | Geschäftsführer | Blackmore Grange Blackmore End WR8 0EE Hanley Swan Worcestershire | England | British | Chartered Accountant | 123487130001 | ||||||||
ROONEY, Malcolm | Geschäftsführer | 17 Illingworth Drive Bradshaw HX2 9RR Halifax West Yorkshire | British | Director | 57598620001 | |||||||||
SMITH, David Colin | Geschäftsführer | 7 Southend Avenue DL3 7HL Darlington County Durham | United Kingdom | British | Managing Director | 81477940002 | ||||||||
STABLER, Richard | Geschäftsführer | The Beechwood YO25 5NS Driffield 6 East Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 135393290001 | ||||||||
TENNANT, Bryn James | Geschäftsführer | Caley Hall Pool In Wharfedale LS21 1EE Otley West Yorkshire | England | British | Director | 51532040002 | ||||||||
TENNANT, Bryn James | Geschäftsführer | Caley Hall Pool In Wharfedale LS21 1EE Otley West Yorkshire | England | British | Emergency Vehicle Equipment | 51532040002 | ||||||||
TENNANT, Edith | Geschäftsführer | 19 Mavis Avenue Cookridge LS16 7LJ Leeds West Yorkshire | British | Secretary | 13675930001 | |||||||||
THORNE, Raymond | Geschäftsführer | 60 Silhill Hall Road B91 1JS Solihull West Midlands | British | Chartered Accountant | 2756010001 | |||||||||
WELSBY, Glyn Mikal | Geschäftsführer | The Garth Westfield Court, Copmanthorpe YO23 3TA York | England | British | Accountant | 110146300002 |
Hat PREMIER HAZARD LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 24. Feb. 2015 Geliefert am 03. März 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances by a chargor for third party liabilities | Erstellt am 21. Mai 2010 Geliefert am 28. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits accrued thereon being all sums of money in any currency together with all interest from time to time accuring thereon see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Mai 2010 Geliefert am 28. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, trade and other debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Accession deed to a debenture | Erstellt am 03. Apr. 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Dez. 2005 Geliefert am 06. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security accession deed between the company,seton house group limited (the "parent") and lehman commercial paper inc (the "security agent") supplemental to a debenture dated 4 july 2001 | Erstellt am 23. Aug. 2001 Geliefert am 31. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) to any secured party (as defined) under any finance document (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 26. Nov. 1992 Geliefert am 02. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 18. Juli 1984 Geliefert am 23. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & all other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat PREMIER HAZARD LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0