JHP GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | JHP GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01729661 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JHP GROUP LIMITED?
- Sonstige Bildung n.n.g. (85590) / Erziehung
Wo befindet sich JHP GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 32 Eyre Street First Floor S1 4QZ Sheffield South Yorkshire England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JHP GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
JHP TRAINING LIMITED | 01. Aug. 1983 | 01. Aug. 1983 |
HUGH PITMAN TRAINING LIMITED | 05. Juli 1983 | 05. Juli 1983 |
MIGHTYWORLD LIMITED | 07. Juni 1983 | 07. Juni 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JHP GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JHP GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Notification of Dimensions Training Topco Limited as a person with significant control on 27. Jan. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Wayne Janse Van Rensburg as a person with significant control on 27. Jan. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 9a Wainsford Road Pennington Lymington Hampshire SO41 8GD zum 32 Eyre Street First Floor Sheffield South Yorkshire S1 4QZ am 07. März 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 32 Eyre Street First Floor Sheffield South Yorkshire S1 4QZ England zum 9a Wainsford Road Pennington Lymington Hampshire SO41 8GD am 24. Feb. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung von Mr Andrew Niedzwiecki als Direktor am 27. Jan. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Wayne Janse Van Rensburg als Geschäftsführer am 27. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mrs Pamela Mary Rae-Welsh als Direktor am 27. Jan. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 27. Apr. 2021 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Dearing House 1 Young Street Sheffield S1 4UP zum 32 Eyre Street First Floor Sheffield South Yorkshire S1 4QZ am 10. Aug. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 27. Apr. 2020 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Sept. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 27. Apr. 2019 | 6 Seiten | AA | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Apr. 2019 bis 27. Apr. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Apr. 2018 | 6 Seiten | AA | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Apr. 2018 bis 28. Apr. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2018 bis 29. Apr. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of Wayne Janse Van Rensburg as a person with significant control on 23. Juni 2018 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Cessation of Learndirect Limited as a person with significant control on 23. Juni 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von JHP GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIEDZWIECKI, Andrew | Geschäftsführer | Wainsford Road Pennington SO41 8GD Lymington 9a Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 205992720001 | ||||
RAE-WELSH, Pamela Mary | Geschäftsführer | Wainsford Road Pennington SO41 8GD Lymington 9a Hampshire United Kingdom | England | British | Director | 215888510001 | ||||
ANDERSON, Margaret | Sekretär | 5 College Green Wanborough SN4 0AZ Swindon Wiltshire | British | 11878420001 | ||||||
HARRIS, Ralph William | Sekretär | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry 3 Riverstone Court West Midlands | British | 148241090001 | ||||||
KORAL, Greg | Sekretär | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry 3 Riverstone Court West Midlands | 163187500001 | |||||||
PITMAN, Helen Ruth | Sekretär | Foxley House SN16 0JJ Malmesbury Wiltshire | British | 73397610001 | ||||||
WARD, Lesley Ruth | Sekretär | 1 Young Street S1 4UP Sheffield Dearing House United Kingdom | British | 175718850001 | ||||||
CHAMBERS, James Robert | Geschäftsführer | The Old Vicarage Hackney Lane Barlow S18 7TR Dronfield Derbyshire | England | British | Chief Executive Officer | 121875910001 | ||||
CHARTERIS, William John | Geschäftsführer | 2 Summers Close The Hollies LE9 7QP Kirkby Mallory Leicestershire | British | Managing Director | 55185140001 | |||||
DEAVILLE, John Paul | Geschäftsführer | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry 3 Riverstone Court West Midlands | England | British | Company Director | 99794540001 | ||||
GREENHALGH, Tracie Rose | Geschäftsführer | 1 Young Street S1 4UP Sheffield Dearing House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 148240990001 | ||||
HARRIS, Ralph William | Geschäftsführer | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry 3 Riverstone Court West Midlands | England | British | Company Director | 174533780002 | ||||
HENDERSON-MORROW, Kristian | Geschäftsführer | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry 3 Riverstone Court West Midlands | England | British | Company Director | 148241030001 | ||||
HILLS, Kenneth Cumming | Geschäftsführer | 1 Young Street S1 4UP Sheffield Dearing House | United Kingdom | British | Company Director | 159009950001 | ||||
JANSE VAN RENSBURG, Wayne | Geschäftsführer | Eyre Street First Floor S1 4QZ Sheffield 32 South Yorkshire England | England | British | Director | 152557640001 | ||||
JONES, Sarah Elizabeth | Geschäftsführer | 1 Young Street S1 4UP Sheffield Dearing House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 103575870002 | ||||
KORAL, Gregory David | Geschäftsführer | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry 3 Riverstone Court West Midlands | England | British | Director | 108145070001 | ||||
LEWIS, Derek Compton | Geschäftsführer | Woodlands Farmhouse Thoby Lane Mount Nessing CM15 0SY Brentwood Essex | England | British | Company Director And Advisor | 56972220001 | ||||
PEACE, Roger Kenneth | Geschäftsführer | Mill Field CV37 8UX Pebworth Stamford House Stratford-Upon-Avon | England | British | Chartered Accountant | 41697510007 | ||||
PETERS, David Charles | Geschäftsführer | 93 Percy Road TW12 2JS Hampton Middlesex | British | Company Director | 44700870001 | |||||
PITMAN, Henry John | Geschäftsführer | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | Company Director | 55231490005 | ||||
PITMAN, Henry John | Geschäftsführer | Home Farm Bourton On The Hill GL56 9AF Moreton In Marsh Gloucestershire | British | Property Sales Negotiator | 55231490003 | |||||
PITMAN, John Hugh | Geschäftsführer | Foxley House SN16 0JJ Malmesbury Wiltshire | British | Chairman | 1262260001 | |||||
PITMAN, John Hugh | Geschäftsführer | Foxley House SN16 0JJ Malmesbury Wiltshire | British | Chairman & Chief Executive | 1262260001 | |||||
PITMAN, Rosemary Alice | Geschäftsführer | Bakers House Brokenborough SN16 0HY Malmesbury Wiltshire | British | Company Director | 20210900001 | |||||
PITMAN, Thomas Edward | Geschäftsführer | Hofland Road W14 0LN London 17 | United Kingdom | British | Company Director | 83610320002 | ||||
PITMAN, Thomas Edward | Geschäftsführer | Foxley House Foxley SN16 0JJ Malmesbury Wiltshire | United Kingdom | British | Company Director | 83610320001 | ||||
PITMAN, William Hugh | Geschäftsführer | 18 Macaulay Road SW4 0QX London | British | Fund Manager | 104764070001 | |||||
RICHARDSON, Helen Kathryn | Geschäftsführer | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry 3 Riverstone Court West Midlands | England | British | Company Director | 147736990001 | ||||
ROBERTS, Stuart Kurt | Geschäftsführer | 10 Jerrard Drive B75 7TN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Accountant | 22138140001 | ||||
SHERLOCK, Brian Foster | Geschäftsführer | Landsdowne Crescent Willes Road CV32 4PR Leamington Spa 25 Warwickshire United Kingdom | British | Company Director | 134663880002 | |||||
SWARBRICK, John Frederick | Geschäftsführer | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry 3 Riverstone Court | England | British | Company Director | 84418420005 | ||||
WILLIAMS, Stephen Fred | Geschäftsführer | 81 Links Drive B91 2DJ Solihull West Midlands England | British | Managing Director | 34195840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei JHP GROUP LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions Training Topco Limited | 27. Jan. 2022 | Wainsford Road Pennington SO41 8GD Lymington 9a Hampshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Wayne Janse Van Rensburg | 23. Juni 2018 | Eyre Street First Floor S1 4QZ Sheffield 32 South Yorkshire England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Learndirect Limited | 22. Juni 2018 | 1 Young Street S1 4UP Sheffield Dearing House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Pimco (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Young Street S1 4UP Sheffield 1 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat JHP GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 03. Dez. 2013 Geliefert am 06. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Nov. 2012 Geliefert am 04. Dez. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debentures | Erstellt am 08. Jan. 2010 Geliefert am 20. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the seurity trustee and the beneficiaries to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Jan. 2010 Geliefert am 15. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Jan. 2010 Geliefert am 15. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 23. März 2006 Geliefert am 29. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The rent deposit (initially £2,330.00). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. März 2004 Geliefert am 24. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 31. Jan. 2003 Geliefert am 06. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £2,330. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 01. Juli 1999 Geliefert am 09. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Juni 1999 Geliefert am 16. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal amounts detailed or owing under an instrument constituting floating rate secured "a" loan notes 2000 of £1 each both of even date issued by the company (as amended supplemental varied or substantial from time to time and other sums due or to become due from the company to the chargee arising out of or in connection with the act or matters referred to in clause 7 of the debenture on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Mai 1999 Geliefert am 14. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under an instrument constituting floating rate secured loan notes 2000 of £1 each both dated 26TH may 1999 and issued by the company (as amended,supplemental, varied or substantial from time to time) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Juli 1998 Geliefert am 17. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 29. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 04. Okt. 1993 Geliefert am 11. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. Sept. 1983 Geliefert am 10. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0