FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED

FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01730291
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Stretton Green Distribution Centre
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ASSEMBLY & AUTOMATION (ELECTRONICS) LIMITED15. Juli 198315. Juli 1983
    DIPLEMA THIRTY TWO LIMITED08. Juni 198308. Juni 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012

    6 SeitenAA

    Ernennung von Miss Stephanie Anne Shaw als Direktor am 10. Dez. 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Fergus Mckay als Geschäftsführer am 10. Dez. 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Miss Stephanie Anne Shaw als Sekretär am 01. Juni 2011

    1 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 08. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 186,588
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Eversecretary Limited als Sekretär am 01. Juni 2011

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES Uk am 24. Nov. 2011

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    15 SeitenAA

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    14 SeitenAA

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    14 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHAW, Stephanie Anne
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Stretton Green Distribution Centre
    Cheshire
    Sekretär
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Stretton Green Distribution Centre
    Cheshire
    165163250001
    FOSKIN, Richard
    Rocklands Union Road
    IRISH Kilmacthomas
    Waterford
    Ireland
    Geschäftsführer
    Rocklands Union Road
    IRISH Kilmacthomas
    Waterford
    Ireland
    IrelandIrish74069810001
    JOHNSON, Edmund
    83 Wyckham Place
    Wyckham Way
    IRISH Dundrum
    Dublin 16
    Ireland
    Geschäftsführer
    83 Wyckham Place
    Wyckham Way
    IRISH Dundrum
    Dublin 16
    Ireland
    IrelandIrish126453140001
    MCCAFFERTY, Robert Michael
    Keylwerthgasse 10
    FOREIGN Vienna
    A 1190
    Austria
    Geschäftsführer
    Keylwerthgasse 10
    FOREIGN Vienna
    A 1190
    Austria
    AustriaAmerican157079160001
    SHAW, Stephanie Anne
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Stretton Green Distribution Centre
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Stretton Green Distribution Centre
    Cheshire
    EnglandBritish174253770001
    BEATTS, Keith Pickwell
    34 Barnhill Drive
    Earnock
    ML3 9EZ Hamilton
    Lanarkshire
    Sekretär
    34 Barnhill Drive
    Earnock
    ML3 9EZ Hamilton
    Lanarkshire
    British52854190001
    HODSDEN, Richard
    47 Orchard Grove
    SL9 9ET Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Sekretär
    47 Orchard Grove
    SL9 9ET Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British98672820001
    JONES, Keith Wilson
    65 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF14 6LB Cardiff
    Sekretär
    65 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF14 6LB Cardiff
    British88435330001
    MAY, Geoffrey Charles
    24 Cambourne Avenue
    Whitchurch
    CF4 2AQ Cardiff
    South Glamorgan
    Sekretär
    24 Cambourne Avenue
    Whitchurch
    CF4 2AQ Cardiff
    South Glamorgan
    British10975750001
    READ, Paul
    8 Gelli Fawr Court
    Henllys
    NP44 6ET Cwmbran
    Gwent
    Sekretär
    8 Gelli Fawr Court
    Henllys
    NP44 6ET Cwmbran
    Gwent
    British43486210001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Sekretär
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Sekretär
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    EVERSECRETARY LIMITED
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Eversheds House
    Sekretär
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Eversheds House
    60471940015
    ARNOLD, William Keith
    Wayside House
    Wayloeds Lane
    NP6 6RW Shirenewton
    Gwent
    Geschäftsführer
    Wayside House
    Wayloeds Lane
    NP6 6RW Shirenewton
    Gwent
    British10975760003
    ARNOLD, William Keith
    Wayside House
    Wayloeds Lane
    NP6 6RW Shirenewton
    Gwent
    Geschäftsführer
    Wayside House
    Wayloeds Lane
    NP6 6RW Shirenewton
    Gwent
    British10975760003
    BEATTS, Keith Pickwell
    34 Barnhill Drive
    Earnock
    ML3 9EZ Hamilton
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    34 Barnhill Drive
    Earnock
    ML3 9EZ Hamilton
    Lanarkshire
    British52854190001
    CLEMENTS, Harry Anthony Frank
    20 Millwood
    Lisvane
    CF4 5TL Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    20 Millwood
    Lisvane
    CF4 5TL Cardiff
    South Glamorgan
    British22344480001
    EARLE, Michael Francis Henry
    14 Ash Tree Close
    Radyr
    CF4 8RX Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    14 Ash Tree Close
    Radyr
    CF4 8RX Cardiff
    South Glamorgan
    British58111210001
    EDGE, Christopher
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    Geschäftsführer
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    British11465390001
    FARHA, Alfred Sam
    Field Cottage Fritwell Road
    OX27 7NZ Fewcott
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Field Cottage Fritwell Road
    OX27 7NZ Fewcott
    Oxfordshire
    British113890220001
    HARTY, Bernard Peter
    Lyle House
    2a Eastbury Avenue
    HA6 3LG Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Lyle House
    2a Eastbury Avenue
    HA6 3LG Northwood
    Middlesex
    British36907310002
    HOPKINS, Gary
    11 Forest Hills Drive
    Talbot Green
    CF7 8JB Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    11 Forest Hills Drive
    Talbot Green
    CF7 8JB Pontyclun
    Mid Glamorgan
    British63534990001
    JONES, Keith Wilson
    65 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF14 6LB Cardiff
    Geschäftsführer
    65 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF14 6LB Cardiff
    WalesBritish88435330001
    KING, John William
    23 Holmbury Park
    Sunridge Avenue
    BR1 2QS Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    23 Holmbury Park
    Sunridge Avenue
    BR1 2QS Bromley
    Kent
    EnglandBritish596100001
    MAY, Geoffrey Charles
    24 Cambourne Avenue
    Whitchurch
    CF4 2AQ Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    24 Cambourne Avenue
    Whitchurch
    CF4 2AQ Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish10975750001
    MCKAY, Fergus
    58 Cloch Road
    PA19 1AU Gourock
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    58 Cloch Road
    PA19 1AU Gourock
    Renfrewshire
    United KingdomBritish117134180001
    MCKAY, Fergus Andrew
    2 Magpie Crescent
    Inverkip
    PA16 0LW Greenock
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    2 Magpie Crescent
    Inverkip
    PA16 0LW Greenock
    Renfrewshire
    British62269770001
    NILSON, Ronny Stig Kjell
    Vastra Sjogatan 4
    Kalmar
    39232 Kalmar
    Sweden
    Geschäftsführer
    Vastra Sjogatan 4
    Kalmar
    39232 Kalmar
    Sweden
    Swedish56534930001
    NILSSON, Hans Daniel
    30 East Sheen Avenue
    East Sheen
    SW14 8AS London
    Geschäftsführer
    30 East Sheen Avenue
    East Sheen
    SW14 8AS London
    EnglandSwedish55982340002
    PORTER, Humphrey
    Makartstrasse 7
    A2102 Haenbrunn
    Austria
    Geschäftsführer
    Makartstrasse 7
    A2102 Haenbrunn
    Austria
    British63137020001
    READ, Paul
    8 Gelli Fawr Court
    Henllys
    NP44 6ET Cwmbran
    Gwent
    Geschäftsführer
    8 Gelli Fawr Court
    Henllys
    NP44 6ET Cwmbran
    Gwent
    British43486210001
    ROWAN, James
    17 Powmill Road
    KA9 2NX Prestwick
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    17 Powmill Road
    KA9 2NX Prestwick
    Ayrshire
    British55159480002
    RYAN, Matthew
    Kingfisher House
    Aberthin Road
    CF7 7EJ Cowbridge
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Kingfisher House
    Aberthin Road
    CF7 7EJ Cowbridge
    South Glamorgan
    Irish50392750001
    THOMAS, Meirion Lewis
    34 Robert Street
    Glynneath
    SA11 5EG Neath
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    34 Robert Street
    Glynneath
    SA11 5EG Neath
    West Glamorgan
    British50392590001
    TOYE, Daniel
    18 Myvot Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4ND Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    18 Myvot Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4ND Glasgow
    Lanarkshire
    British104183320001

    Hat FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 11. Aug. 1998
    Geliefert am 22. Aug. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date of 8 grove park business estate white waltham county of berkshire between the company and the chargee
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the deposit of £7,750 and all related rights thereto and thereof.
    Berechtigte Personen
    • Michael Shanly Investments Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. März 1997
    Geliefert am 14. Apr. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of any loan document the credit agreements (as defined) and this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston as Agent and Trustee for the Bank Agents and the Banks (As Defined)
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. März 1997
    Geliefert am 18. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 05. Feb. 1997
    Geliefert am 13. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Flextronics international (UK) LTD us dollar deposit account no 42684555, dollar current account no 42684588 and money market deposit bid no 83615844. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge,
    Erstellt am 06. Sept. 1994
    Geliefert am 20. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at dinas isaf, taff ely, mid glamorgan,.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC,
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 06. Sept. 1994
    Geliefert am 20. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and under the account held with barclays bank PLC reference ;assembly & automation (electronics) limited higher interest business account number 90506168, together with all interest accrued or accruing thereon, please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC,
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage,
    Erstellt am 06. Sept. 1994
    Geliefert am 20. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    P.C.B. assembly machinery comprising ;2/2004 a"gen-rad" model 2271 circuit board test system, no 9953 with monitor ,keyboard, "oki" data microline printer, 1/111-1 a"gen-rad" model 2276E board test work station, no 9877 with monitor ,polar toneohm 550 ohmmeter "digital"TK550 tape streamer,"okidata" microline 192 plus printer, 1/1136/1 a " universal " model 6348 radial printed circuit board inserter, no 10793-8-41953101 , 18IN x 18IN board size ,,40 station automatic COMP0NENT feed with "hewlett packard"vecrta 5 personal computer ,monitor and keyboard, "hewlett packard " quiet jet printer. Please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC.
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge .
    Erstellt am 06. Sept. 1994
    Geliefert am 20. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to barclays bank PLC, supplemental to the terms of a guarantee and debenture dated 8TH april 1991 .
    Kurze Angaben
    Fixed charge over right title and interest of the company in or arising out of a factoring or invoice discounting deed dated 6TH september 1994 ,between kellock limited and the company and any deeds amending or replacing the same. Please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC,
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Sept. 1994
    Geliefert am 15. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Kellock Limited
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed
    Erstellt am 06. Sept. 1994
    Geliefert am 12. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal amount of the stock and all monies due or to become due from the company to the chargee under the deed
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co (Guernsey) Limited
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Apr. 1991
    Geliefert am 17. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 01. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1990
    Geliefert am 13. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at dunas isaf edmondstown mid glamorgan t/no (part) wa 165032 (part) wa 384774.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    • 01. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0