FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01730291 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Stretton Green Distribution Centre Langford Way WA4 4TQ Warrington Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ASSEMBLY & AUTOMATION (ELECTRONICS) LIMITED | 15. Juli 1983 | 15. Juli 1983 |
| DIPLEMA THIRTY TWO LIMITED | 08. Juni 1983 | 08. Juni 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Miss Stephanie Anne Shaw als Direktor am 10. Dez. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fergus Mckay als Geschäftsführer am 10. Dez. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Stephanie Anne Shaw als Sekretär am 01. Juni 2011 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eversecretary Limited als Sekretär am 01. Juni 2011 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES Uk am 24. Nov. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAW, Stephanie Anne | Sekretär | Langford Way WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Centre Cheshire | 165163250001 | |||||||
| FOSKIN, Richard | Geschäftsführer | Rocklands Union Road IRISH Kilmacthomas Waterford Ireland | Ireland | Irish | 74069810001 | |||||
| JOHNSON, Edmund | Geschäftsführer | 83 Wyckham Place Wyckham Way IRISH Dundrum Dublin 16 Ireland | Ireland | Irish | 126453140001 | |||||
| MCCAFFERTY, Robert Michael | Geschäftsführer | Keylwerthgasse 10 FOREIGN Vienna A 1190 Austria | Austria | American | 157079160001 | |||||
| SHAW, Stephanie Anne | Geschäftsführer | Langford Way WA4 4TQ Warrington Stretton Green Distribution Centre Cheshire | England | British | 174253770001 | |||||
| BEATTS, Keith Pickwell | Sekretär | 34 Barnhill Drive Earnock ML3 9EZ Hamilton Lanarkshire | British | 52854190001 | ||||||
| HODSDEN, Richard | Sekretär | 47 Orchard Grove SL9 9ET Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 98672820001 | ||||||
| JONES, Keith Wilson | Sekretär | 65 Heol Llanishen Fach Rhiwbina CF14 6LB Cardiff | British | 88435330001 | ||||||
| MAY, Geoffrey Charles | Sekretär | 24 Cambourne Avenue Whitchurch CF4 2AQ Cardiff South Glamorgan | British | 10975750001 | ||||||
| READ, Paul | Sekretär | 8 Gelli Fawr Court Henllys NP44 6ET Cwmbran Gwent | British | 43486210001 | ||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 76729800001 | |||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House | 60471940015 | |||||||
| ARNOLD, William Keith | Geschäftsführer | Wayside House Wayloeds Lane NP6 6RW Shirenewton Gwent | British | 10975760003 | ||||||
| ARNOLD, William Keith | Geschäftsführer | Wayside House Wayloeds Lane NP6 6RW Shirenewton Gwent | British | 10975760003 | ||||||
| BEATTS, Keith Pickwell | Geschäftsführer | 34 Barnhill Drive Earnock ML3 9EZ Hamilton Lanarkshire | British | 52854190001 | ||||||
| CLEMENTS, Harry Anthony Frank | Geschäftsführer | 20 Millwood Lisvane CF4 5TL Cardiff South Glamorgan | British | 22344480001 | ||||||
| EARLE, Michael Francis Henry | Geschäftsführer | 14 Ash Tree Close Radyr CF4 8RX Cardiff South Glamorgan | British | 58111210001 | ||||||
| EDGE, Christopher | Geschäftsführer | 46 Howards Lane Putney SW15 6NJ London | British | 11465390001 | ||||||
| FARHA, Alfred Sam | Geschäftsführer | Field Cottage Fritwell Road OX27 7NZ Fewcott Oxfordshire | British | 113890220001 | ||||||
| HARTY, Bernard Peter | Geschäftsführer | Lyle House 2a Eastbury Avenue HA6 3LG Northwood Middlesex | British | 36907310002 | ||||||
| HOPKINS, Gary | Geschäftsführer | 11 Forest Hills Drive Talbot Green CF7 8JB Pontyclun Mid Glamorgan | British | 63534990001 | ||||||
| JONES, Keith Wilson | Geschäftsführer | 65 Heol Llanishen Fach Rhiwbina CF14 6LB Cardiff | Wales | British | 88435330001 | |||||
| KING, John William | Geschäftsführer | 23 Holmbury Park Sunridge Avenue BR1 2QS Bromley Kent | England | British | 596100001 | |||||
| MAY, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | 24 Cambourne Avenue Whitchurch CF4 2AQ Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 10975750001 | |||||
| MCKAY, Fergus | Geschäftsführer | 58 Cloch Road PA19 1AU Gourock Renfrewshire | United Kingdom | British | 117134180001 | |||||
| MCKAY, Fergus Andrew | Geschäftsführer | 2 Magpie Crescent Inverkip PA16 0LW Greenock Renfrewshire | British | 62269770001 | ||||||
| NILSON, Ronny Stig Kjell | Geschäftsführer | Vastra Sjogatan 4 Kalmar 39232 Kalmar Sweden | Swedish | 56534930001 | ||||||
| NILSSON, Hans Daniel | Geschäftsführer | 30 East Sheen Avenue East Sheen SW14 8AS London | England | Swedish | 55982340002 | |||||
| PORTER, Humphrey | Geschäftsführer | Makartstrasse 7 A2102 Haenbrunn Austria | British | 63137020001 | ||||||
| READ, Paul | Geschäftsführer | 8 Gelli Fawr Court Henllys NP44 6ET Cwmbran Gwent | British | 43486210001 | ||||||
| ROWAN, James | Geschäftsführer | 17 Powmill Road KA9 2NX Prestwick Ayrshire | British | 55159480002 | ||||||
| RYAN, Matthew | Geschäftsführer | Kingfisher House Aberthin Road CF7 7EJ Cowbridge South Glamorgan | Irish | 50392750001 | ||||||
| THOMAS, Meirion Lewis | Geschäftsführer | 34 Robert Street Glynneath SA11 5EG Neath West Glamorgan | British | 50392590001 | ||||||
| TOYE, Daniel | Geschäftsführer | 18 Myvot Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4ND Glasgow Lanarkshire | British | 104183320001 |
Hat FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 11. Aug. 1998 Geliefert am 22. Aug. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date of 8 grove park business estate white waltham county of berkshire between the company and the chargee | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the deposit of £7,750 and all related rights thereto and thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. März 1997 Geliefert am 14. Apr. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of any loan document the credit agreements (as defined) and this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. März 1997 Geliefert am 18. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 05. Feb. 1997 Geliefert am 13. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Flextronics international (UK) LTD us dollar deposit account no 42684555, dollar current account no 42684588 and money market deposit bid no 83615844. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge, | Erstellt am 06. Sept. 1994 Geliefert am 20. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at dinas isaf, taff ely, mid glamorgan,. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 06. Sept. 1994 Geliefert am 20. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title and interest in and under the account held with barclays bank PLC reference ;assembly & automation (electronics) limited higher interest business account number 90506168, together with all interest accrued or accruing thereon, please see doc for further details,. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage, | Erstellt am 06. Sept. 1994 Geliefert am 20. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben P.C.B. assembly machinery comprising ;2/2004 a"gen-rad" model 2271 circuit board test system, no 9953 with monitor ,keyboard, "oki" data microline printer, 1/111-1 a"gen-rad" model 2276E board test work station, no 9877 with monitor ,polar toneohm 550 ohmmeter "digital"TK550 tape streamer,"okidata" microline 192 plus printer, 1/1136/1 a " universal " model 6348 radial printed circuit board inserter, no 10793-8-41953101 , 18IN x 18IN board size ,,40 station automatic COMP0NENT feed with "hewlett packard"vecrta 5 personal computer ,monitor and keyboard, "hewlett packard " quiet jet printer. Please see doc for further details,. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge . | Erstellt am 06. Sept. 1994 Geliefert am 20. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to barclays bank PLC, supplemental to the terms of a guarantee and debenture dated 8TH april 1991 . | |
Kurze Angaben Fixed charge over right title and interest of the company in or arising out of a factoring or invoice discounting deed dated 6TH september 1994 ,between kellock limited and the company and any deeds amending or replacing the same. Please see doc for further details,. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 06. Sept. 1994 Geliefert am 15. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 06. Sept. 1994 Geliefert am 12. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal amount of the stock and all monies due or to become due from the company to the chargee under the deed | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Apr. 1991 Geliefert am 17. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Jan. 1990 Geliefert am 13. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at dunas isaf edmondstown mid glamorgan t/no (part) wa 165032 (part) wa 384774. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0