TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED

TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01737862
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED?

    • Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CABLE COMMUNICATIONS CENTRAL LANCASHIRE LIMITED27. Juni 199427. Juni 1994
    CABLE COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED29. März 199029. März 1990
    LANCASHIRE CABLE TELEVISION LIMITED07. Aug. 198307. Aug. 1983
    JAVESWORD LIMITED08. Juli 198308. Juli 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    15 SeitenAA

    legacy

    80 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    8 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    14 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 23. Aug. 2016

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share prem 02/08/2016
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    85 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    5 SeitenGUARANTEE2

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 06. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 22,544,826
    SH01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    13 SeitenAA

    legacy

    94 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 09. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 22,544,826
    SH01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    13 SeitenAA

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    Wer sind die Geschäftsführer von TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Sekretär
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151395770001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BOLLAND, Iain Hugh
    44 Western Road
    Hagley
    DY9 0JY Stourbridge
    West Midlands
    Sekretär
    44 Western Road
    Hagley
    DY9 0JY Stourbridge
    West Midlands
    British70957410001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Sekretär
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    HURST, Paul Stuart
    68 Abbot Meadow
    Penwortham
    PR1 9JX Preston
    Lancashire
    Sekretär
    68 Abbot Meadow
    Penwortham
    PR1 9JX Preston
    Lancashire
    British22359600001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Sekretär
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BOLLAND, Iain Hugh
    44 Western Road
    Hagley
    DY9 0JY Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    44 Western Road
    Hagley
    DY9 0JY Stourbridge
    West Midlands
    British70957410001
    BOWDEN, Lesley
    10 Canford Close
    EN2 8QN Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    10 Canford Close
    EN2 8QN Enfield
    Middlesex
    British37397130001
    BRYAN, Danny Frank
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    American41071470001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    CAMPBELL, Thomas Charles
    8 Elixton Hall Gardens
    Elixton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Elixton Hall Gardens
    Elixton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    American55727100001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DAVIDSON, Stephen James
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92784240001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    GEPPERT, William King
    Bannister Hall Lodge
    Potter Lane Higher Walton
    PR5 4EN Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Bannister Hall Lodge
    Potter Lane Higher Walton
    PR5 4EN Preston
    Lancashire
    American36137650001
    GILLIAM, Michael Newell
    Cedar House
    7 Orchards Close Elmstead Road
    KT14 6SG West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Cedar House
    7 Orchards Close Elmstead Road
    KT14 6SG West Byfleet
    Surrey
    Us37473900001
    HARTMAN, David Bruce
    15 Higher Greenfield
    Ingol
    PR2 3ZX Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    15 Higher Greenfield
    Ingol
    PR2 3ZX Preston
    Lancashire
    American10764320001
    HOWE, Gerard Joseph
    Silvergarth
    19 Badgers Hill Wentworth
    GU25 4BA Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    Silvergarth
    19 Badgers Hill Wentworth
    GU25 4BA Virginia Water
    Surrey
    American35926250001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MICHELS, Alan
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    British43658810001
    REXROTH, Lynn Charles
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Geschäftsführer
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    American49075080001
    ROY, Drew Aloysius
    Marron Grange
    South Road St Georges Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Marron Grange
    South Road St Georges Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    American60296050001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Geschäftsführer
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    SUGDEN, Andrew
    9 Grange Park
    GU21 4BX Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    9 Grange Park
    GU21 4BX Woking
    Surrey
    United KingdomBritish75703620001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TURNER, John Michael
    Pine Lodge
    East Road
    KT13 0LG Weybridge
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    Pine Lodge
    East Road
    KT13 0LG Weybridge
    Surrey
    England
    American35605270001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Geschäftsführer
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001
    VAUGHN, David Kent
    19 Sheraton Park
    Ingol
    PR2 7AZ Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    19 Sheraton Park
    Ingol
    PR2 7AZ Preston
    Lancashire
    Us Citizen24140670001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    25. Okt. 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4925679
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2321124
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat TELEWEST COMMUNICATIONS (CENTRAL LANCASHIRE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 22. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture made between (1) telewest communications networks limited, (2) the original charging subsidiaries, (3) the original charging partnerships and (4) telewest finance corporation (the "us "borrower") 5). cibc world markets PLC in its capacity as security trustee issued by the company.
    Erstellt am 16. März 2001
    Geliefert am 23. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A).all amounts payable to cibc world markets PLC as security trustee to the extent only of the amount payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed and all amounts payable to any other person who may be appointed as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed; (b) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents; (c) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to the hedge counterparties under the hedging arrangements; (d) all indebtedness of the lessees to the lessors (or any of them) under the lease documents; and (e) all financial obligations due to crosby under the crosby documents
    Kurze Angaben
    I). all the company's present and future rights, title, benefit and interest in and under the loan stock (as defined) from time to time ii). All rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company arising under the bbc jv management services agreement, and the UK gold jv management services agreement iii). All rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company under the bbc jv agreement, the UK gold jv agreement and any other subscription and shareholder agreement entered into in relation to a joint venture, including (but not limited to) all amounts payable under clauses 19 and 20 of the bbc jv agreement and clauses 19 and 20 of the UK gold jv agreement and iv). All the company's present and future rights title benefit and interest in and under the intercompany loan agreement together with first floating charge all the company's undertaking property and assets not charged by way of fixed charge .. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture made between (1) telewest communications networks limited, (2) the original charging subsidiaries, (3) the original charging partnerships and (4) cibc world markets PLC in its capacity as security trustee issued by the company
    Erstellt am 20. Mai 1999
    Geliefert am 03. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    (A) all amounts payable to cibc world markets PLC as security trustee to the extent only of the amount payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed and all amounts payable to any other person who may be appointed as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed; (b) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents; (c) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to the hedge counterparties under the hedging arrangements; (d) all indebtedness of the lessees to the lessors (or any of them) under the lease documents; and (e) all financial obligations due to crosby under the crosby documents
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge (I) without prejudice to clause 3.1(b) of the debenture all the company's right, title and interest in and to all claims to which the company is at the date of the debenture or may thereafter become entitled under and in relation to each of the lease documents to which it is a party.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture dated 26TH september 1998 made between (1)telewest communications networks limited,(1) the original charging subsidiaries (2) the original charging partnerships (3) and the toronto-dominion bank in its capacity as security trustee (4)
    Erstellt am 26. Sept. 1998
    Geliefert am 08. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities whether actual or contingent which are covenanted or guaranteed to be paid by each chargor (as defined therein) to the chargees under or pursuant to the agreement dated 27TH march 1998 and/or the security trust deed and/or all or any of the other security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto Dominion Bank (In Its Capacity as Security Trustee,Agent and First Beneficiary Under the Terms of the Debenture), the Arrangers and the Banks (or Any of Them).
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Juli 1996
    Geliefert am 07. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities whether actual or contingent which are covenanted or guaranteed to be paid by each chargor (as defined therein) to cibc wood gundy PLC (in its capacity as security trustee) for the account of (a) the agent, the security trustee, the arrangers and the banks (or any of them) under or pursuant to the agreement dated 22ND may 1996 and/or this deed and/or the security trust deed and/or any of the other security documents; (b) the interest rate beneficiaries (or any of them) in respect of the interest rate protection arrangements; and (c) the bond providers (or any of them) in respect of any indemnity from each chargor issued in connection with the bond provision arrangements (all as defined in the deed) (collectively the beneficiaries) whether by acceleration or otherwise
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc Wood Gundy PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0