STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)
Überblick
| Unternehmensname | STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE) |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01753736 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DANEMOOR LIMITED | 16. Sept. 1983 | 16. Sept. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Justin Matthew King als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Dez. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Zweite Einreichung für die Abberufung von Kevin Michael Bradshaw als Geschäftsführer | 4 Seiten | RP04TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Justin Matthew King als Direktor am 18. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Thomas Murphy als Geschäftsführer am 18. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Mary Elizabeth Murray als Sekretär am 25. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Gerald Jones am 22. Juli 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Roger Mclaughlan als Direktor am 10. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Ann Ward als Sekretär am 13. Juli 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Michael Bradshaw als Geschäftsführer am 09. März 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nils Olin Steinmeyer als Geschäftsführer am 01. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Anthony Gerald Jones als Direktor am 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Thomas Murphy als Direktor am 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Elizabeth Ann Ward als Sekretär am 11. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nils Olin Steinmeyer als Sekretär am 11. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Garden Centre Group, Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF zum Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF am 24. Feb. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF zum The Garden Centre Group, Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF am 04. Jan. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Dez. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF zum Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF am 23. Jan. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY, Mary Elizabeth | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 213045220001 | |||||||
| JONES, Anthony Gerald | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 212265950001 | |||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 206428840001 | |||||
| FOALE, Stephen John | Sekretär | 42 Holmbury Avenue RG45 6TQ Crowthorne Berkshire | British | 37403500001 | ||||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Sekretär | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | British | 72128340003 | ||||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Sekretär | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | 76162020001 | ||||||
| ROGERS, May Elizabeth | Sekretär | 7 Croft Lane SG6 1AS Letchworth Hertfordshire | British | 28069990001 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 173142280001 | |||||||
| WARD, Elizabeth Ann | Sekretär | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 205459140001 | |||||||
| WHITTAKER, Janet Mary | Sekretär | 32 Whitney Drive SG1 4BH Stevenage Hertfordshire | British | 28070010001 | ||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 124019940001 | |||||
| BRIGDEN, Peter | Geschäftsführer | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 195802400001 | |||||
| HODKINSON, James Clifford | Geschäftsführer | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Geschäftsführer | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| KING, Justin Matthew | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 213157990001 | |||||
| KING, Wendy | Geschäftsführer | 9 Fielden Abbeydale GL4 5EW Gloucester Gloucestershire | England | British | 89910600001 | |||||
| KITCHING, Jonathan Andrew | Geschäftsführer | Beech House Harp Hill GL52 6PR Cheltenham | England | British | 68271660002 | |||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Geschäftsführer | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LIVINGSTON, William Andrew | Geschäftsführer | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | 111439220001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Geschäftsführer | Glan Honddu House Llandefaelog Fach LD3 9PP Brecon Powys | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 207509410001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Geschäftsführer | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Geschäftsführer | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | 76162020001 | |||||
| ROGERS, May Elizabeth | Geschäftsführer | 7 Croft Lane SG6 1AS Letchworth Hertfordshire | British | 28069990001 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Geschäftsführer | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| STEVENSON, Barry John | Geschäftsführer | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | 102595670001 | |||||
| WHITTAKER, Barrington | Geschäftsführer | 32 Whitney Drive SG1 4BH Stevenage Hertfordshire | British | 28070000001 | ||||||
| WHITTAKER, Janet Mary | Geschäftsführer | 32 Whitney Drive SG1 4BH Stevenage Hertfordshire | United Kingdom | British | 28070010001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyevale Garden Cedntres Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE) Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 24. Feb. 2009 Geliefert am 04. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to the debenture | Erstellt am 12. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and property situated on the south east side of graveley road stevenage and adjoining land at the junction of B197 and graveley road stevenage t/nos hd. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 01. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any acount whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H st mellons park garden centre newport road st mellons cardiff fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 01. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H st mellons park garden centre newport road st mellons cardiff fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a debenture | Erstellt am 29. März 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a debenture | Erstellt am 29. März 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Feb. 2007 Geliefert am 27. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at the junction of the B197 and graveley road stevenage t/no HD451252. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Feb. 2007 Geliefert am 27. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the north west and north east sides of graveley road stevenage t/no hd 392392. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Feb. 2007 Geliefert am 24. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Transfer | Erstellt am 06. Feb. 2006 Geliefert am 18. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben The triangualr shaped piece of land forming part of stevenage garden centre as shown on the plan attached to the transfer. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Transfer | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 17. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben Stevenage garden centre graveley road stevenage hertfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 10. Mai 1989 Geliefert am 16. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Mai 1989 Geliefert am 19. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £264,345.09 and all other moneys due or to become due from the company to csl holdings limited. | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Apr. 1987 Geliefert am 16. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Nursery at north road and graveley link stevenage hertfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Feb. 1987 Geliefert am 17. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or C.S.l business systems limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0