MHL REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMHL REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01756338
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MHL REALISATIONS LIMITED?

    • (4521) /

    Wo befindet sich MHL REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Four
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MHL REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MCCANN HOMES LIMITED28. Dez. 200028. Dez. 2000
    MCCANN HOLDINGS LIMITED15. Nov. 198315. Nov. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MHL REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MHL REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MHL REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2015

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2014

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2013

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2012

    21 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Robert David Green als Geschäftsführer am 17. Mai 2011

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert David Green als Sekretär am 17. Mai 2011

    2 SeitenTM02

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed mccann homes LIMITED\certificate issued on 02/09/11
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 01. Sept. 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Shirwell House Shirwell Crescent Furzton Lake Milton Keynes Buckinghamshire MK4 1GA am 14. Juni 2011

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    legacy

    5 SeitenMG01

    Beendigung der Bestellung von Simon Langford als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    21 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 21. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 50,002
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Simon David Langford am 31. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    22 SeitenAA

    legacy

    5 SeitenMG01

    Beendigung der Bestellung von Charles Raikes als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Edwin Barnes als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von MHL REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COULL, Andrew
    1 Lime Grove
    LU7 2SU Linslade
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    1 Lime Grove
    LU7 2SU Linslade
    Bedfordshire
    EnglandBritish117328610001
    ROYDON, Terry Rene
    Kingsmill
    The Marlins
    HA6 3NP Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Kingsmill
    The Marlins
    HA6 3NP Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish2326110001
    SETH, David Peter
    1 Brough Close
    Shenley Church End
    MK5 6HR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    1 Brough Close
    Shenley Church End
    MK5 6HR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    UkBritish75931260001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Sekretär
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    British76720550003
    LEWIS, Pauline Sau Yoke
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    Sekretär
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    British107739250001
    MCCANN, Jeanette Marie
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    Sekretär
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    British40380650002
    BARNES, Edwin Sidney
    121 Arlesey Road
    Stotfold
    SG5 4HE Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    121 Arlesey Road
    Stotfold
    SG5 4HE Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish116515140001
    COULL, Andrew
    1 Lime Grove
    LU7 2SU Linslade
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    1 Lime Grove
    LU7 2SU Linslade
    Bedfordshire
    EnglandBritish117328610001
    DAVIES, Gail
    5 Lexden Close
    Wootton
    NN4 6DU Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    5 Lexden Close
    Wootton
    NN4 6DU Northampton
    Northamptonshire
    British124910160001
    GAYTON, Paul
    2 Robinson Close
    EN2 6SF Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Robinson Close
    EN2 6SF Enfield
    Middlesex
    British125227660001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Geschäftsführer
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritish76720550003
    LANGFORD, Simon David
    10 Woodpecker Way
    SG19 2SQ Sandy
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    10 Woodpecker Way
    SG19 2SQ Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritish117328730001
    LEWIS, Pauline Sau Yoke
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    EnglandBritish107739250001
    MCCANN, James Christopher
    The Oaks
    Heath Lane, Woburn Sands
    MK17 8TS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Oaks
    Heath Lane, Woburn Sands
    MK17 8TS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish50515850006
    MCCANN, Jeanette Marie
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    Geschäftsführer
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    United KingdomBritish40380650002
    MCCANN, Malcolm John
    Branscome Mentmore Road
    Linslade
    LU7 Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Branscome Mentmore Road
    Linslade
    LU7 Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British16912730001
    MCCANN, Terence Patrick
    Linford Lodge Wood Lane
    St Leger Drive Great Linford
    MK14 5AZ Milton Keynes
    Geschäftsführer
    Linford Lodge Wood Lane
    St Leger Drive Great Linford
    MK14 5AZ Milton Keynes
    United KingdomBritish8524640002
    PAYTON, Keith Douglas
    4 Heather Breea Gardens
    NN10 6EH Rushden
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    4 Heather Breea Gardens
    NN10 6EH Rushden
    Northamptonshire
    British85234370001
    POWELL, Ashley Jonathan
    152 Lupin Drive
    CM1 6FJ Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    152 Lupin Drive
    CM1 6FJ Chelmsford
    Essex
    British127633390001
    RAIKES, Charles Robert
    51 Mill Street
    OX2 0AL Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    51 Mill Street
    OX2 0AL Oxford
    Oxfordshire
    British127633250001
    ROWNTREE, Charles James
    55 Galleon Way
    ME2 4GX Upnor
    Kent
    Geschäftsführer
    55 Galleon Way
    ME2 4GX Upnor
    Kent
    British100843060001

    Hat MHL REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2011
    Geliefert am 08. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The land being 42 to 48 (even) oxenhope way borughton milton keynes (plots 1 to 4).
    Berechtigte Personen
    • Homes and Communities Agency
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Jan. 2010
    Geliefert am 29. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plots 53 to 56 cedar park broughton milton keynes.
    Berechtigte Personen
    • Homes and Communities Agency
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Nov. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 2008
    Geliefert am 02. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a f/h land on the west side of station road, sandy, bedfordshire t/no BD151438, fixed charge all proceeds of sale of the property and all fittings on the property and floating charge all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC, as Security Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juni 2008
    Geliefert am 25. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property being building 2, caldecotte lakeside, monellan grove, caldecotte, milton keynes.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2008
    Geliefert am 13. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H building 1 caldecotte lakeside monellan grove caldecotte milton keynes fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2008
    Geliefert am 13. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the north and west of monellan grove caldecotte milton keynes fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Mai 2008
    Geliefert am 04. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Blocks b,c and d monkston park 1 and 2 milton keynes.
    Berechtigte Personen
    • Commission for the New Towns (Known as English Partnerships)of Central Business Exchange
    Transaktionen
    • 04. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Nov. 2007
    Geliefert am 13. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land at green farm road newport pagnell buckinghamshire.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2009
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 2007
    Geliefert am 13. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land on the west side of garden hedge leighton buzzard bedfordshire t/no BD254941.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 05. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H monkston park sites 1 and 2 milton keynes.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 13. Okt. 2006
    Geliefert am 24. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the parent to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Aug. 2006
    Geliefert am 10. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    120 potton road biggleswade and land and buildings at potton road biggleswade t/n BD12242 and BD146754. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second legal charge
    Erstellt am 28. Juli 2006
    Geliefert am 03. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    193 cressex road, high wycombe.
    Berechtigte Personen
    • Private Sector Developments Limited
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juni 2006
    Geliefert am 20. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at jordans yard st neots road sandy bedfordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sub charge
    Erstellt am 04. Mai 2006
    Geliefert am 17. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All principal interest or other money now and in the future secured by the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge over agreement for lease
    Erstellt am 04. Mai 2006
    Geliefert am 13. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The agreement for lease dated 20TH march 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Mai 2006
    Geliefert am 13. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property situate at caldecotte lakeside milton keynes. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 2006
    Geliefert am 13. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The white swan public house 27 high street westcott bucks. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 13. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H properties k/a plots 25-30 willows chase, monkston park 13 & 14, milton keynes t/no. BM61781.
    Berechtigte Personen
    • Commission for the New Towns
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 02. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land off trow close, cotton end, bedfordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Aug. 2005
    Geliefert am 26. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that land being 55,57 and 59 stoke road slough t/n BK234902 BK362460 and BK277664. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 16. Juni 2005
    Geliefert am 06. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south west of tewkesbury lane monkston park milton keynes t/lybm 291292. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juni 2005
    Geliefert am 06. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south west of tewkesbury lane monkston park milton keynes t/n bm 291292. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of performance bond
    Erstellt am 07. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The benefit of a performance bond between kingsoak homes limited, hsbc bank PLC and the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/Hold land and buildings lying to the west of plantation rd,leighton buzzard with all buildings and other structures thereon; the goodwill of business and all plant machinery and other items affixed thereon; the proceeds of any claims made under any insurance policy. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat MHL REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Mai 2011Beginn der Liquidation
    19. Apr. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0