SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01759149 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Norcliffe House Station Road SK9 1BU Wilmslow |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Okt. 2015
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian Richard Smith am 19. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Benjamin Robert Taberner am 18. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Jude Kay als Geschäftsführer am 31. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Kay als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Abigail Mattison als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maureen Claire Royston am 22. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* am 21. Feb. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Maureen Claire Royston als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Calveley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Richard Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTISON, Abigail | Sekretär | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188580810001 | |||||||
| ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Geschäftsführer | Alderley Road Wilmslow SK9 1NX Cheshire Emerson Court England England | United Kingdom | British | 184190020002 | |||||
| SMITH, Ian Richard | Geschäftsführer | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 181082310001 | |||||
| TABERNER, Benjamin Robert | Geschäftsführer | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 150511890001 | |||||
| JOBSON, Timothy Akers | Sekretär | 6 Redhouse Road Tettenhall WV6 8ST Wolverhampton West Midlands | British | 34676900001 | ||||||
| KAY, Dominic Jude | Sekretär | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | 145920530001 | ||||||
| KYRIAKOU, Patricia Linda | Sekretär | The Rectory Rectory Road Donington Albrighton WV7 3EP Wolverhampton West Midlands | British | 2118290001 | ||||||
| WK COMPANY SERVICES LIMITED | Sekretär | 5 & 6 Northumberland Building Queen Square BA1 2JE Bath Avon | 101282840001 | |||||||
| ANSTEAD, Hamilton Douglas | Geschäftsführer | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | 107751890001 | ||||||
| CALVELEY, Peter, Dr | Geschäftsführer | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | 131468590001 | |||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Geschäftsführer | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| HEYWOOD, Anthony George | Geschäftsführer | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | 131288260001 | |||||
| HILL, Peter | Geschäftsführer | Manor Farm Springhill Lane WV4 4UH Lower Penn Staffordshire | British | 60631360001 | ||||||
| JOBSON, Timothy Akers | Geschäftsführer | 6 Redhouse Road Tettenhall WV6 8ST Wolverhampton West Midlands | British | 34676900001 | ||||||
| KAY, Dominic Jude | Geschäftsführer | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | 145920530001 | |||||
| KILGOUR, Robert Dow | Geschäftsführer | 26 Beveridge Road KY1 1UY Kirkcaldy Fife | British | 494960001 | ||||||
| KYRIAKOU, Michael Andreas | Geschäftsführer | La Rizonne Vanxains 24600 France | France | British | 64115610001 | |||||
| KYRIAKOU, Patricia Linda | Geschäftsführer | The Rectory Rectory Road Donington Albrighton WV7 3EP Wolverhampton West Midlands | British | 2118290001 | ||||||
| MITCHELL, Nicholas John | Geschäftsführer | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | 145102120001 | |||||
| WILLIS, Graeme | Geschäftsführer | 3 Carrwood Road SK9 5DJ Wilmslow Cheshire | British | 71527500002 | ||||||
| WILLIS, Graeme | Geschäftsführer | 3 Carrwood Road SK9 5DJ Wilmslow Cheshire | British | 71527500002 |
Hat SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rhyme debenture | Erstellt am 12. Nov. 2004 Geliefert am 30. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 2001 Geliefert am 30. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a oakfield house, 126 barkham road, wokingham, berkshire t/no BK303511.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 2001 Geliefert am 26. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Okt. 1999 Geliefert am 12. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or group company (as defined) to the chargee under the debenture or otherwise | |
Kurze Angaben The leasehold property known as springfield house, oaken lane, wolverhampton west midlands WV8 2EE. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 1998 Geliefert am 16. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies,other liabilities and other costs charges and expenses due or to become due from the company to the charge under a lease dated 28TH august 1998 and all other monies due under or pursuant to any clause of the debenture | |
Kurze Angaben L/H property k/a springfield house oaken lane codsall woverhampton west midlands. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Aug. 1984 Geliefert am 14. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold springfield house, oaken, codsall, staffordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Okt. 1983 Geliefert am 20. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures (including trade) fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0