FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED

FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01761823
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED?

    • Güterkraftverkehr (49410) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Senate Court
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Devon
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FRAMPTONS INTERNATIONAL LIMITED 09. Dez. 198309. Dez. 1983
    T.I.R. TRANS LIMITED17. Okt. 198317. Okt. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Juni 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung am 31. März 2017

    • Kapital: GBP 10
    3 SeitenSH19

    legacy

    3 SeitenSH20

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 101,827
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Senate Court Southernhay Gardens Exeter Devon EX1 1NT verlegt

    1 SeitenAD04

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom The Old Mill Park Road Shepton Mallet Somerset BA4 5BS United Kingdom zum Gregory Distribution North Park North Tawton Devon EX20 2EB geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Juni 2015

    27 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 017618230016, erstellt am 08. Apr. 2015

    8 SeitenMR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 190 consideration of allotment 31/03/2015
    RES13

    Eintragung der Belastung 017618230015, erstellt am 08. Apr. 2015

    31 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 017618230014, erstellt am 08. Apr. 2015

    31 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 017618230013, erstellt am 08. Apr. 2015

    35 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    2 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FOOT ANSTEY SECRETARIAL LIMITED
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Sekretär
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03485060
    116388540001
    BUTLER, Angela Mary
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Geschäftsführer
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    United KingdomBritishDirector152016650001
    GREGORY, John Kennedy
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Geschäftsführer
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    EnglandBritishDirector196632660001
    JEFFERSON, Paul Gerard
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Geschäftsführer
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    United KingdomBritishDirector128823150001
    WALKER, Andrew Graham
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Geschäftsführer
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    EnglandBritishDirector139906550001
    BUCHAN, Janice Elizabeth
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Sekretär
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    British34082820001
    BUCHAN, Janice Elizabeth
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Geschäftsführer
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    EnglandBritishFinance Director34082820001
    FRAMPTON, Andrew John
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Geschäftsführer
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    United KingdomBritishDirector34082830001
    FRAMPTON, Paul
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Geschäftsführer
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    United KingdomBritishDirector117961680001
    FRY, Richard James
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    Geschäftsführer
    Southernhay Gardens
    EX1 1NT Exeter
    Senate Court
    Devon
    England
    United KingdomBritishDirector And General Manager113315780001
    YEOMAN, Roger
    Two Wells
    Ditcheat
    BA4 6RB Shepton Mallet
    Somerset
    Geschäftsführer
    Two Wells
    Ditcheat
    BA4 6RB Shepton Mallet
    Somerset
    BritishCompany Director63302880001

    Hat FRAMPTONS TRANSPORT SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. Apr. 2015
    Geliefert am 16. Apr. 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    None.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Apr. 2015
    Geliefert am 15. Apr. 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All that freehold property known as mendip distribution centre shepton mallet and registered at hm land registry with title numbers ST75492 and ST65607.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Apr. 2015
    Geliefert am 15. Apr. 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All that freehold property known as or being crown warehouse crown trading estate shepton mallet and registered at hm land registry with title numbers WS21791, WS33989 and WS23167.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Apr. 2015
    Geliefert am 15. Apr. 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Mai 2012
    Geliefert am 04. Mai 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south east side of fosse way shepton mallet t/no's ST65607 and ST75492 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 20. Feb. 2012
    Geliefert am 22. Feb. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 2012
    Geliefert am 28. Jan. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2011
    Geliefert am 05. Okt. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south east side of fosse way charlton shepton mallet t/nos. ST75492 and ST65607 and any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Sept. 2008
    Geliefert am 25. Sept. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at crowne trading estate, shepton mallet, somerset t/no WS21791 and WS33989 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 2008
    Geliefert am 10. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at crown trading estate shepton mallett somerset t/no WS33912 and WS23167 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 06. Jan. 2003
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 21. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from frampton holdings limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total amount recoverable in relation thereto under this mortgage shall not exceed an amount equal to the 50% share of frampton holdings limited in the proceeds of sale of the mortgaged property or the equivalent thereof at the date of demand on the mortgagor in one or more currencies
    Kurze Angaben
    F/H property k/a tower house street somerset t/n ST89683 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed equitable charge
    Erstellt am 18. Mai 1995
    Geliefert am 20. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all book debts invoice debts accounts notes bills acceptances the subject of a factoring agreement and all title property right or interest in any goods and all guarantees indemnities insurances or securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Griffin Factors Limited
    Transaktionen
    • 20. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Credit agreement
    Erstellt am 27. Jan. 1993
    Geliefert am 04. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £67307.50 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the paper apart to form 395 see form 395 M33C for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Credit agreement
    Erstellt am 11. Aug. 1992
    Geliefert am 25. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £31494.18 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the reverse to form 395 see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Nov. 1984
    Geliefert am 30. Nov. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charge overthe:- undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1984Registrierung einer Belastung
    • 10. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0