MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01763604 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?
- Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 London Wall Place, 4th Floor EC2Y 5AU London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TIGERTMS LIMITED | 17. Feb. 2010 | 17. Feb. 2010 |
| TELEPHONE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | 25. Nov. 1987 | 25. Nov. 1987 |
| TELEPHONE MANAGEMENT LIMITED | 09. Sept. 1987 | 09. Sept. 1987 |
| BURGUNDY SECURITIES LIMITED | 02. Dez. 1983 | 02. Dez. 1983 |
| AFRICOURT LIMITED | 21. Okt. 1983 | 21. Okt. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 77-79 Christchurch Road Ringwood Hampshire BH24 1DH zum 2 London Wall Place, 4th Floor London EC2Y 5AU am 08. Dez. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Change of details for Mitel Hospitality Communications 1 Limited as a person with significant control on 08. Dez. 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Connected Guests Ltd as a person with significant control on 03. März 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Connected Guests Ltd as a person with significant control on 26. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Mitel Europe Limited as a person with significant control on 26. Feb. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Mark Udell als Geschäftsführer am 01. Nov. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Skellon als Geschäftsführer am 31. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Skellon als Direktor am 16. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Andrew Evans als Geschäftsführer am 16. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Gregory J. Hiscock als Sekretär am 01. Juni 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISCOCK, Gregory J. | Sekretär | Legget Drive K2K 2W7 Kanata 350 Ontario Canada | 224968320001 | |||||||
| HISCOCK, Gregory James | Geschäftsführer | Legget Drive K2K 2W7 Kanata 350 Ontario Canada | Canada | Canadian | 131825230002 | |||||
| ARORA, Suman | Sekretär | 22 Kings Mews 31 Poole Road Westbourne BH4 9DJ Bournemouth Dorset | British | 36541950004 | ||||||
| ARORA, Suman | Sekretär | 22 Kings Mews 31 Poole Road Westbourne BH4 9DJ Bournemouth Dorset | British | 36541950004 | ||||||
| COMBEN, Roy Dennis | Sekretär | Glencoe Blandford Road Bere Regis BH20 7JH Wareham Dorset | British | 31144600001 | ||||||
| SEARBY, Robert Anthony | Sekretär | 5 Spinfield Lane West SL7 2DB Marlow Buckinghamshire | British | 1737470007 | ||||||
| STRANGE, Elizabeth Ann | Sekretär | 20 Hynesbury Road Friars Cliff BH23 4ER Christchurch Dorset | British | 27737610001 | ||||||
| UDELL, Simon Mark | Sekretär | Christchurch Road BH24 1DH Ringwood 77-79 Hampshire United Kingdom | 147820350001 | |||||||
| WANKLYN, Stephen Richard | Sekretär | 52 Montacute Way Merley BH21 1TZ Wimborne Dorset | British | 109848670001 | ||||||
| WANKLYN, Stephen Richard | Sekretär | 52 Montacute Way Merley BH21 1TZ Wimborne Dorset | British | 109848670001 | ||||||
| ARORA, Suman | Geschäftsführer | 22 Kings Mews 31 Poole Road Westbourne BH4 9DJ Bournemouth Dorset | England | British | 36541950004 | |||||
| BARNARD, Henry | Geschäftsführer | 13 Knole Wood Devenish Road SL5 9QR Sunningdale Berkshire | England | British | 79398170001 | |||||
| BECHMANN, Ulrich | Geschäftsführer | March 10c Ellmall 6352 Austria | German | 105977490001 | ||||||
| BECKMANN, Ulrich | Geschäftsführer | Sonnsieine 225 Going 6353 Austria | Germann | 84762580001 | ||||||
| CARTER, Michael Thomas | Geschäftsführer | 1 The Hollows Little Lonnen BH21 7BB Wimborne Dorset | British | 72648550002 | ||||||
| CLARK, Susanne Christine | Geschäftsführer | 6 Nutley Close BH11 8LF Bournemouth Dorset | British | 72648560001 | ||||||
| COMBEN, Roy Dennis | Geschäftsführer | Glencoe Blandfield Road BH20 7JH Bere Regis Dorset | British | 24875800001 | ||||||
| DEPAUW, Yoeri | Geschäftsführer | The Greens Alsidrin, NA Dubai Flat 308 United Arab Emirates | Uae | Belgian | 119362440001 | |||||
| DUDHIA, Saeed Ahmed Gulam, Mr. | Geschäftsführer | Christchurch Road BH24 1DH Ringwood 77-79 Hampshire United Kingdom | England | British | 115082000001 | |||||
| EIBEL, Karl | Geschäftsführer | Abstallerstrasse Graz 45 8052 Austria | Austria | 138909980001 | ||||||
| EVANS, James Andrew | Geschäftsführer | NP26 5YR Portskewett Castlegate Business Park United Kingdom | Wales | British | 188610900001 | |||||
| EVETTS, Peter | Geschäftsführer | 18 Braeside Road BH22 OJS West Moors Dorset | United Kingdom | British | 81346870001 | |||||
| HOADLEY, Brian Peter | Geschäftsführer | Broomrigg Road GU51 4LS Fleet Crossways Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34054910002 | |||||
| KATES, Brian Trevor | Geschäftsführer | 15 Keswick Road Boscombe BH5 1LP Bournemouth Dorset | British | 24875810001 | ||||||
| LOMAX, Mark Robert | Geschäftsführer | 20 Westfield Road Regents Park SO15 4HR Southampton Hampshire | British | 97367020001 | ||||||
| LOMAX, Mark Robert | Geschäftsführer | 20 Westfield Road Regents Park SO15 4HR Southampton Hampshire | British | 97367020001 | ||||||
| MCCALLUM, Stephen Reid | Geschäftsführer | Christchurch Road BH24 1DH Ringwood 77-79 Hampshire United Kingdom | England | British | 89885340001 | |||||
| MCCALLUM, Stephen Reid | Geschäftsführer | 6 Hookwater Road SO53 5PR Chandlers Ford Hampshire | England | British | 89885340001 | |||||
| NUNN, Anne Veronica | Geschäftsführer | 2 The Vineries Colehill BH21 2PU Wimborne Dorset | British | 24875820001 | ||||||
| PONTIN, Alan | Geschäftsführer | Peel Fold Mill Lane RG9 4HB Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 17148750003 | |||||
| PRENTICE, Peter | Geschäftsführer | 127 Porchester Road Woolston SO19 2JA Southampton Hampshire | British | 114312120001 | ||||||
| SCHAER, Andreas | Geschäftsführer | Berghofstr 20 Herdern Switzerland | Swiss | 139865300001 | ||||||
| SCHAER, Andreas | Geschäftsführer | Spitzackerstrasse 5 FOREIGN Zurich 8057 Switzerland | Swiss | 115072390001 | ||||||
| SEARBY, Robert Anthony | Geschäftsführer | 5 Spinfield Lane West SL7 2DB Marlow Buckinghamshire | England | British | 1737470007 | |||||
| SKELLON, Simon | Geschäftsführer | Christchurch Road BH24 1DH Ringwood 77-79 Hampshire | England | British | 206579120001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitel Hospitality Communications 1 Limited | 26. Feb. 2018 | London Wall Place, 4th Floor EC2Y 5AU London 2 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mitel Europe Limited | 06. Apr. 2016 | New Street Square EC4A 3TW London 5 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 31. Juli 2014 Geliefert am 11. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 1000 shares of stock issued by innovation technologies worldwide, inc. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 31. Juli 2014 Geliefert am 04. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Sept. 2010 Geliefert am 08. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 29. März 2010 Geliefert am 30. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juni 2005 Geliefert am 24. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Feb. 1988 Geliefert am 12. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0