GREETINGS FOR EATING LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREETINGS FOR EATING LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01770733
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREETINGS FOR EATING LTD?

    • (1584) /

    Wo befindet sich GREETINGS FOR EATING LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GREETINGS FOR EATING LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WELLSPRINGS CONFECTIONERY LIMITED05. Apr. 199305. Apr. 1993
    WELLSPRINGS ENTERPRISES LIMITED 17. Okt. 198817. Okt. 1988
    BETHCAR LIMITED02. Okt. 198602. Okt. 1986
    BETHCAR AGRICULTURE LIMITED17. Nov. 198317. Nov. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREETINGS FOR EATING LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREETINGS FOR EATING LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Nov. 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Nov. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Mai 2009

    5 Seiten4.68

    Vorschlag des Verwalters

    66 Seiten2.17B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    26 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    23 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    68 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht

    31 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2006

    12 SeitenAA

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    11 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten123

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11

    Wer sind die Geschäftsführer von GREETINGS FOR EATING LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMITH, Yasmin Ruth
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    British60088530001
    SMITH, James Michael, Dr
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish150413640001
    SMITH, Stephen David, Dr
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    British54545850002
    SMITH, Yasmin Ruth
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish60088530001
    JOHN, Josh Verghese
    24 Orchard Crescent
    Tuxford
    NG22 0LU Newark
    Nottinghamshire
    Sekretär
    24 Orchard Crescent
    Tuxford
    NG22 0LU Newark
    Nottinghamshire
    British51340860001
    PRICE, Gregory Philip
    15 Hill Vue Avenue
    NG24 1PQ Newark
    Nottinghamshire
    Sekretär
    15 Hill Vue Avenue
    NG24 1PQ Newark
    Nottinghamshire
    British15769230004
    BOWER, Stuart Richard Hugo
    4 Long Lane
    Tuxford
    NG22 0LS Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    4 Long Lane
    Tuxford
    NG22 0LS Newark
    Nottinghamshire
    British73425870001
    BUTTERFIELD, Marcel
    Canterbury Lodge
    Rempstone Road Coleorton
    LE67 8HR Coalville
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Canterbury Lodge
    Rempstone Road Coleorton
    LE67 8HR Coalville
    Leicestershire
    United KingdomBritish61153960003
    COMMUNITY OF THE TRUE VINE LTD, The Directors
    Beth Shalon
    Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Beth Shalon
    Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    British15769240001
    FORD, Glen
    9 Churchill Drive
    Hilton
    DE65 5FS Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    9 Churchill Drive
    Hilton
    DE65 5FS Derby
    Derbyshire
    British103152550001
    SMITH, James Michael, Dr
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish150413640001
    SMITH, Marina Helen
    Bethany Acres Road Edge
    Ollerton Road Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Bethany Acres Road Edge
    Ollerton Road Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    British9654780004

    Hat GREETINGS FOR EATING LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Chattel mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 02. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The equipment being marden edwards overwrapper s/n 7424, loma combi metal detector s/n ACB43046-38591F and rondo compas icing roller s/n C4A421102 for details of further chattels charged please refer to form 395, fixed charge on all policies of insurance and all rights and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. März 2003
    Geliefert am 15. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Juli 2000
    Geliefert am 04. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies and all other liabilities due or to become due from the company to the chargee and all costs and expenses incurred in relation to the charge on a full indemnity basis together with interest thereon
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all book debts and other debts and by way of floating charge all the book debts and other debts of the company which are not charged hereunder by way of fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • Close Invoice Finance Limited (The Charge Holder)
    Transaktionen
    • 04. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. März 1998
    Geliefert am 27. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Jan. 1998
    Geliefert am 15. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £17,378 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Qualitec food depositor with pump action. All stainless steel electro 16RAK oven with thermo/steam injection, ebat crypto peerless food mixer and accessories, frigoscandia giro spiral cake drying tunnel, qualitech deposit.
    Berechtigte Personen
    • North Nottinghamshire Training & Enterprise Council Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Jan. 1998
    Geliefert am 15. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £17,378 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all the plant machinery vehicles stock and shares and all other similar property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital fixtures and fittings.
    Berechtigte Personen
    • North Nottinghamshire Training & Enterprise Council Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1996
    Geliefert am 07. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £5,000 under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Qualitec food depositor with pump action all stainless steel electro 16RAK oven with thermo/steam injection (3 phase) eb 80 crypto peerless food mixer and accessories.
    Berechtigte Personen
    • North Nottinghamshire Training and Enterprise Council Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GREETINGS FOR EATING LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Mai 2008Ende der Verwaltung
    04. Juni 2007Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Franklin Plant
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    Praktiker
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    Daniel Plant
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    Praktiker
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    2
    DatumTyp
    15. Feb. 2011Aufgelöst am
    30. Mai 2008Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Plant
    Sfp
    9 Ensign House
    E14 9XQ Admirals Way
    Marsh Wall, Docklands London
    Praktiker
    Sfp
    9 Ensign House
    E14 9XQ Admirals Way
    Marsh Wall, Docklands London
    Simon Franklin Plant
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    Praktiker
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0