RH FREEPORT WAREHOUSING LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRH FREEPORT WAREHOUSING LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01771843
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?

    • Güterkraftverkehr (49410) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kuehne+Nagel House Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6BW Milton Keynes
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MERSEY FREIGHT SERVICES (MTL) LTD07. Aug. 198507. Aug. 1985
    MERSEY FREIGHT SERVICES LIMITED 22. Nov. 198322. Nov. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Juni 2012

    Kapitalaufstellung am 12. Juni 2012

    • Kapital: GBP 200,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Tim Scharwath als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    22 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lenton Lane Nottingham NG7 2NR am 11. Mai 2011

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Tim Scharwath als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Thierry Patrick Held als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ian Baxter als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Baxter als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Steven Rafferty als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Steven Rafferty als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Peter Isler als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Robert Layton als Sekretär

    3 SeitenAP03

    legacy

    5 SeitenMG01

    legacy

    11 SeitenMG01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    22 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Peter James Isler am 09. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    19 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LAYTON, Robert
    Sywell Road
    Holcot
    NN6 9SN Northampton
    Nutmeg Cottage
    Northamptonshire
    Sekretär
    Sywell Road
    Holcot
    NN6 9SN Northampton
    Nutmeg Cottage
    Northamptonshire
    British159459370001
    HELD, Thierry Patrick
    Florence Way
    Rockingham Road
    UB8 2LS Uxbridge
    1 Union Business Park
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Florence Way
    Rockingham Road
    UB8 2LS Uxbridge
    1 Union Business Park
    Middlesex
    EnglandSwiss155850310001
    CRANE, Roger Leonard Arthur
    19 Gillercomb Close
    West Bridgford
    NG2 6SE Nottingham
    Sekretär
    19 Gillercomb Close
    West Bridgford
    NG2 6SE Nottingham
    British18196300002
    RAFFERTY, Steven
    5a Ashford Road
    LE10 0JL Hinckley
    Leicestershire
    Sekretär
    5a Ashford Road
    LE10 0JL Hinckley
    Leicestershire
    British86477730001
    BAXTER, Andrew Neville
    Moor House
    Old North Road South Muskham
    NG23 6DX Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Moor House
    Old North Road South Muskham
    NG23 6DX Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish107002860001
    BAXTER, Ian John Robert
    Church Lane
    NG13 9HG Langar
    Langar House
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Lane
    NG13 9HG Langar
    Langar House
    Nottinghamshire
    EnglandBritish20757760004
    BAXTER, Neville Alfred
    Wellow Park House
    Bleasby
    NG14 7GH Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Wellow Park House
    Bleasby
    NG14 7GH Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish1639600001
    CRANE, Roger Leonard Arthur
    19 Gillercomb Close
    West Bridgford
    NG2 6SE Nottingham
    Geschäftsführer
    19 Gillercomb Close
    West Bridgford
    NG2 6SE Nottingham
    British18196300002
    GOODRICK, Howard Vivian
    Lark Cottage
    West End, Lund
    YO25 9TN Driffield
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Lark Cottage
    West End, Lund
    YO25 9TN Driffield
    North Humberside
    EnglandBritish10050160002
    ISLER, Peter James
    Southfield Farm House
    The Clays
    LN5 0RW Brant Broughton
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Southfield Farm House
    The Clays
    LN5 0RW Brant Broughton
    Lincolnshire
    United KingdomBritish82518660002
    JARVIS, Terence
    27 Chester Avenue
    PR9 7ET Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    27 Chester Avenue
    PR9 7ET Southport
    Merseyside
    British39724000001
    RAFFERTY, Steven
    5a Ashford Road
    LE10 0JL Hinckley
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    5a Ashford Road
    LE10 0JL Hinckley
    Leicestershire
    United KingdomBritish86477730001
    SCHARWATH, Tim
    Florence Way
    Rockingham Road
    UB8 2LS Uxbridge
    1 Union Business Park
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Florence Way
    Rockingham Road
    UB8 2LS Uxbridge
    1 Union Business Park
    Middlesex
    EnglandBritish159736860001
    STOKES, Mark Bryan
    Stoneleigh House Main Road
    Anslow
    DE13 9QE Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Stoneleigh House Main Road
    Anslow
    DE13 9QE Burton On Trent
    Staffordshire
    British74798060003

    Hat RH FREEPORT WAREHOUSING LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 30. Dez. 2010
    Geliefert am 31. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 17. Dez. 2010
    Geliefert am 21. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 18. Feb. 1994
    Geliefert am 01. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge.
    Erstellt am 25. Juni 1991
    Geliefert am 15. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all book and other debts owing to the company. (For full details see form 395, tc ref: M286C).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 20. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Okt. 1988
    Geliefert am 25. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 20. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 1988
    Geliefert am 13. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The R H Group Limited
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 20. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Mai 1987
    Geliefert am 14. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    Floating charge
    Erstellt am 03. Apr. 1987
    Geliefert am 07. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing the liability and future potential liability of r h freight (mersey) limited and the R.H. group limited in respect of the rent and covenants contained in 3 sub under-leases dated 20.9.74 22.11.77 & 4.8.78
    Kurze Angaben
    First floating charge over the company (see doc). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • R H Freight (Mersey) Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    • 20. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 06. Dez. 1985
    Geliefert am 12. Dez. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book & other debts due owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1985Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 08. Juni 1984
    Geliefert am 13. Juni 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over (see doc M15). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 1984Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0