RH FREEPORT WAREHOUSING LTD
Überblick
| Unternehmensname | RH FREEPORT WAREHOUSING LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01771843 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?
- Güterkraftverkehr (49410) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kuehne+Nagel House Sunrise Parkway Linford Wood MK14 6BW Milton Keynes United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MERSEY FREIGHT SERVICES (MTL) LTD | 07. Aug. 1985 | 07. Aug. 1985 |
| MERSEY FREIGHT SERVICES LIMITED | 22. Nov. 1983 | 22. Nov. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tim Scharwath als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lenton Lane Nottingham NG7 2NR am 11. Mai 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Tim Scharwath als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Thierry Patrick Held als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Baxter als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Baxter als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Rafferty als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Rafferty als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Isler als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Robert Layton als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter James Isler am 09. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RH FREEPORT WAREHOUSING LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYTON, Robert | Sekretär | Sywell Road Holcot NN6 9SN Northampton Nutmeg Cottage Northamptonshire | British | 159459370001 | ||||||
| HELD, Thierry Patrick | Geschäftsführer | Florence Way Rockingham Road UB8 2LS Uxbridge 1 Union Business Park Middlesex | England | Swiss | 155850310001 | |||||
| CRANE, Roger Leonard Arthur | Sekretär | 19 Gillercomb Close West Bridgford NG2 6SE Nottingham | British | 18196300002 | ||||||
| RAFFERTY, Steven | Sekretär | 5a Ashford Road LE10 0JL Hinckley Leicestershire | British | 86477730001 | ||||||
| BAXTER, Andrew Neville | Geschäftsführer | Moor House Old North Road South Muskham NG23 6DX Newark Nottinghamshire | England | British | 107002860001 | |||||
| BAXTER, Ian John Robert | Geschäftsführer | Church Lane NG13 9HG Langar Langar House Nottinghamshire | England | British | 20757760004 | |||||
| BAXTER, Neville Alfred | Geschäftsführer | Wellow Park House Bleasby NG14 7GH Nottingham Nottinghamshire | England | British | 1639600001 | |||||
| CRANE, Roger Leonard Arthur | Geschäftsführer | 19 Gillercomb Close West Bridgford NG2 6SE Nottingham | British | 18196300002 | ||||||
| GOODRICK, Howard Vivian | Geschäftsführer | Lark Cottage West End, Lund YO25 9TN Driffield North Humberside | England | British | 10050160002 | |||||
| ISLER, Peter James | Geschäftsführer | Southfield Farm House The Clays LN5 0RW Brant Broughton Lincolnshire | United Kingdom | British | 82518660002 | |||||
| JARVIS, Terence | Geschäftsführer | 27 Chester Avenue PR9 7ET Southport Merseyside | British | 39724000001 | ||||||
| RAFFERTY, Steven | Geschäftsführer | 5a Ashford Road LE10 0JL Hinckley Leicestershire | United Kingdom | British | 86477730001 | |||||
| SCHARWATH, Tim | Geschäftsführer | Florence Way Rockingham Road UB8 2LS Uxbridge 1 Union Business Park Middlesex | England | British | 159736860001 | |||||
| STOKES, Mark Bryan | Geschäftsführer | Stoneleigh House Main Road Anslow DE13 9QE Burton On Trent Staffordshire | British | 74798060003 |
Hat RH FREEPORT WAREHOUSING LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 30. Dez. 2010 Geliefert am 31. Dez. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Dez. 2010 Geliefert am 21. Dez. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Feb. 1994 Geliefert am 01. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge. | Erstellt am 25. Juni 1991 Geliefert am 15. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge over all book and other debts owing to the company. (For full details see form 395, tc ref: M286C). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Okt. 1988 Geliefert am 25. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1988 Geliefert am 13. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 1987 Geliefert am 14. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 03. Apr. 1987 Geliefert am 07. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing the liability and future potential liability of r h freight (mersey) limited and the R.H. group limited in respect of the rent and covenants contained in 3 sub under-leases dated 20.9.74 22.11.77 & 4.8.78 | |
Kurze Angaben First floating charge over the company (see doc). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 06. Dez. 1985 Geliefert am 12. Dez. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book & other debts due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 08. Juni 1984 Geliefert am 13. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over (see doc M15). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0