CSE INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCSE INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01773360
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CSE INTERNATIONAL LIMITED?

    • Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich CSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4th Floor Springfield House
    76 Wellington Street
    LS1 2AY Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CENTRE FOR SOFTWARE ENGINEERING LIMITED(THE)09. Feb. 198409. Feb. 1984
    DRAMVOGUE LIMITED28. Nov. 198328. Nov. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für CSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Aug. 2016

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Aug. 2015

    16 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6Th Floor 2 Wellington Place Leeds LS1 4AP zum 4Th Floor Springfield House 76 Wellington Street Leeds LS1 2AY am 28. Okt. 2014

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Aug. 2014

    17 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order - replacement of liquidator
    7 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Sovereign House Queensway Court Business Park Scunthorpe N Lincs DN16 1AD England* am 27. Aug. 2013

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Nov. 2012

    Kapitalaufstellung am 09. Nov. 2012

    • Kapital: GBP 93,334
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2012

    7 SeitenAA

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2011

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Karen Marshall als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Karen Marshall als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010

    7 SeitenAA

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Bellwin Drive Flixborough Scunthorpe DN15 8SN* am 30. Nov. 2009

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von CSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOWNING, Keith Michael
    Ainsdale Crescent
    HA5 5SF Pinner
    25
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Ainsdale Crescent
    HA5 5SF Pinner
    25
    Middlesex
    EnglandBritish127934940002
    MCCARTNEY, Alan
    Normanby Road
    DN15 9AD Thealby
    The Dairy Evan's Yard
    North Lincs
    Geschäftsführer
    Normanby Road
    DN15 9AD Thealby
    The Dairy Evan's Yard
    North Lincs
    United KingdomBritish118583390002
    BENNETT, Kathryn Margaret
    2 Brigg Road
    Broughton
    DN20 0JW Brigg
    South Humberside
    Sekretär
    2 Brigg Road
    Broughton
    DN20 0JW Brigg
    South Humberside
    British22664910001
    BENNETT, Philip Anthony, Dr
    2 Brigg Road
    Broughton
    DN20 0JW Brigg
    South Humberside
    Sekretär
    2 Brigg Road
    Broughton
    DN20 0JW Brigg
    South Humberside
    British22664920001
    DICKINSON, David James
    Meadow House
    Bishopthorpe
    YO23 2UF York
    North Yorkshire
    Sekretär
    Meadow House
    Bishopthorpe
    YO23 2UF York
    North Yorkshire
    British113148670001
    EYRE, Andrew John Duncan
    10 Stratford Way
    Huntington
    YO32 9YW York
    North Yorkshire
    Sekretär
    10 Stratford Way
    Huntington
    YO32 9YW York
    North Yorkshire
    British18139080004
    GUILDER, Neil Mark
    52 Meadow Road
    Garforth
    LS25 2EN Leeds
    Sekretär
    52 Meadow Road
    Garforth
    LS25 2EN Leeds
    British50828820001
    MARSHALL, Karen Patricia
    York Road
    Cliffe
    YO8 6NU Selby
    Meadow House
    North Yorkshire
    Sekretär
    York Road
    Cliffe
    YO8 6NU Selby
    Meadow House
    North Yorkshire
    British84769000002
    BENNETT, Kathryn Margaret
    2 Brigg Road
    Broughton
    DN20 0JW Brigg
    South Humberside
    Geschäftsführer
    2 Brigg Road
    Broughton
    DN20 0JW Brigg
    South Humberside
    British22664910001
    BENNETT, Philip Anthony, Dr
    The Old Manor House
    2 Riverside
    DN21 3UG Scotter
    North Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Old Manor House
    2 Riverside
    DN21 3UG Scotter
    North Lincolnshire
    EnglandBritish185040400001
    BROWN, Michael John Douglas, Air Vice-Marshall
    2 Carters Close
    PE3 9AW South Bretton
    Peterborough
    Geschäftsführer
    2 Carters Close
    PE3 9AW South Bretton
    Peterborough
    British36474710002
    DICKSON, David James
    Meadow House
    Moor Lane Bishopthorpe
    YO23 2UF York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Meadow House
    Moor Lane Bishopthorpe
    YO23 2UF York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish5907730002
    EYRE, Andrew John Duncan
    10 Stratford Way
    Huntington
    YO32 9YW York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Stratford Way
    Huntington
    YO32 9YW York
    North Yorkshire
    EnglandBritish18139080004
    FOX, John Brett
    17 Rectory Gardens
    Todwick
    S26 1JU Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    17 Rectory Gardens
    Todwick
    S26 1JU Sheffield
    South Yorkshire
    British109109560001
    MARSHALL, Karen Patricia
    York Road
    Cliffe
    YO8 6NU Selby
    Meadow House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    York Road
    Cliffe
    YO8 6NU Selby
    Meadow House
    North Yorkshire
    EnglandBritish84769000002
    MAY, Rodney, Dr
    Craigmount 16 Church Street
    DN21 5DG Glentworth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Craigmount 16 Church Street
    DN21 5DG Glentworth
    Lincolnshire
    British58133370001
    NUSSEY, Ian David
    Cidermill Farmhouse
    Ardens Grafton
    B49 6DS Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Cidermill Farmhouse
    Ardens Grafton
    B49 6DS Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish12912920001
    O'CONNOR, Terence Patrick
    2 Longacre Close
    GU33 7UZ Liss
    Hampshire
    Geschäftsführer
    2 Longacre Close
    GU33 7UZ Liss
    Hampshire
    British74068290002
    TILL, Ian Jeremy
    21 Hamilton Way
    Acomb
    YO24 4LE York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    21 Hamilton Way
    Acomb
    YO24 4LE York
    North Yorkshire
    British7916010001
    WHITFIELD, Paul
    Field House
    Walkmill Eccleshall
    ST21 6ER Stafford
    Geschäftsführer
    Field House
    Walkmill Eccleshall
    ST21 6ER Stafford
    British74068310002

    Hat CSE INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over credit balances
    Erstellt am 26. Aug. 1999
    Geliefert am 03. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of land transport authority for $89,911.15 singapore dollars
    Kurze Angaben
    The sum of $89,911.15 singapore dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 409-01-08038961 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 26. Aug. 1999
    Geliefert am 03. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of land transport authority for $104,318.35 singapore dollars
    Kurze Angaben
    The sum of $104,318.35 singapore dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 409-01-08038953 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 09. Aug. 1999
    Geliefert am 23. Aug. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 24. Mai 1999
    Geliefert am 02. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of land transport authority for singapore $ 104,318.35
    Kurze Angaben
    Sum of singapore $ 104,318.35 with interest to be held by the bank on account no 409/01/08038961 and earmarked or designated by breference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 24. Mai 1999
    Geliefert am 28. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of land transport authority for $89,911.15 (singapore dollars)
    Kurze Angaben
    The sum of $89,911.15 (singapore dollars) together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 409- 01-08038953.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 25. Jan. 1996
    Geliefert am 15. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to perfomance bond dated 25TH january 1996 in favour of hong kong airport authority for one million hong kong dollars
    Kurze Angaben
    The sum of one million hong kong dollars together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 338/01/06010180 with reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Apr. 1990
    Geliefert am 17. Apr. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 2ND floor glenford house bellwin drive flixborough scunthorpe and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 1988
    Geliefert am 02. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing sterling pounds 126,666 and all other moneys due & to become due from the company to the charge under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    L/Hold property k/as bellwin drive flixborough scunthorpe south humberside t/n hs 97121 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant & machinery from time to time an that property. Fixed charge goodill and uncalled capital see doc m 343 for full details.
    Berechtigte Personen
    • W J Shepherd Building Group Limited
    Transaktionen
    • 02. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 29. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. Aug. 1987
    Geliefert am 25. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A charge by way of legal mortgage over bellwin drive, flixborough, glanford, humbersie title no hs 97121 and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    • 10. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 1985
    Geliefert am 19. Apr. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1985Registrierung einer Belastung

    Hat CSE INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Aug. 2013Beginn der Liquidation
    24. Jan. 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    William Duncan
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    West Yorkshire
    Keith Allan Marshall
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    2 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    West Yorkshire
    Adrian David Allen
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HF Leeds
    Praktiker
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HF Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0