CSE INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CSE INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01773360 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CSE INTERNATIONAL LIMITED?
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich CSE INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor Springfield House 76 Wellington Street LS1 2AY Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CSE INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CENTRE FOR SOFTWARE ENGINEERING LIMITED(THE) | 09. Feb. 1984 | 09. Feb. 1984 |
| DRAMVOGUE LIMITED | 28. Nov. 1983 | 28. Nov. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CSE INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CSE INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 18 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Aug. 2016 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Aug. 2015 | 16 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 6Th Floor 2 Wellington Place Leeds LS1 4AP zum 4Th Floor Springfield House 76 Wellington Street Leeds LS1 2AY am 28. Okt. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Aug. 2014 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:court order - replacement of liquidator | 7 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 2 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Sovereign House Queensway Court Business Park Scunthorpe N Lincs DN16 1AD England* am 27. Aug. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 7 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karen Marshall als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karen Marshall als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Bellwin Drive Flixborough Scunthorpe DN15 8SN* am 30. Nov. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CSE INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWNING, Keith Michael | Geschäftsführer | Ainsdale Crescent HA5 5SF Pinner 25 Middlesex | England | British | 127934940002 | |||||
| MCCARTNEY, Alan | Geschäftsführer | Normanby Road DN15 9AD Thealby The Dairy Evan's Yard North Lincs | United Kingdom | British | 118583390002 | |||||
| BENNETT, Kathryn Margaret | Sekretär | 2 Brigg Road Broughton DN20 0JW Brigg South Humberside | British | 22664910001 | ||||||
| BENNETT, Philip Anthony, Dr | Sekretär | 2 Brigg Road Broughton DN20 0JW Brigg South Humberside | British | 22664920001 | ||||||
| DICKINSON, David James | Sekretär | Meadow House Bishopthorpe YO23 2UF York North Yorkshire | British | 113148670001 | ||||||
| EYRE, Andrew John Duncan | Sekretär | 10 Stratford Way Huntington YO32 9YW York North Yorkshire | British | 18139080004 | ||||||
| GUILDER, Neil Mark | Sekretär | 52 Meadow Road Garforth LS25 2EN Leeds | British | 50828820001 | ||||||
| MARSHALL, Karen Patricia | Sekretär | York Road Cliffe YO8 6NU Selby Meadow House North Yorkshire | British | 84769000002 | ||||||
| BENNETT, Kathryn Margaret | Geschäftsführer | 2 Brigg Road Broughton DN20 0JW Brigg South Humberside | British | 22664910001 | ||||||
| BENNETT, Philip Anthony, Dr | Geschäftsführer | The Old Manor House 2 Riverside DN21 3UG Scotter North Lincolnshire | England | British | 185040400001 | |||||
| BROWN, Michael John Douglas, Air Vice-Marshall | Geschäftsführer | 2 Carters Close PE3 9AW South Bretton Peterborough | British | 36474710002 | ||||||
| DICKSON, David James | Geschäftsführer | Meadow House Moor Lane Bishopthorpe YO23 2UF York North Yorkshire | United Kingdom | British | 5907730002 | |||||
| EYRE, Andrew John Duncan | Geschäftsführer | 10 Stratford Way Huntington YO32 9YW York North Yorkshire | England | British | 18139080004 | |||||
| FOX, John Brett | Geschäftsführer | 17 Rectory Gardens Todwick S26 1JU Sheffield South Yorkshire | British | 109109560001 | ||||||
| MARSHALL, Karen Patricia | Geschäftsführer | York Road Cliffe YO8 6NU Selby Meadow House North Yorkshire | England | British | 84769000002 | |||||
| MAY, Rodney, Dr | Geschäftsführer | Craigmount 16 Church Street DN21 5DG Glentworth Lincolnshire | British | 58133370001 | ||||||
| NUSSEY, Ian David | Geschäftsführer | Cidermill Farmhouse Ardens Grafton B49 6DS Alcester Warwickshire | England | British | 12912920001 | |||||
| O'CONNOR, Terence Patrick | Geschäftsführer | 2 Longacre Close GU33 7UZ Liss Hampshire | British | 74068290002 | ||||||
| TILL, Ian Jeremy | Geschäftsführer | 21 Hamilton Way Acomb YO24 4LE York North Yorkshire | British | 7916010001 | ||||||
| WHITFIELD, Paul | Geschäftsführer | Field House Walkmill Eccleshall ST21 6ER Stafford | British | 74068310002 |
Hat CSE INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over credit balances | Erstellt am 26. Aug. 1999 Geliefert am 03. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of land transport authority for $89,911.15 singapore dollars | |
Kurze Angaben The sum of $89,911.15 singapore dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 409-01-08038961 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 26. Aug. 1999 Geliefert am 03. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of land transport authority for $104,318.35 singapore dollars | |
Kurze Angaben The sum of $104,318.35 singapore dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 409-01-08038953 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 09. Aug. 1999 Geliefert am 23. Aug. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 24. Mai 1999 Geliefert am 02. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of land transport authority for singapore $ 104,318.35 | |
Kurze Angaben Sum of singapore $ 104,318.35 with interest to be held by the bank on account no 409/01/08038961 and earmarked or designated by breference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 24. Mai 1999 Geliefert am 28. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of land transport authority for $89,911.15 (singapore dollars) | |
Kurze Angaben The sum of $89,911.15 (singapore dollars) together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 409- 01-08038953. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 25. Jan. 1996 Geliefert am 15. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to perfomance bond dated 25TH january 1996 in favour of hong kong airport authority for one million hong kong dollars | |
Kurze Angaben The sum of one million hong kong dollars together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 338/01/06010180 with reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. Apr. 1990 Geliefert am 17. Apr. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 2ND floor glenford house bellwin drive flixborough scunthorpe and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 1988 Geliefert am 02. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing sterling pounds 126,666 and all other moneys due & to become due from the company to the charge under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/Hold property k/as bellwin drive flixborough scunthorpe south humberside t/n hs 97121 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant & machinery from time to time an that property. Fixed charge goodill and uncalled capital see doc m 343 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 14. Aug. 1987 Geliefert am 25. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A charge by way of legal mortgage over bellwin drive, flixborough, glanford, humbersie title no hs 97121 and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 1985 Geliefert am 19. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CSE INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0