INNOVATE RAIL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINNOVATE RAIL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01774174
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INNOVATE RAIL LIMITED?

    • (6312) /

    Wo befindet sich INNOVATE RAIL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BDO STOY HAYWARD LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INNOVATE RAIL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ROUNDOAK RAIL LIMITED30. Nov. 198330. Nov. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INNOVATE RAIL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für INNOVATE RAIL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Juni 2010

    5 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    9 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Dez. 2008

    57 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten288b

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    187 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2006

    17 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von INNOVATE RAIL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EVANS, Ralph Anthony
    Grace House 90 Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6JU York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Grace House 90 Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6JU York
    North Yorkshire
    EnglandBritish48052490002
    DAVEY, Ian Harding
    53 Cromwell Road
    DN35 0AU Cleethorpes
    South Humberside
    Sekretär
    53 Cromwell Road
    DN35 0AU Cleethorpes
    South Humberside
    British2052870001
    DIBDIN, Doris
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    Sekretär
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    British3187700001
    CLARK, Robert William
    Primrose Cottage Prestwood
    DY7 5AN Stourbridge
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Primrose Cottage Prestwood
    DY7 5AN Stourbridge
    Staffordshire
    British61948360001
    DARGAVEL, Stephen Geoffrey
    Ranelagh Gardens
    SW6 3PA London
    Suite 08 Hurlingham Studios
    Geschäftsführer
    Ranelagh Gardens
    SW6 3PA London
    Suite 08 Hurlingham Studios
    British40896630002
    DIBDIN, Doris
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    Geschäftsführer
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    United KingdomBritish3187700001
    DIBDIN, Thomas Peter
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    Geschäftsführer
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    EnglandBritish33893060002
    JACKSON, Paul
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish40294740001
    OSBORNE, Peter Gordon
    25 Scrooby Street
    S61 4PH Rotherham
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    25 Scrooby Street
    S61 4PH Rotherham
    South Yorkshire
    British94197700011
    SAVAGE, Stephen John
    The Old Vicarage
    1 Church Street Caistor
    LN8 3ET Market Rasen
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    1 Church Street Caistor
    LN8 3ET Market Rasen
    Lincolnshire
    EnglandBritish42339130002
    STITCHMAN, John Adam
    Apartment 610 The Litmus Building
    195 Huntingdon Street
    NG1 3NX Nottingham
    Geschäftsführer
    Apartment 610 The Litmus Building
    195 Huntingdon Street
    NG1 3NX Nottingham
    British125897930001
    YOUNG, Michael
    1 Avenue Road
    DE56 4DW Duffield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    1 Avenue Road
    DE56 4DW Duffield
    Derbyshire
    United KingdomBritish126009380001

    Hat INNOVATE RAIL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from innovate rail limited innovate holdings limited innovate phil hanley limited corby chilled distribution limited corby chilled distribution (northern) limited corby chilled distribution (scotland) LTD and eimskipafelag islands ehf to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Glitnir Banki Hf as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 12. Jan. 2006
    Geliefert am 13. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 10. Nov. 2004
    Geliefert am 17. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit agreement
    Erstellt am 04. Apr. 2001
    Geliefert am 12. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and the lease of even date
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert John Hugo Randall and David John George Royds
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Jan. 2001
    Geliefert am 31. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property former marconi works deykin avenue birmingham. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Mai 1988
    Geliefert am 07. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See doc for details.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Tsb England and Wales PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 17. Juni 1987
    Geliefert am 29. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    For details see form 395 doc. M52.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 29. Aug. 1985
    Geliefert am 03. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing £62,610 and all other monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    Two volvo bm 4300B articulated loading shovels with hydraulic attachment brackets pt. No. 90271, hi-tip buckets 4.3 cu.M. Pt. No. 99795 machine numbers chassis 5644 engine 64916. chassis 5645 engine 64925.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Leasing LTD
    • Lloyds Bowmaker Equipment Leasing LTD
    • Lloyds Bowmaker LTD
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    • 19. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat INNOVATE RAIL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Juni 2009Ende der Verwaltung
    30. Juni 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    DatumTyp
    16. Juni 2011Aufgelöst am
    30. Juni 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0