MILLFOLD GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMILLFOLD GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01778615
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MILLFOLD GROUP LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich MILLFOLD GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MILLFOLD GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EAGA HOME SERVICES LIMITED11. Jan. 200711. Jan. 2007
    MICO GROUP LIMITED15. Nov. 200615. Nov. 2006
    MICO GROUP LIMITED23. Mai 200323. Mai 2003
    MILLFOLD GROUP LIMITED25. Sept. 200225. Sept. 2002
    MILLFOLD PROPERTIES LIMITED16. Dez. 198316. Dez. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MILLFOLD GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für MILLFOLD GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Partnership House City West Business Park Scotswood Road Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE4 7DF am 25. Juli 2011

    1 SeitenAD01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Beendigung der Bestellung von Christopher Judd als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Timothy Francis George als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Mai 2011 bis 30. Nov. 2011

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2010

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Michael Mcmahon als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Neil Spann als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 04. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 54,757
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2009

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Mcmahon am 11. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Christopher Judd am 11. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2008

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed eaga home services LIMITED\certificate issued on 03/06/08
    3 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2007

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von MILLFOLD GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GEORGE, Timothy Francis
    Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Blackbarn House
    Worcestershire
    United Kingdom
    Sekretär
    Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Blackbarn House
    Worcestershire
    United Kingdom
    161208870001
    SPANN, Neil
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector154870250001
    COX, William John Hallam
    School House Worksop Road
    Thorpe Salvin
    S80 3JP Worksop
    Nottinghamshire
    Sekretär
    School House Worksop Road
    Thorpe Salvin
    S80 3JP Worksop
    Nottinghamshire
    British16227680001
    JUDD, Christopher
    City West Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7DF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne & Wear
    Sekretär
    City West Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7DF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne & Wear
    British69049410002
    LINTON, David Glyn
    13 Bachelors Lane
    Chester
    CH3 5XD Cheshire
    Sekretär
    13 Bachelors Lane
    Chester
    CH3 5XD Cheshire
    British96201780001
    COX, Margaret Ann
    The School House
    Thorpe Salvin
    S80 3JP Worksop
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The School House
    Thorpe Salvin
    S80 3JP Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritishSchool Matron115566220001
    COX, Richard John
    10 Riverdale Drive
    Earlsfield
    SW18 4UR London
    Geschäftsführer
    10 Riverdale Drive
    Earlsfield
    SW18 4UR London
    BritishDirector17909640002
    COX, William John Hallam
    School House Worksop Road
    Thorpe Salvin
    S80 3JP Worksop
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    School House Worksop Road
    Thorpe Salvin
    S80 3JP Worksop
    Nottinghamshire
    Uk ResidentBritishDirector16227680001
    HICKTON, Julie Ann
    9 Redwing Close
    S81 8UR Gateford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    9 Redwing Close
    S81 8UR Gateford
    Nottinghamshire
    BritishPersonal Manager83167730001
    HODGES, David
    Laburnum House
    West Thirston
    NE65 9EF Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Laburnum House
    West Thirston
    NE65 9EF Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector103341630001
    JOHNSON, Joseph Andrew
    Glenshotton
    West Thirston
    NE65 9QD Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Glenshotton
    West Thirston
    NE65 9QD Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector69508510004
    MCLEOD, Ian Daniel
    NE43
    Geschäftsführer
    NE43
    United KingdomBritishDirector109419030001
    MCMAHON, Michael
    City West Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7DF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    City West Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7DF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector112505130001
    VARLEY, Paul Richard
    Westsyde
    Ponteland
    NE20 9LS Newcastle Upon Tyne
    28
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Westsyde
    Ponteland
    NE20 9LS Newcastle Upon Tyne
    28
    United Kingdom
    BritishDirector137984880001

    Hat MILLFOLD GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Aug. 1999
    Geliefert am 28. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north side of fitzwilliam road rotherham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juli 1999
    Geliefert am 22. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 11. Juni 1991
    Geliefert am 28. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000 and all monies due or to becombe due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    L/H land on the north side of fitzwitlliam roa,d rotherham county of south yorkslhire. T/n:- syk 281858.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Assurance Co LTD
    Transaktionen
    • 28. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 20. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 25. März 1991
    Geliefert am 04. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 11. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Juni 1989
    Geliefert am 12. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a galax building fitzwilliam road rotherham and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 11. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Dez. 1984
    Geliefert am 12. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings south east side of snail hill and north side of quarry hill rotherham, south yorkshire title no. Syk 8256 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    • 11. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Dez. 1984
    Geliefert am 12. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings lying to the north of the crofts rotherham, south yorkshire title no. Syk 107246 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    • 11. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Juli 1984
    Geliefert am 20. Juli 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H, don forge works sheffield road rotherham s yorks. And or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 1984Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Apr. 1984
    Geliefert am 03. Apr. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31 westgate rotherham south yorkshire. Title no. Syk 151199 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1984Registrierung einer Belastung
    • 11. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Apr. 1984
    Geliefert am 03. Apr. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    78 westgate rotherham south yorkshire. Title no. Syk 45795 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1984Registrierung einer Belastung
    • 11. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0