MILLFOLD GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MILLFOLD GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01778615 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MILLFOLD GROUP LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich MILLFOLD GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MILLFOLD GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
EAGA HOME SERVICES LIMITED | 11. Jan. 2007 | 11. Jan. 2007 |
MICO GROUP LIMITED | 15. Nov. 2006 | 15. Nov. 2006 |
MICO GROUP LIMITED | 23. Mai 2003 | 23. Mai 2003 |
MILLFOLD GROUP LIMITED | 25. Sept. 2002 | 25. Sept. 2002 |
MILLFOLD PROPERTIES LIMITED | 16. Dez. 1983 | 16. Dez. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MILLFOLD GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MILLFOLD GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Partnership House City West Business Park Scotswood Road Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE4 7DF am 25. Juli 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Judd als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy Francis George als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Mai 2011 bis 30. Nov. 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Mcmahon als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Spann als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Mcmahon am 11. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Christopher Judd am 11. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed eaga home services LIMITED\certificate issued on 03/06/08 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2007 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b |
Wer sind die Geschäftsführer von MILLFOLD GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGE, Timothy Francis | Sekretär | Main Street Bishampton WR10 2NH Pershore Blackbarn House Worcestershire United Kingdom | 161208870001 | |||||||
SPANN, Neil | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 154870250001 | ||||
COX, William John Hallam | Sekretär | School House Worksop Road Thorpe Salvin S80 3JP Worksop Nottinghamshire | British | 16227680001 | ||||||
JUDD, Christopher | Sekretär | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | British | 69049410002 | ||||||
LINTON, David Glyn | Sekretär | 13 Bachelors Lane Chester CH3 5XD Cheshire | British | 96201780001 | ||||||
COX, Margaret Ann | Geschäftsführer | The School House Thorpe Salvin S80 3JP Worksop Nottinghamshire | England | British | School Matron | 115566220001 | ||||
COX, Richard John | Geschäftsführer | 10 Riverdale Drive Earlsfield SW18 4UR London | British | Director | 17909640002 | |||||
COX, William John Hallam | Geschäftsführer | School House Worksop Road Thorpe Salvin S80 3JP Worksop Nottinghamshire | Uk Resident | British | Director | 16227680001 | ||||
HICKTON, Julie Ann | Geschäftsführer | 9 Redwing Close S81 8UR Gateford Nottinghamshire | British | Personal Manager | 83167730001 | |||||
HODGES, David | Geschäftsführer | Laburnum House West Thirston NE65 9EF Morpeth Northumberland | British | Director | 103341630001 | |||||
JOHNSON, Joseph Andrew | Geschäftsführer | Glenshotton West Thirston NE65 9QD Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | Director | 69508510004 | ||||
MCLEOD, Ian Daniel | Geschäftsführer | NE43 | United Kingdom | British | Director | 109419030001 | ||||
MCMAHON, Michael | Geschäftsführer | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | United Kingdom | British | Director | 112505130001 | ||||
VARLEY, Paul Richard | Geschäftsführer | Westsyde Ponteland NE20 9LS Newcastle Upon Tyne 28 United Kingdom | British | Director | 137984880001 |
Hat MILLFOLD GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Erstellt am 26. Aug. 1999 Geliefert am 28. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the north side of fitzwilliam road rotherham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Juli 1999 Geliefert am 22. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 11. Juni 1991 Geliefert am 28. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 and all monies due or to becombe due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben L/H land on the north side of fitzwitlliam roa,d rotherham county of south yorkslhire. T/n:- syk 281858. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 25. März 1991 Geliefert am 04. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 21. Juni 1989 Geliefert am 12. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a galax building fitzwilliam road rotherham and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Dez. 1984 Geliefert am 12. Dez. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings south east side of snail hill and north side of quarry hill rotherham, south yorkshire title no. Syk 8256 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Dez. 1984 Geliefert am 12. Dez. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings lying to the north of the crofts rotherham, south yorkshire title no. Syk 107246 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. Juli 1984 Geliefert am 20. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H, don forge works sheffield road rotherham s yorks. And or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 03. Apr. 1984 Geliefert am 03. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 31 westgate rotherham south yorkshire. Title no. Syk 151199 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 03. Apr. 1984 Geliefert am 03. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 78 westgate rotherham south yorkshire. Title no. Syk 45795 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0