MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)

MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01784444
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Pinsent Masons Llp
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Part Ground & First Floor Two Parklands Great Park Rubery Birmingham B45 9PZ zum C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB am 20. Dez. 2017

    1 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Juli 2017

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Patricia Lesley Lee als Geschäftsführer am 31. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 29. Juni 2017

    • Kapital: GBP 0.01
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 28/06/2017
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 20. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 117.68
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 117.68
    SH01

    Ernennung von Ms Patricia Lesley Lee als Direktor am 22. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Albert Edward Smith als Geschäftsführer am 22. Okt. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 117.68
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Katharine Kandelaki als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 30. Juni 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 28 Welbeck Street London W1G 8EW* am 04. Okt. 2012

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MANSON, David Lindsay
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    England
    Geschäftsführer
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    England
    United KingdomBritishNone170602970001
    BENEY, Ralph Martin
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    Sekretär
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    BritishDirector Secretary85286690001
    BORG, Richard Joseph
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NP Welwyn
    Fulling Mill House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NP Welwyn
    Fulling Mill House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    BritishSolicitor121685170001
    KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    England
    Sekretär
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    England
    British171887510001
    SIDHU, Ranjit Singh
    Manor House
    Merton
    OX6 0NF Bicester
    Oxon
    Sekretär
    Manor House
    Merton
    OX6 0NF Bicester
    Oxon
    British6101150001
    BENEY, Ralph Martin
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    Geschäftsführer
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishDirector Secretary85286690001
    LEE, Patricia Lesley
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    Geschäftsführer
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    United KingdomBritishChief Executive192233540001
    SIDHU, Dhaminder Singh
    37 Whitefields Gate
    B91 3GE Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    37 Whitefields Gate
    B91 3GE Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director35895070001
    SIDHU, Kheshminder Singh
    29 Capel Close
    Summertown
    OX2 7LA Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    29 Capel Close
    Summertown
    OX2 7LA Oxford
    Oxfordshire
    BritishDoctor Of Medicine57465200001
    SIDHU, Ranjit Singh
    Manor House
    Merton
    OX6 0NF Bicester
    Oxon
    Geschäftsführer
    Manor House
    Merton
    OX6 0NF Bicester
    Oxon
    BritishCompany Director6101150001
    SIDHU, Sawinder Kaur
    The Manor House
    Merton
    OX6 Bicester
    Oxon
    Geschäftsführer
    The Manor House
    Merton
    OX6 Bicester
    Oxon
    EnglandBritishCompany Director21847670001
    SMITH, Albert Edward
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    England
    Geschäftsführer
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    England
    EnglandBritishNone77631340001
    SRINIVAS, Doraiswamy, Doctor
    63 Ashley Gardens
    SW1P 1QG Ambrosden Avenue
    London
    Geschäftsführer
    63 Ashley Gardens
    SW1P 1QG Ambrosden Avenue
    London
    United KingdomAmerican,BritishDirector85286410001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE)?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    06. Apr. 2016
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04556634
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE) Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 10. Dez. 2002
    Geliefert am 21. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by heatlthcare properties (oxford ) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that freehold land and buildings situate at and known as manor house nursing home merton bicester title number ON214669. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 10. Dez. 2002
    Geliefert am 18. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. März 2001
    Geliefert am 28. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 8 ash lane cherwell oxfordshire title number ON200181. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. März 2001
    Geliefert am 28. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 39 west hawthorn road cherwell oxfordshire title number ON200184. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. März 2001
    Geliefert am 28. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property 18 ash lane cherwell oxfordshire title number ON204466. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 28. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 37 west hawthorn road ambrosden cherwell oxfordshire. T/no. ON200183. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Aug. 1999
    Geliefert am 28. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Manor house nursing home merton nr bicester oxfordshire and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property..assigns the related rights..by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery..by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future..assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 28. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Aug. 1994
    Geliefert am 27. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & premises k/a the manor house nursing home merton oxford with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Residual floating charge
    Erstellt am 19. Aug. 1994
    Geliefert am 27. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture incorporating legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 1991
    Geliefert am 19. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All freehold or leasehold property at merton oxfordshire known as the manor house merton and pavitar nivas merton as the same are described in a conveynance dated 21.3.84 between R.S. sidher (1) the company (2) see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 11. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Nov. 1988
    Geliefert am 24. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2 west end merton bicester oxfordshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 29. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Sept. 1987
    Geliefert am 08. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the dove cote merton near bicester oxfordshire, and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 11. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Feb. 1987
    Geliefert am 06. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold plot of land adjoining crawshaw hall crawshawbooth rossendale lancashire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1987Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1986
    Geliefert am 29. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings see doc for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anz Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 07. Sept. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Sept. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Dez. 1986
    Geliefert am 29. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property situate at and known as the manor house merton near bicester oxfordshire OX6 0NF. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Anz Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 31. Okt. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Dez. 1984
    Geliefert am 09. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £230,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or R.S.sidhu and S.sidhu to the chargee.
    Kurze Angaben
    Legal charge over piece or parcel of land situate in the parish of merton oxford together with the messuage and out buildings or some part thereof known as the manor house, merton, nr. Bicester and the goodwill of the business floating charge upon the undertaking, all other property assets & rights present and future of the company.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Finance Company Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    • 17. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. März 1984
    Geliefert am 27. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property the manor house merton bicester oxfordshire and the proceedsof sale thereof. Together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 1984Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. März 1984
    Geliefert am 16. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. A fixed & floating charge over partwill & book debts. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 1984Registrierung einer Belastung

    Hat MANOR HOUSE NURSING HOME LIMITED(THE) Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Juli 2017Beginn der Liquidation
    02. Nov. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0