POLAMCO LIMITED
Überblick
Unternehmensname | POLAMCO LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01784597 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von POLAMCO LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich POLAMCO LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Company Secretariat Site H Faraday Road SN3 5HH Swindon United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von POLAMCO LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MONADCREST LIMITED | 20. Jan. 1984 | 20. Jan. 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von POLAMCO LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für POLAMCO LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. Mai 2021
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 017845970012 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 017845970011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 017845970015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 017845970013 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 017845970014 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 3 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von POLAMCO LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARKSDALE, Harold Gregory | Geschäftsführer | Site H Faraday Road SN3 5HH Swindon Company Secretariat United Kingdom | United States | American | Vp And Corporate Secretary | 194513550001 | ||||
BUGGY, Richard Mark | Geschäftsführer | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics United Kingdom | United States | American | Vice President Finance | 237634590001 | ||||
COOPER, Stephen Christopher | Geschäftsführer | Faraday Road SN3 5HH Swindon Teuk Ltd Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British | Shared Services Finance Director | 137882610001 | ||||
PAYNE, David John | Sekretär | 6 Constantine Court BA4 4TS Shepton Mallet Somerset | British | 102430220002 | ||||||
PAYNE, Kenneth George | Sekretär | 2 Old Tarnwell Stanton Drew BS39 4EA Bristol Avon | British | 5200850001 | ||||||
CHESSELLS, Arthur David, Sir | Geschäftsführer | Oakleigh Catts Hill TN6 3NQ Mark Cross East Sussex | England | British | Company Director | 39000870003 | ||||
COODE, Sally-Jane | Geschäftsführer | Paddock House Farleigh Wick BA15 2PU Bradford On Avon Wiltshire | British | Company Director | 5200870001 | |||||
PAYNE, David John | Geschäftsführer | Weston Lock Lower Bristol Road BA2 1EP Bath | England | British | Finance Director | 166432510001 | ||||
POLSON, Andrew David | Geschäftsführer | 102 Newbridge Hill BA1 3QB Bath | United Kingdom | British | Director | 44987880002 | ||||
POLSON, David Clive | Geschäftsführer | 18 Trossachs Drive Bathampton BA2 6RP Bath | England | British | Company Director | 5200880002 | ||||
SITES, Donald Wayne | Geschäftsführer | Site H Faraday Road SN3 5HH Swindon Company Secretariat United Kingdom | Usa | American | Vp Finance | 190543150001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei POLAMCO LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyco Electronics Uk Holdings Ltd | 06. Apr. 2016 | Dorcan SN3 5HH Swindon Faraday Road United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat POLAMCO LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 23. Jan. 2014 Geliefert am 31. Jan. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 27. Nov. 2013 Geliefert am 03. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 24. Okt. 2013 Geliefert am 31. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 12. Juni 2013 Geliefert am 14. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 10. Juni 2013 Geliefert am 14. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 03. Apr. 2013 Geliefert am 06. Apr. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Nakamura tome WT100MMY twin spindle multi axis cnc turning centre serial no.M105601. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 26. Feb. 2013 Geliefert am 07. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The goods: nakamura tome WT100MMY cnc turning centre, s/no: M105508 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Juni 2012 Geliefert am 20. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2011 Geliefert am 06. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 05. Juni 1998 Geliefert am 25. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a industrial premises weston lock lower bristol road bath. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 11. Apr. 1990 Geliefert am 23. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of assignment the plant machinery chattels or other equipment of the company yamayaki H400 horizontal machining centre serial no. 84013 located at avondale road bath (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of deposit account | Erstellt am 30. Apr. 1985 Geliefert am 02. Mai 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge upon all monies presently or from time to time standing to the credit of the company's seven day notice deposit account with the mortgagee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Apr. 1985 Geliefert am 02. Mai 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property on the north east side of avondale road, bath title no av 85757 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. Uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral debenture | Erstellt am 20. Aug. 1984 Geliefert am 22. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the polamco engineering limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. Apr. 1984 Geliefert am 07. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben And heritable property & assets in scotland please see doc M13. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0