HOLDFIELD LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHOLDFIELD LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01788946
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HOLDFIELD LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich HOLDFIELD LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOLDFIELD LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HOLDFIELD LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für HOLDFIELD LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Ernennung von Helen Christine Gordon als Direktor am 31. Dez. 2015

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Rolland Cunningham als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Greenwood als Geschäftsführer am 22. Dez. 2015

    2 SeitenTM01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL am 10. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Citygate St James' Boulevard Newcastle upon Tyne NE1 4JE zum 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB am 02. Dez. 2014

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 14. Nov. 2014

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 24. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Peter Couch als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 08. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Peter On am 29. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mark Greenwood am 13. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Rolland Cunningham am 10. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Nicholas Mark Fletcher Jopling am 02. Feb. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Nicholas Peter On am 22. Dez. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Nicholas Peter On am 17. Mai 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von HOLDFIELD LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Sekretär
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    GORDON, Helen Christine
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish59902650001
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritish60099210004
    ON, Nicholas Peter
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritish135860930002
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Sekretär
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    MCDONNELL, David Croft
    Burnlea
    18 The Serpentine
    L19 9DT Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    Burnlea
    18 The Serpentine
    L19 9DT Liverpool
    Merseyside
    British3569220001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Geschäftsführer
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritish156117090001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish74581390003
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Geschäftsführer
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    GREENWOOD, Mark
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish154194730002
    HANLON, Keith
    Rookery Cottage
    Hillock Lane
    WN8 7RJ Dalton Nr Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Rookery Cottage
    Hillock Lane
    WN8 7RJ Dalton Nr Wigan
    Lancashire
    British32810060001
    MCDONNELL, David Croft
    Burnlea
    18 The Serpentine
    L19 9DT Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Burnlea
    18 The Serpentine
    L19 9DT Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish3569220001
    WINDLE, Michael Patrick
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish43646700001

    Hat HOLDFIELD LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Feb. 2002
    Geliefert am 09. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22 seddon st,st helens,WA10 6NU; t/no ms 236469; all fixtures,fixed plant and machinery thereon; fixed equitable charge over the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC and the Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2001
    Geliefert am 30. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property being 60 devon street st helens title number LA260454. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Mai 2001
    Geliefert am 25. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Mai 2001
    Geliefert am 03. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    49 ireland road, haydock, t/no MS294582. By way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC and the Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Mai 2001
    Geliefert am 22. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at 72 borough road st helens WA10 3TA t/n MS290850 by way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Apr. 2001
    Geliefert am 02. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    66 lord street st helens. T/no. LA217090 by way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Apr. 2001
    Geliefert am 02. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21 owen street st helens. T/no. LA211067 by way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 1994
    Geliefert am 29. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/as 36A island road, garston, liverpool L19 t/no MS328945. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales
    Transaktionen
    • 29. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Juni 1994
    Geliefert am 29. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales
    Transaktionen
    • 29. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Apr. 1993
    Geliefert am 06. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property formerly the police station now k/a 108 lawrence road liverpool t/no ms 156577 & all movable plant & machinery implements utensils equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Juni 1992
    Geliefert am 05. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    51 fern grove liverpool merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 14. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4, grasmere ave st. Helens merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 14. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3, lynton grove, st. Helens, merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 14. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    262 & 266 bele green lane, wigan grtr manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 14. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    58 cornice rd, liverpool, merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 14. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Nos 55,59,65,75,83 & 87 pitt st, st helens, merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 14. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    93, enfield st, lamberhead, green, pemberton wigan grtr manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 14. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    34, bentley st, st. Helens, merseyside.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Nov. 1987
    Geliefert am 27. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H properties 57 and 59 aughton road birkdale southport merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC.
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Juli 1987
    Geliefert am 16. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    36, island road, garston liverpool-. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Apr. 1987
    Geliefert am 15. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    64, whitehedge road, liverpool 19.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Apr. 1987
    Geliefert am 15. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22, bonsall road, liverpool 12.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Apr. 1987
    Geliefert am 15. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    17, windbourne rd, liverpool 14 -. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 1984
    Geliefert am 18. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    & heritable property in scotland (see doc M9).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 1984Registrierung einer Belastung

    Hat HOLDFIELD LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Feb. 2016Aufgelöst am
    14. Nov. 2014Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0