BRADLEY COURT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRADLEY COURT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01791944 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRADLEY COURT LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BRADLEY COURT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRADLEY COURT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LASTFLOW LIMITED | 15. Feb. 1984 | 15. Feb. 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRADLEY COURT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRADLEY COURT LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BRADLEY COURT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Maple Court, Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Maple Court, Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford Herts WD24 4QQ zum 1 More London Place London SE1 2AF am 27. Aug. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Mai 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr James Owen Percival als Direktor am 11. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Wilson als Geschäftsführer am 11. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Jonathan Way als Geschäftsführer am 29. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Jane Rabin als Geschäftsführer am 13. Juni 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr. Stuart Beasley als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Humphreys als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Brian Wilson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRADLEY COURT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLT SECRETARY LIMITED | Sekretär | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 125128960001 | |||||||
| BEASLEY, Stuart | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 188237620001 | |||||
| PERCIVAL, James Owen | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 161274380001 | |||||
| MACKAY, William Donald | Sekretär | 79 Tweedsmuir Road G52 2RX Glasgow | British | 796730001 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Ross | Sekretär | Highwood PA13 4TA Kilmacolm Refrewshire | British | 25359180002 | ||||||
| WILSON, Brian | Sekretär | Tudor Cottage 70 High Street, Eaton Bray LU6 2DP Dunstable | British | 125151140001 | ||||||
| LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 60530770001 | |||||||
| BOWCOCK, Philip Hedley | Geschäftsführer | East Barn Glory Hill Farm HP9 1XE Beaconsfield Bucks | British | 111188430001 | ||||||
| CHISMAN, Ronald Neil | Geschäftsführer | 1 Beaufort Close SW15 3TL London | United Kingdom | British | 780950001 | |||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Geschäftsführer | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| HUMPHREYS, Stephen | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | British | 71438830004 | ||||||
| JAMES, Paul Frederick | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | British | 48791500001 | ||||||
| LICHMAN, Laurence | Geschäftsführer | 209 Merry Hill Road WD23 1AP Bushey Hertfordshire | British | 143730380001 | ||||||
| MACKAY, William Donald | Geschäftsführer | 79 Tweedsmuir Road G52 2RX Glasgow | British | 796730001 | ||||||
| MICHELS, David Michael Charles | Geschäftsführer | 15 Court Drive HA7 4QH Stanmore Middlesex | British | 4855250001 | ||||||
| RABIN, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | England | British | 125139540001 | |||||
| THOMSON, Jonathan David | Geschäftsführer | 79 Hamlet Gardens Hammersmith W6 0SX London | British | 117323980001 | ||||||
| WAY, Mark Jonathan | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 191239860001 | |||||
| WILSON, Brian | Geschäftsführer | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 125151140001 | |||||
| LADBROKE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 62360460001 |
Hat BRADLEY COURT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 1991 Geliefert am 03. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 1991 Geliefert am 03. Sept. 1991 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and for the banks as defined in the deed on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 11. Nov. 1987 Geliefert am 26. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Ground at middleton hall, W. lothian, uphall and county of W. lothian. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. März 1987 Geliefert am 18. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as gateford hill house, worksop, nottinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Juni 1984 Geliefert am 02. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Apr. 1984 Geliefert am 02. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a bradley court, mitcheldean gloucestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BRADLEY COURT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0