WICKES DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWICKES DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01795477
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HEWAPOINT LIMITED28. Feb. 198428. Feb. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis27. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG zum C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX am 23. Sept. 2022

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 12. Sept. 2022

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Notification of Travis Perkins Financing Company No.3 Limited as a person with significant control on 06. Sept. 2022

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Wickes Properties Limited as a person with significant control on 06. Sept. 2022

    1 SeitenPSC07

    Ernennung von Tp Directors Ltd als Direktor am 27. Juni 2022

    2 SeitenAP02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Dez. 2020

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2019

    20 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2018

    20 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von John Peter Carter als Geschäftsführer am 01. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2017

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    18 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Anthony David Buffin als Geschäftsführer am 11. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Alan Richard Williams als Direktor am 11. Juli 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2015

    18 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    England
    Sekretär
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer8929285
    186000060001
    WILLIAMS, Alan Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137582690004
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer03480295
    191205550001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Sekretär
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Sekretär
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BAMFORD, Carmel
    36 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    Geschäftsführer
    36 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    British17771540001
    BHOTE, Sanaya Homi
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    British72716110002
    BIRD, Jeremy
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Geschäftsführer
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish111434190001
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Geschäftsführer
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Geschäftsführer
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    EnglandBritish178011680002
    CARTER, John Peter
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Geschäftsführer
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    CORNER, Michael Richmond
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    Geschäftsführer
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    British21206150001
    EDWARDS, Fred
    2 Moreland Drive
    SL9 8BB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Moreland Drive
    SL9 8BB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British75885570002
    FRIEDMAN, Douglas Benjamin
    46 Lankaster Gardens
    N2 9AJ London
    Geschäftsführer
    46 Lankaster Gardens
    N2 9AJ London
    American15200060001
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    JONES, Paul Samuel
    Brooklyn Newell Green
    Warfield
    RG42 6AJ Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Brooklyn Newell Green
    Warfield
    RG42 6AJ Bracknell
    Berkshire
    British75187050001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Geschäftsführer
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    THACKER, Colin David
    Old Place Farm
    Birling Road Ryarsh
    ME19 5JS West Malling
    Kent
    Geschäftsführer
    Old Place Farm
    Birling Road Ryarsh
    ME19 5JS West Malling
    Kent
    United KingdomBritish39672600001
    THOMAS, Geoffrey John
    8 Stanbrooke Way Church Lane
    Yielden
    MK44 1AU Bedford
    North Bedfordshire
    Geschäftsführer
    8 Stanbrooke Way Church Lane
    Yielden
    MK44 1AU Bedford
    North Bedfordshire
    British42980950001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    06. Sept. 2022
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer07180292
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Wickes Properties Limited
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    06. Apr. 2016
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer1406897
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat WICKES DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A mezzanine debenture
    Erstellt am 28. Juli 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Senior security accession deed
    Erstellt am 29. Jan. 2003
    Geliefert am 13. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Retained land at high rd,goodmayes,redbridge known as 1-4 railway cottages and land/blds on south-east side of high rd,chadwell heath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordinated security accession deed
    Erstellt am 29. Jan. 2003
    Geliefert am 13. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land t high rd,goodmayes,redbridge known as 1-4 railway cottages and land and buildings on the south-east side of high road,chadwell heath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent
    Erstellt am 16. Jan. 2001
    Geliefert am 31. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V,London Branch
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 2000
    Geliefert am 09. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed being supplemental to a debenture dated 26 september 2000 (as defined)
    Erstellt am 27. Okt. 2000
    Geliefert am 06. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) in any manner whatsoever and in any currency or currencies
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.,London Branch,as Security Agent
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge supplemental to a guarantee and debenture dated 3RD july 1996, a guarantee and debenture dated 12TH december 1996 and a guarantee and debenture dated 7TH january 1997 issued by the company
    Erstellt am 21. Aug. 1997
    Geliefert am 03. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Kurze Angaben
    F/H 1 to 4 railway cottages and land and buildings on the south east side of high road goodmayes ilford. T/n-NGL76432.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Jan. 1997
    Geliefert am 15. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Limited recourse guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1996
    Geliefert am 20. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Juli 1996
    Geliefert am 10. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Sept. 1993
    Geliefert am 10. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deposit and interim payment (as the same are defined in an agreement for the sale and purchase of the property dated 7/9/93 "the contract") due from the company to the chargee under the terms of the said contract
    Kurze Angaben
    The l/h land at marsh barton road exeter more particularly describes in an agreement dated 7/9/93.
    Berechtigte Personen
    • Wgtc Nominees Limited
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 1993
    Geliefert am 06. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,350,000 due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings to the south of cuton hall alne springfield chelmsford currently forming part of t/n ex 469422.
    Berechtigte Personen
    • Wgtc Nominees Limited
    Transaktionen
    • 06. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WICKES DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Sept. 2022Beginn der Liquidation
    23. Dez. 2023Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon David Chandler
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0