WICKES DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WICKES DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01795477 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HEWAPOINT LIMITED | 28. Feb. 1984 | 28. Feb. 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG zum C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX am 23. Sept. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Notification of Travis Perkins Financing Company No.3 Limited as a person with significant control on 06. Sept. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Wickes Properties Limited as a person with significant control on 06. Sept. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Ernennung von Tp Directors Ltd als Direktor am 27. Juni 2022 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Dez. 2020 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2019 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2018 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Peter Carter als Geschäftsführer am 01. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2017 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony David Buffin als Geschäftsführer am 11. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Richard Williams als Direktor am 11. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2015 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Sekretär | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England England |
| 186000060001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alan Richard | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Sekretär | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | 65678800002 | ||||||||||
| RIMMER, Barbara | Sekretär | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||||||
| STOKES-SMITH, Keith Reginald | Sekretär | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75650590001 | ||||||||||
| ARCHER, William Ernest | Geschäftsführer | The Priory 2 Astley Close WA16 8GJ Knutsford Cheshire | British | 15170380004 | ||||||||||
| BAMFORD, Carmel | Geschäftsführer | 36 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | 17771540001 | ||||||||||
| BHOTE, Sanaya Homi | Geschäftsführer | 50 Bonnersfield Lane HA1 2LE Harrow Middlesex | British | 72716110002 | ||||||||||
| BIRD, Jeremy | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 111434190001 | |||||||||
| BIRD, Richard Sidney | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | British | 111500210001 | ||||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CARTER, John Peter | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| CORNER, Michael Richmond | Geschäftsführer | 95 Castelnau Barnes SW13 London | British | 21206150001 | ||||||||||
| EDWARDS, Fred | Geschäftsführer | 2 Moreland Drive SL9 8BB Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 75885570002 | ||||||||||
| FRIEDMAN, Douglas Benjamin | Geschäftsführer | 46 Lankaster Gardens N2 9AJ London | American | 15200060001 | ||||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Geschäftsführer | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| HOSKINS, William John | Geschäftsführer | 3 Homewood Road AL1 4BE St. Albans Hertfordshire | British | 49295070002 | ||||||||||
| JONES, Paul Samuel | Geschäftsführer | Brooklyn Newell Green Warfield RG42 6AJ Bracknell Berkshire | British | 75187050001 | ||||||||||
| PENNY, Michael William Harrison | Geschäftsführer | Windrush 9 Downsway GU1 2YA Guildford Surrey | United Kingdom | British | 144262470001 | |||||||||
| RICE, John Michael | Geschäftsführer | Wayside Cottage Street Lane Rodeheath ST7 3SN Cheshire | British | 72718070001 | ||||||||||
| STOKES-SMITH, Keith Reginald | Geschäftsführer | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75650590001 | ||||||||||
| THACKER, Colin David | Geschäftsführer | Old Place Farm Birling Road Ryarsh ME19 5JS West Malling Kent | United Kingdom | British | 39672600001 | |||||||||
| THOMAS, Geoffrey John | Geschäftsführer | 8 Stanbrooke Way Church Lane Yielden MK44 1AU Bedford North Bedfordshire | British | 42980950001 | ||||||||||
| WILSON, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 72996700001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Perkins Financing Company No.3 Limited | 06. Sept. 2022 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Wickes Properties Limited | 06. Apr. 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WICKES DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A mezzanine debenture | Erstellt am 28. Juli 2003 Geliefert am 13. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Senior security accession deed | Erstellt am 29. Jan. 2003 Geliefert am 13. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Retained land at high rd,goodmayes,redbridge known as 1-4 railway cottages and land/blds on south-east side of high rd,chadwell heath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordinated security accession deed | Erstellt am 29. Jan. 2003 Geliefert am 13. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land t high rd,goodmayes,redbridge known as 1-4 railway cottages and land and buildings on the south-east side of high road,chadwell heath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent | Erstellt am 16. Jan. 2001 Geliefert am 31. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Dez. 2000 Geliefert am 09. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed being supplemental to a debenture dated 26 september 2000 (as defined) | Erstellt am 27. Okt. 2000 Geliefert am 06. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) in any manner whatsoever and in any currency or currencies | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge supplemental to a guarantee and debenture dated 3RD july 1996, a guarantee and debenture dated 12TH december 1996 and a guarantee and debenture dated 7TH january 1997 issued by the company | Erstellt am 21. Aug. 1997 Geliefert am 03. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge | |
Kurze Angaben F/H 1 to 4 railway cottages and land and buildings on the south east side of high road goodmayes ilford. T/n-NGL76432. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Jan. 1997 Geliefert am 15. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Limited recourse guarantee and debenture | Erstellt am 12. Dez. 1996 Geliefert am 20. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Juli 1996 Geliefert am 10. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Sept. 1993 Geliefert am 10. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The deposit and interim payment (as the same are defined in an agreement for the sale and purchase of the property dated 7/9/93 "the contract") due from the company to the chargee under the terms of the said contract | |
Kurze Angaben The l/h land at marsh barton road exeter more particularly describes in an agreement dated 7/9/93. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Feb. 1993 Geliefert am 06. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,350,000 due from the company to the chargee under the terms of this charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings to the south of cuton hall alne springfield chelmsford currently forming part of t/n ex 469422. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WICKES DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0