EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED

EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01796131
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED?

    • Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EUROBELL (SOUTHWEST) LIMITED14. Feb. 199414. Feb. 1994
    DEVON CABLEVISION LIMITED29. Feb. 198429. Feb. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    20 SeitenAA

    legacy

    80 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP zum 1 More London Place London SE1 2AF am 29. Aug. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 01. Aug. 2017

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 017961310013 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 017961310014 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 017961310015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 017961310017 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 017961310018 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 017961310016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 017961310019 vollständig

    1 SeitenMR04

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 26. Okt. 2016

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    Wer sind die Geschäftsführer von EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151021020001
    DUNN, Robert Dominic
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish182167230001
    BLANKFIELD, Andrew Morris
    14 Hall Place Gardens
    AL1 3SP St. Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    14 Hall Place Gardens
    AL1 3SP St. Albans
    Hertfordshire
    British81192720001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    MELIA, Gerard Thomas
    83 Wellington Road
    Turton
    BL7 0EF Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    83 Wellington Road
    Turton
    BL7 0EF Bolton
    Lancashire
    British1512020001
    RICHARDS, Allan
    12 Thistle Grove
    SW10 9RZ London
    Sekretär
    12 Thistle Grove
    SW10 9RZ London
    British55171600002
    RICHARDS, Allan
    3 Stewarts Grove
    SW3 6PD London
    Sekretär
    3 Stewarts Grove
    SW3 6PD London
    British55171600001
    WILLIAMS, Glenn Bernard Douglas
    12 Lowry Close
    College Town
    GU47 0FJ Sandhurst
    Berkshire
    Sekretär
    12 Lowry Close
    College Town
    GU47 0FJ Sandhurst
    Berkshire
    British63412650001
    WRIGHT, Douglas Barclay
    Lodge Drive
    Loudwater
    WD3 4PT Rickmansworth
    Clarinsh
    Hertfordshire
    Sekretär
    Lodge Drive
    Loudwater
    WD3 4PT Rickmansworth
    Clarinsh
    Hertfordshire
    British134618260001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BARNES, Richard Nigel
    42 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    42 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    British5240090001
    BLAKER, Peter Allan Renshaw, Lord
    Woodsland Farm Keysford Lane
    RH16 2QT Lindfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Woodsland Farm Keysford Lane
    RH16 2QT Lindfield
    West Sussex
    British56032390001
    BONNER, John Albert Gordon
    6 Cliff Court Drive
    Frenchay
    BS16 1LP Bristol
    Geschäftsführer
    6 Cliff Court Drive
    Frenchay
    BS16 1LP Bristol
    EnglandBritish170141060001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COLBRAN, Robert Scott
    Pinecreek Farm
    Rr 4
    FOREIGN Acton
    Ontario Ltj 2mi
    Canada
    Geschäftsführer
    Pinecreek Farm
    Rr 4
    FOREIGN Acton
    Ontario Ltj 2mi
    Canada
    Canadian15486600001
    COLLINS, Seamus
    Cable Systems Development Co Ltd
    41 Gloucester Place
    W1H 3PD London
    Geschäftsführer
    Cable Systems Development Co Ltd
    41 Gloucester Place
    W1H 3PD London
    British17949260003
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    CORNISH, Alan Stewart
    Aspens 42 Oxenden Wood Road
    BR6 6HP Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    Aspens 42 Oxenden Wood Road
    BR6 6HP Orpington
    Kent
    British2757380001
    CURTIS, Peter John Watling
    168 Manor Green Road
    KT19 8LL Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    168 Manor Green Road
    KT19 8LL Epsom
    Surrey
    British43282580002
    DAY, Simon James, Sir
    Keaton House
    Ivybridge
    PL21 0LB Plymouth
    Devon
    Geschäftsführer
    Keaton House
    Ivybridge
    PL21 0LB Plymouth
    Devon
    EnglandBritish12477210001
    FREEDMAN, Philip Zachary
    98 Highgate Hill
    N6 5HE London
    Geschäftsführer
    98 Highgate Hill
    N6 5HE London
    American73535900001
    GAGE, John Barry
    202 Lord Seaton Road
    North York
    M2P 1K9 Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    202 Lord Seaton Road
    North York
    M2P 1K9 Ontario
    Canada
    Canadian15486590002
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GELLERT, Horst
    Im Mondsroettchen 38
    51429 Bergisch Gladbach
    Germany
    Geschäftsführer
    Im Mondsroettchen 38
    51429 Bergisch Gladbach
    Germany
    German46999550001
    HOFMANN, Klaus
    Meineckestrasse 46
    D40474 Duesseldorf
    Germany
    Geschäftsführer
    Meineckestrasse 46
    D40474 Duesseldorf
    Germany
    German69180580001
    HOLMES, Kenneth Edmund
    Aish Cross House
    Stoke Gabriel
    TQ9 6PT Totnes
    Devon
    Geschäftsführer
    Aish Cross House
    Stoke Gabriel
    TQ9 6PT Totnes
    Devon
    British5201920001
    HOOLE, Peter David
    The Small House
    High St Sherington
    MK16 9NB Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Small House
    High St Sherington
    MK16 9NB Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13747930001
    JACKSON, Andrew George Wycliffe
    136 Narbonne Avenue
    SW4 9LG London
    Geschäftsführer
    136 Narbonne Avenue
    SW4 9LG London
    British27013830001
    JAGGARD, Stephen Paul
    West End House High Street
    Blagdon
    BS18 6RA Bristol
    Geschäftsführer
    West End House High Street
    Blagdon
    BS18 6RA Bristol
    British43116270001
    JAGGARD, Timothy John Brooks
    Candlelight Cottage
    Ackrells Hill, Littlehempston
    TQ9 6LX Totnes
    Devon
    Geschäftsführer
    Candlelight Cottage
    Ackrells Hill, Littlehempston
    TQ9 6LX Totnes
    Devon
    British88378290001
    LAQUA, Markus Josef
    19 Elsenham Street
    Southfields
    SW18 5NU London
    Geschäftsführer
    19 Elsenham Street
    Southfields
    SW18 5NU London
    German43624140001
    LAQUA, Markus Josef
    23 Hatchlands
    RH12 5JX Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    23 Hatchlands
    RH12 5JX Horsham
    West Sussex
    German43624140002
    LICKORISH, Derek Arthur
    26 Bucklands View
    Nailsea
    BS48 4TZ Bristol
    Somerset
    Geschäftsführer
    26 Bucklands View
    Nailsea
    BS48 4TZ Bristol
    Somerset
    British29415700001
    LINKE, Rainer
    Berliner Ring 22
    53175 Bonn
    Northrine Westfalia
    Germany
    Geschäftsführer
    Berliner Ring 22
    53175 Bonn
    Northrine Westfalia
    Germany
    German46999490001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2904215
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 26. Apr. 2016
    Geliefert am 27. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    -.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Apr. 2015
    Geliefert am 06. Mai 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Mai 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. März 2015
    Geliefert am 01. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Jan. 2015
    Geliefert am 06. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Apr. 2014
    Geliefert am 10. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. März 2014
    Geliefert am 02. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 14. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 14. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 03. März 2011
    Geliefert am 15. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the security trustee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the issuance of the new notes, the new guarantees and the new indenture and the transactions contemplated thereby and hereby confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of liens under and subject to the terms of the liens, the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 15. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 04. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 04. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Okt. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 22. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A supplemental deed made between (1) eurobell (holdings) limited, (2) telewest communications networks limited, (3) cibc worlds markets PLC and (4) telewest communications PLC pursuant to which, inter alia the company accedes to a guarantee and debenture dated 16 march 2001 and
    Erstellt am 15. Feb. 2002
    Geliefert am 21. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the chargors to the security trustee and any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right, title and/or interest in all stocks and shares whatsoever whether marketable or otherwise and all other interests (including but not limited to loan capital) including all allotments, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing. The loan stock, all amounts payable, the intercompany loan. By way of floating charge all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, other than any property or assets from time to time charged by way of fixed charge or assignment above.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee for Thebeneficiaries)
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 29. Mai 1997
    Geliefert am 03. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the indemnity dated 29TH may 1997
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. Account number 7855719. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 1996
    Geliefert am 03. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Meespierson N.V.
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EUROBELL (SOUTH WEST) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Nov. 2018Aufgelöst am
    01. Aug. 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0