IVORY BEVERAGES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | IVORY BEVERAGES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01796736 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von IVORY BEVERAGES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich IVORY BEVERAGES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | East Wing 14th Floor 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von IVORY BEVERAGES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
COFFEE MAC LIMITED | 02. März 1984 | 02. März 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IVORY BEVERAGES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. März 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für IVORY BEVERAGES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Apr. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Michael Roe am 11. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Wyatt Bristow Aca Bsc(Hons) am 11. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2006 | 18 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von IVORY BEVERAGES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREENWOOD, Michael Frank | Sekretär | Gloucester Road Kew TW9 3BT Richmond 51 Surrey | British | Director | 90910000002 | |||||
BRISTOW, Andrew Wyatt | Geschäftsführer | Garden Road BR1 3LX Bromley 22 Kent | England | British | Director | 8748280008 | ||||
ROE, Timothy Michael | Geschäftsführer | Kenley Road SW19 3JQ London 2a | England | British | Director | 51264250001 | ||||
ATKINSON, Richard | Sekretär | 5 Lukins Drive CM6 1XQ Dunmow Essex | British | 60376890001 | ||||||
HALEY, Paul Stewart | Sekretär | 3 Providential Street Flockton WF4 4DJ Wakefield West Yorkshire | British | 101774450001 | ||||||
LEMPRIERE, Paul John | Sekretär | 20 Bishop Burton Road Cherry Burton HU17 7RW Beverley E Yorkshire | British | Company Director | 7658350001 | |||||
MCKAY, William Trevor | Sekretär | 1 West Court HA0 3QQ North Wembley Middlesex | British | Secretary | 588890001 | |||||
ALLAWAY, Michael John | Geschäftsführer | Grove Cottage Blounts Court Road RG9 5EU Peppard Henley On Thames | United Kingdom | British | Company Director | 37618690001 | ||||
ATKINSON, Richard | Geschäftsführer | 5 Lukins Drive CM6 1XQ Dunmow Essex | British | Solicitor | 60376890001 | |||||
BLAKE, Frank George Bennett | Geschäftsführer | 117 Pannal Ash Road HG2 9JL Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 3779990001 | ||||
CHRISTOPHER, John Martin | Geschäftsführer | 24 Bridge Court Morley LS27 0BD Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 18639650001 | |||||
DRAUDE, Barry | Geschäftsführer | 20 Chestnut Green Monk Fryston LS25 5PN Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 112174490001 | ||||
DUNNE, Jeremy Robert | Geschäftsführer | 16 Greenhill Road Armley LS12 3QA Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 84111110001 | ||||
FIRTH, Michael Roger | Geschäftsführer | Stamford House The Green, Green Hammerton YO26 8BQ York North Yorkshire | British | Company Director | 62298980001 | |||||
GIDDINGS, Allan | Geschäftsführer | Rock House Back Lane Sicklinghall LS22 4BQ Wetherby West Yorkshire | British | Company Director | 2164900001 | |||||
HALEY, Paul Stewart | Geschäftsführer | 3 Providential Street Flockton WF4 4DJ Wakefield West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 101774450001 | |||||
IVORY, Christopher Richard | Geschäftsführer | The Old Mill Kirkbridge Crakehall DL8 1PN Bedale North Yorkshire | British | Company Director | 12090570001 | |||||
LEMPRIERE, Paul John | Geschäftsführer | 20 Bishop Burton Road Cherry Burton HU17 7RW Beverley E Yorkshire | England | British | Company Director | 7658350001 | ||||
LUCK, Gary Darren Michael | Geschäftsführer | 73 De Vigier Avenue CB10 2AY Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | Director | 92311040001 | ||||
MACLACHLAN, Ronald Alan | Geschäftsführer | Oakcroft 30 The Orchards BD16 4AZ Bingley West Yorkshire | British | Company Director | 18639640001 | |||||
MILLER, Billy David | Geschäftsführer | 96 Green Park Road HX3 0SW Halifax West Yorkshire | British | Director | 79550070001 | |||||
MORGAN, David Edward | Geschäftsführer | 40 Singingwood Lane CA 94563 Orinda California Usa | British | Chartered Accountant | 60419650002 | |||||
MURRAY, Steven John | Geschäftsführer | 9 Whiteoak Gardens The Hollies DA15 8WE Sidcup Kent | United Kingdom | British | Director | 21176500001 | ||||
WILFORD, Roy | Geschäftsführer | Hindlea Trigfa Estate LL72 8LL Moelfre Anglesey | British | Company Director | 76263740001 |
Hat IVORY BEVERAGES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 24. Dez. 2001 Geliefert am 03. Jan. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 08. Aug. 2000 Geliefert am 10. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Various chattels the insurance policies in relation thereto and all the right title and interest in and to the benefit of all present and future contracts and agreements relating to the chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 23. März 1998 Geliefert am 30. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 11. März 1997 Geliefert am 21. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from northallerton wholesale foods limited and/or land food products limited formerly known as flipchoice limited (the "group companies") except any monies due by the group companies as guarantor for the company | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. März 1997 Geliefert am 19. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Feb. 1997 Geliefert am 13. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company and northallerton wholesale foods limited (the "group company") to the chargee,except any monies or liabilities due owing or incurred by the group company as guarantor for the company | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture | Erstellt am 09. Dez. 1996 Geliefert am 24. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each relevant obligor (as defined therein) to the institutions (as defined therein) (or any of them) under each of the financing documents to which that relevant obligor is a party | |
Kurze Angaben L/H property k/a the warehouse and land on the east side of ripley drive normanton t/n WYK555975 k/a carter mills 146 cleckheaton rd bradford units 5 & 6 normanton industrial estate normanton west yorkshire t/no's;- wyk 527220 & WYK531219 l/h property k/a unit 4 westwoods alphin brook road marsh barton exeter unit 29 earith business park fen drove earith huntingdon cambridgeshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Okt. 1996 Geliefert am 10. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities (whether actual or contingient whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each relevant obligor to the chargee as agent and trustee for itself and for each institution (or any of them) as defined therein under each of the financing documents to which that relevant obligor is a party. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 17. Mai 1991 Erworben am 18. Okt. 1991 Geliefert am 29. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Okt. 1989 Geliefert am 30. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Juni 1989 Geliefert am 21. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0