IVORY BEVERAGES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIVORY BEVERAGES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01796736
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IVORY BEVERAGES LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    East Wing 14th Floor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COFFEE MAC LIMITED02. März 198402. März 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. März 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 15. Apr. 2010

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Transactions authorised 09/04/2010
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung und/oder der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Michael Roe am 11. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Wyatt Bristow Aca Bsc(Hons) am 11. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2008

    14 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2007

    14 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2006

    18 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    21 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GREENWOOD, Michael Frank
    Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BT Richmond
    51
    Surrey
    Sekretär
    Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BT Richmond
    51
    Surrey
    BritishDirector90910000002
    BRISTOW, Andrew Wyatt
    Garden Road
    BR1 3LX Bromley
    22
    Kent
    Geschäftsführer
    Garden Road
    BR1 3LX Bromley
    22
    Kent
    EnglandBritishDirector8748280008
    ROE, Timothy Michael
    Kenley Road
    SW19 3JQ London
    2a
    Geschäftsführer
    Kenley Road
    SW19 3JQ London
    2a
    EnglandBritishDirector51264250001
    ATKINSON, Richard
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Sekretär
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    British60376890001
    HALEY, Paul Stewart
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    Sekretär
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    British101774450001
    LEMPRIERE, Paul John
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    Sekretär
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    BritishCompany Director7658350001
    MCKAY, William Trevor
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    Sekretär
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    BritishSecretary588890001
    ALLAWAY, Michael John
    Grove Cottage
    Blounts Court Road
    RG9 5EU Peppard
    Henley On Thames
    Geschäftsführer
    Grove Cottage
    Blounts Court Road
    RG9 5EU Peppard
    Henley On Thames
    United KingdomBritishCompany Director37618690001
    ATKINSON, Richard
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Geschäftsführer
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    BritishSolicitor60376890001
    BLAKE, Frank George Bennett
    117 Pannal Ash Road
    HG2 9JL Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    117 Pannal Ash Road
    HG2 9JL Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector3779990001
    CHRISTOPHER, John Martin
    24 Bridge Court
    Morley
    LS27 0BD Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Bridge Court
    Morley
    LS27 0BD Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director18639650001
    DRAUDE, Barry
    20 Chestnut Green
    Monk Fryston
    LS25 5PN Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Chestnut Green
    Monk Fryston
    LS25 5PN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director112174490001
    DUNNE, Jeremy Robert
    16 Greenhill Road
    Armley
    LS12 3QA Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Greenhill Road
    Armley
    LS12 3QA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant84111110001
    FIRTH, Michael Roger
    Stamford House
    The Green, Green Hammerton
    YO26 8BQ York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Stamford House
    The Green, Green Hammerton
    YO26 8BQ York
    North Yorkshire
    BritishCompany Director62298980001
    GIDDINGS, Allan
    Rock House Back Lane
    Sicklinghall
    LS22 4BQ Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Rock House Back Lane
    Sicklinghall
    LS22 4BQ Wetherby
    West Yorkshire
    BritishCompany Director2164900001
    HALEY, Paul Stewart
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant101774450001
    IVORY, Christopher Richard
    The Old Mill
    Kirkbridge Crakehall
    DL8 1PN Bedale
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Mill
    Kirkbridge Crakehall
    DL8 1PN Bedale
    North Yorkshire
    BritishCompany Director12090570001
    LEMPRIERE, Paul John
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director7658350001
    LUCK, Gary Darren Michael
    73 De Vigier Avenue
    CB10 2AY Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    73 De Vigier Avenue
    CB10 2AY Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishDirector92311040001
    MACLACHLAN, Ronald Alan
    Oakcroft 30 The Orchards
    BD16 4AZ Bingley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Oakcroft 30 The Orchards
    BD16 4AZ Bingley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director18639640001
    MILLER, Billy David
    96 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    96 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector79550070001
    MORGAN, David Edward
    40 Singingwood Lane
    CA 94563 Orinda
    California
    Usa
    Geschäftsführer
    40 Singingwood Lane
    CA 94563 Orinda
    California
    Usa
    BritishChartered Accountant60419650002
    MURRAY, Steven John
    9 Whiteoak Gardens The Hollies
    DA15 8WE Sidcup
    Kent
    Geschäftsführer
    9 Whiteoak Gardens The Hollies
    DA15 8WE Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishDirector21176500001
    WILFORD, Roy
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    Geschäftsführer
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    BritishCompany Director76263740001

    Hat IVORY BEVERAGES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Dez. 2001
    Geliefert am 03. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 08. Aug. 2000
    Geliefert am 10. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Various chattels the insurance policies in relation thereto and all the right title and interest in and to the benefit of all present and future contracts and agreements relating to the chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. März 1998
    Geliefert am 30. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 11. März 1997
    Geliefert am 21. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from northallerton wholesale foods limited and/or land food products limited formerly known as flipchoice limited (the "group companies") except any monies due by the group companies as guarantor for the company
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. März 1997
    Geliefert am 19. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 19. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1997
    Geliefert am 13. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company and northallerton wholesale foods limited (the "group company") to the chargee,except any monies or liabilities due owing or incurred by the group company as guarantor for the company
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 09. Dez. 1996
    Geliefert am 24. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each relevant obligor (as defined therein) to the institutions (as defined therein) (or any of them) under each of the financing documents to which that relevant obligor is a party
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the warehouse and land on the east side of ripley drive normanton t/n WYK555975 k/a carter mills 146 cleckheaton rd bradford units 5 & 6 normanton industrial estate normanton west yorkshire t/no's;- wyk 527220 & WYK531219 l/h property k/a unit 4 westwoods alphin brook road marsh barton exeter unit 29 earith business park fen drove earith huntingdon cambridgeshire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 10. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities (whether actual or contingient whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each relevant obligor to the chargee as agent and trustee for itself and for each institution (or any of them) as defined therein under each of the financing documents to which that relevant obligor is a party.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 17. Mai 1991
    Erworben am 18. Okt. 1991
    Geliefert am 29. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1992Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 24. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Okt. 1989
    Geliefert am 30. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    • 24. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 14. Juni 1989
    Geliefert am 21. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Juni 1989Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0