WMT HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWMT HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01797012
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WMT HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich WMT HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WMT HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WMT HOLDINGS PLC24. Mai 198424. Mai 1984
    BADGERBUSH LIMITED05. März 198405. März 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WMT HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für WMT HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 09. März 2009

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 13. Nov. 2008

    2 Seiten3.6

    Verschiedenes

    Statement of affairs
    6 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    31 Seiten3.10

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2005

    8 SeitenAA

    Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    1 SeitenCERT10

    Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung

    14 SeitenMAR

    legacy

    2 Seiten53

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Umregistrierung

    RES02

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2004

    19 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten244

    Wer sind die Geschäftsführer von WMT HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TOMLINSON, Philip Charles Murray
    630 Fulwood Road
    S10 3QJ Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    630 Fulwood Road
    S10 3QJ Sheffield
    South Yorkshire
    British58220340001
    TOMLINSON, Philip Charles Murray
    630 Fulwood Road
    S10 3QJ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    630 Fulwood Road
    S10 3QJ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish58220340001
    TOMLINSON, Simon John Lloyd
    19 Ashfurlong Close
    Dore
    S17 3NN Sheffield
    Geschäftsführer
    19 Ashfurlong Close
    Dore
    S17 3NN Sheffield
    United KingdomBritish45674390002
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British83552520001
    FOX, George William Damian
    Dickfield Farm
    Little Common Lane
    S11 9NE Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    Dickfield Farm
    Little Common Lane
    S11 9NE Sheffield
    South Yorkshire
    British36779480002
    BREESE, Charles Jonathon
    Hethe House
    Hethe
    OX6 9ES Bicester
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Hethe House
    Hethe
    OX6 9ES Bicester
    Oxfordshire
    British33215780002
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish83552520001
    CHARLES, Nigel Alan
    1 Midfields
    School Aycliffe
    DL5 6QJ Newton Aycliffe
    County Durham
    Geschäftsführer
    1 Midfields
    School Aycliffe
    DL5 6QJ Newton Aycliffe
    County Durham
    British30529170001
    FOX, George William Damian
    Dickfield Farm
    Little Common Lane
    S11 9NE Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Dickfield Farm
    Little Common Lane
    S11 9NE Sheffield
    South Yorkshire
    British36779480002
    INGRAM, Stephen
    88 Stumperlowe Hall Road
    S10 3QT Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    88 Stumperlowe Hall Road
    S10 3QT Sheffield
    South Yorkshire
    British2338960001
    LIVERSIDGE, Douglas Brian
    Nicholas Hall
    Thornhill
    S33 0BR Hope Valley
    Geschäftsführer
    Nicholas Hall
    Thornhill
    S33 0BR Hope Valley
    EnglandBritish7267220002
    PULLUM, John Sidney
    9 Fordyce Close
    Emerson Park
    RM11 3LE Hornchurch
    Essex
    Geschäftsführer
    9 Fordyce Close
    Emerson Park
    RM11 3LE Hornchurch
    Essex
    British1471410001
    REED, Timothy Henry
    Jaggers Keep Bar Road
    Curbar
    S30 1YB Sheffield
    Geschäftsführer
    Jaggers Keep Bar Road
    Curbar
    S30 1YB Sheffield
    EnglandBritish39125880001
    TOMLINSON, Walter Murray
    Letterbox Farm
    Pratthall Calthorpe
    S42 7AZ Chesterfield
    Geschäftsführer
    Letterbox Farm
    Pratthall Calthorpe
    S42 7AZ Chesterfield
    British1961890001

    Hat WMT HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 12. Okt. 1998
    Geliefert am 17. Okt. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings lying to the south of station road holbrook sheffield t/nos SYK211754 and SYK344532. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Jan. 1991
    Geliefert am 08. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 10. Jan. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 12. Juli 1989
    Geliefert am 31. Juli 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from morgan 85 limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    Letter of charge
    Erstellt am 22. Sept. 1988
    Geliefert am 27. Sept. 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys now or at any time hereafter owing the bank by marshall richards barcro limited and/or morgan 85 limited and/or beaver 84 limited and/or rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or lubewell limited power control systems limited to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1988Registrierung einer Belastung
    Letter of charge
    Erstellt am 05. März 1988
    Geliefert am 23. März 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys now or at any time hereafter owing the bank by marshall richards barcro limited and/or morgan 85 limited and/or beaver 84 limited and/or rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or lubewell limited power control systems limited to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. März 1988Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 09. Apr. 1987
    Geliefert am 15. Apr. 1987
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking, property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    • 18. Dez. 2007Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 1
    Letter of charge.
    Erstellt am 09. Apr. 1987
    Geliefert am 15. Apr. 1987
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from rails 84 limited and/or mirhan associates limited and/or beaver 84 limited and/or marshall richards barcro limited and/or morgan 85 limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 17. Jan. 1986
    Geliefert am 22. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 135,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    Leasehold property at station road, halfway, sheffield, title no syk 211754 together with all additions and fixtures.
    Berechtigte Personen
    • United Kingdom Temperence and General Provident Institution.
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 24. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. Mai 1985
    Geliefert am 14. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge on all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future goodwill & bookdebts and the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 1984
    Geliefert am 20. Juni 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • United Kingdom Temperance and General Provident Institution
    Transaktionen
    • 20. Juni 1984Registrierung einer Belastung

    Hat WMT HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Apr. 1987Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Jonathon P Sumpton
    Ernst & Young
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    Leeds Ls11 5qr
    Praktiker
    Ernst & Young
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    Leeds Ls11 5qr

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0