AANE REALISATIONS (NE) LIMITED

AANE REALISATIONS (NE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAANE REALISATIONS (NE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01797394
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AANE REALISATIONS (NE) LIMITED?

    • Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe
    • Zerspanung (25620) / Verarbeitendes Gewerbe
    • Herstellung von anderen Metallwaren (25990) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich AANE REALISATIONS (NE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Duff And Phelps The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AANE REALISATIONS (NE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ARLINGTON AUTOMOTIVE NE LIMITED22. Okt. 201522. Okt. 2015
    DPE AUTOMOTIVE LIMITED28. Jan. 200928. Jan. 2009
    DURHAM PRECISION ENGINEERING LIMITED21. Mai 198421. Mai 1984
    BYTEGLEN LIMITED06. März 198406. März 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AANE REALISATIONS (NE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für AANE REALISATIONS (NE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    50 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    52 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    48 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    55 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Beendigung der Bestellung von Peter William Coates als Geschäftsführer am 15. Feb. 2021

    1 SeitenTM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    49 SeitenAM10

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 23. Okt. 2020

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Erfüllung der Belastung 017973940023 teilweise

    1 SeitenMR04

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 017973940023

    1 SeitenMR05

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    4 SeitenAM06

    Vorschlag des Verwalters

    123 SeitenAM03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Arlington Automotive Ne Limited Gurney Way Aycliffe Business Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UJ England zum C/O Duff and Phelps the Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW am 26. Mai 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    4 SeitenAM01

    Beendigung der Bestellung von Kevin Morley als Geschäftsführer am 15. Apr. 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2019

    35 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Simon George Greenhalgh als Geschäftsführer am 14. Juli 2019

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 017973940021 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 017973940022 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 017973940023, erstellt am 05. Apr. 2019

    77 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2018

    25 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von AANE REALISATIONS (NE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FRANCKEL, Mark
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff And Phelps The Chancery
    Geschäftsführer
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff And Phelps The Chancery
    EnglandBritishDirector200716270001
    BOYLAN, Gillian Elizabeth
    Murray Walk
    DL3 9QS Darlington
    3
    County Durham
    Sekretär
    Murray Walk
    DL3 9QS Darlington
    3
    County Durham
    BritishAccountant128265620002
    COATES, Peter William
    19 Dean Park
    DL17 8HP Ferryhill
    County Durham
    Sekretär
    19 Dean Park
    DL17 8HP Ferryhill
    County Durham
    BritishEngineer121157500001
    GIBSON, John Albert
    Southernwood
    NE61 3JW Morpeth
    Northumberland
    Sekretär
    Southernwood
    NE61 3JW Morpeth
    Northumberland
    British38993810001
    HINDE, George William
    134 Salutation Road
    DL3 8JP Darlington
    County Durham
    Sekretär
    134 Salutation Road
    DL3 8JP Darlington
    County Durham
    BritishWorks Director29523500001
    LAPPING, Andrew Christopher
    Gurney Way
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Limited
    County Durham
    England
    Sekretär
    Gurney Way
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Limited
    County Durham
    England
    188425930001
    PHILLIPS, John
    5 Meadowfield Road
    NE43 7PY Stocksfield
    Northumberland
    Sekretär
    5 Meadowfield Road
    NE43 7PY Stocksfield
    Northumberland
    BritishDirector3519650001
    PIKE, Stephen John
    Dixon Way
    Coundon
    DL14 8NH Bishop Auckland
    25
    County Durham
    United Kingdom
    Sekretär
    Dixon Way
    Coundon
    DL14 8NH Bishop Auckland
    25
    County Durham
    United Kingdom
    BritishAccountant137275150001
    SAUL, Mark Ashley
    Field House Close
    LS22 6UD Wetherby
    1
    West Yorkshire
    Sekretär
    Field House Close
    LS22 6UD Wetherby
    1
    West Yorkshire
    BritishAccountant135658440001
    STODDART, Christine
    Groveway House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    Sekretär
    Groveway House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    BritishAdministrator107159450001
    TILTMAN, Kim
    Gibbons Industrial Park
    Dudley Road
    DY6 8XF Kingswinford
    United Steels Limited
    West Midlands
    England
    Sekretär
    Gibbons Industrial Park
    Dudley Road
    DY6 8XF Kingswinford
    United Steels Limited
    West Midlands
    England
    163220550001
    BEDFORD, Douglas Allan Andrew Humphrey
    Redfern Parkway
    Tyseley
    B11 2AP Birmingham
    Saville House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Redfern Parkway
    Tyseley
    B11 2AP Birmingham
    Saville House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector121697440002
    CARMEDY-PYE, Philip
    Kirkham Way
    Auckland Park
    DL14 8SQ Bishop Auckland
    28
    County Durham
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Kirkham Way
    Auckland Park
    DL14 8SQ Bishop Auckland
    28
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritishOperations Director137314050001
    COATES, Peter William
    Gurney Way
    Aycliffe Business Park
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Ltd
    County Durham
    England
    Geschäftsführer
    Gurney Way
    Aycliffe Business Park
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Ltd
    County Durham
    England
    BritishBritishEngineer121157500001
    COATES, Peter William
    19 Dean Park
    DL17 8HP Ferryhill
    County Durham
    Geschäftsführer
    19 Dean Park
    DL17 8HP Ferryhill
    County Durham
    BritishBritishEngineer121157500001
    ELLIS, Darren
    20 Ashtree Close
    DL5 4FD Newton Aycliffe
    County Durham
    Geschäftsführer
    20 Ashtree Close
    DL5 4FD Newton Aycliffe
    County Durham
    United KingdomBritishDirector120619690001
    GIBSON, John Albert
    Southernwood
    NE61 3JW Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Southernwood
    NE61 3JW Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector38993810001
    GREENHALGH, Simon George
    Gurney Way
    Aycliffe Business Park
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Arlington Automotive Ne Limited
    County Durham
    England
    Geschäftsführer
    Gurney Way
    Aycliffe Business Park
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Arlington Automotive Ne Limited
    County Durham
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer82888850001
    HINDE, George William
    134 Salutation Road
    DL3 8JP Darlington
    County Durham
    Geschäftsführer
    134 Salutation Road
    DL3 8JP Darlington
    County Durham
    BritishWorks Director29523500001
    JOYCE, Stephen
    Gibbons Industrial Park
    Dudley Road
    DY6 8XF Kingswinford
    United Steels Limited
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Gibbons Industrial Park
    Dudley Road
    DY6 8XF Kingswinford
    United Steels Limited
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector77872850001
    LAPPING, Andrew Christopher
    Gurney Way
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Limited
    County Durham
    England
    Geschäftsführer
    Gurney Way
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Limited
    County Durham
    England
    United KingdomBritishDirector113467730001
    MCENENY, Kevin
    Whitworth Meadow
    Binchester Moor
    DL16 7BH Spennymoor
    5
    Co Durham
    Geschäftsführer
    Whitworth Meadow
    Binchester Moor
    DL16 7BH Spennymoor
    5
    Co Durham
    BritishEngineer128504850001
    MERRYWEATHER, Mark Ian
    Gurney Way
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Limited
    County Durham
    Geschäftsführer
    Gurney Way
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Limited
    County Durham
    EnglandBritishDirector166777600001
    MORLEY, Kevin
    Gurney Way
    Aycliffe Business Park
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Arlington Automotive Ne Limited
    County Durham
    England
    Geschäftsführer
    Gurney Way
    Aycliffe Business Park
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Arlington Automotive Ne Limited
    County Durham
    England
    EnglandBritishDirector200406020002
    PHILLIPS, John
    5 Meadowfield Road
    NE43 7PY Stocksfield
    Northumberland
    Geschäftsführer
    5 Meadowfield Road
    NE43 7PY Stocksfield
    Northumberland
    BritishDirector3519650001
    PIKE, Stephen John
    Redfern Parkway
    Tyseley
    B11 2AP Birmingham
    Saville House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Redfern Parkway
    Tyseley
    B11 2AP Birmingham
    Saville House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant149969900001
    STODDART, Thomas
    Groveway House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    Geschäftsführer
    Groveway House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    EnglandBritishDirector15791540003
    STOTT, Simon
    Gurney Way
    Aycliffe Business Park
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Arlington Automotive Ne Limited
    County Durham
    England
    Geschäftsführer
    Gurney Way
    Aycliffe Business Park
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Arlington Automotive Ne Limited
    County Durham
    England
    EnglandBritishDirector194798190001
    TILTMAN, Kim
    Gibbons Industrial Park
    Dudley Road
    DY6 8XF Kingswinford
    United Steels Limited
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    Gibbons Industrial Park
    Dudley Road
    DY6 8XF Kingswinford
    United Steels Limited
    West Midlands
    England
    EnglandBritishAccountant89631230001
    VINCENT, Anthony John
    Grasmere
    DL16 6TX Spennymoor
    31
    County Durham
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Grasmere
    DL16 6TX Spennymoor
    31
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritishPurchasing Director137376960001
    WRIGHT, Rudi Scott
    Gurney Way
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Limited
    County Durham
    England
    Geschäftsführer
    Gurney Way
    DL5 6UJ Newton Aycliffe
    Dpe Automotive Limited
    County Durham
    England
    United KingdomBritishDirector154053040002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AANE REALISATIONS (NE) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Torrington Avenue
    CV4 9AQ Coventry
    79
    England
    06. Apr. 2016
    Torrington Avenue
    CV4 9AQ Coventry
    79
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer5664126
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat AANE REALISATIONS (NE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 05. Apr. 2019
    Geliefert am 15. Apr. 2019
    Teilweise erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Midcap Financial (Ireland) Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 26. Okt. 2020Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 29. Okt. 2020Teilweise Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 05. März 2018
    Geliefert am 05. März 2018
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 05. März 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 17. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Mai 2017
    Geliefert am 10. Mai 2017
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Mai 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 17. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Aug. 2015
    Geliefert am 19. Aug. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a) of the guarantee and debenture;. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (B) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets); and. (C) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q) of the guarantee and debenture.. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets) together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which centric may designate as specified real property.. All defined terms are as defined in the guarantee and debenture.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Centric Spv 1 Limited ("Centric")
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 12. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Juli 2015
    Geliefert am 31. Juli 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Fixed charge over all land and intellectual property.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Hamilton Portfolio Limited (As Security Trustee for and on Behalf of Andrew Lapping and Santon Capital PLC)
    Transaktionen
    • 31. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 23. Juni 2014
    Geliefert am 03. Juli 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 03. Juli 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Juni 2014
    Geliefert am 12. Juni 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Neaf LP Acting by Its General Partner Ne Angel Gp Limited
    Transaktionen
    • 12. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Mai 2014
    Geliefert am 28. Mai 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Under this debenture the company charges, with full title guarantee, to the lender:. 1. by way of first legal mortgage, all present and future right, title and interest of the company from time to time in freehold, leasehold or commonhold property (whether registered or unregistered) together with all present and future buildings, fixtures (including trade and tenant’s fixtures), plant and machinery on any such property and the benefit of all rights, covenants, easements and privileges appurtenant to, or for the benefit of, the same from time to time (and the proceeds of sale from time to time of any of the same and “property” means any of them;. 2. by way of first fixed charge:. A. all properties not charged by clause 1 above from time to time;. B. all present and future rights, licenses, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to any property; and. C. any present or future legal and/or equitable rights or interests (including the benefit of all licences in any part of the world) of each chargor in or relating to any patents, inventions, registered designs, trade marks, domain names, applications for the registration of any of the foregoing and the right to apply therefor in any part of the world, design rights including community designs, database rights, topography rights, copyrights and rights in the nature of copyright, trade names, logos and get-up, know-how and trade secrets, and any similar or equivalent rights arising or subsisting anywhere in the world, together with any present and future fees, royalties and other income or rights derived from or incidental to any of the foregoing and the benefit of all present and future agreements relating to the use of, licensing or exploitation of any such rights.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rudi Wright
    Transaktionen
    • 28. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Mai 2014
    Geliefert am 28. Mai 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Under this debenture the company charges, with full title guarantee, to the lender:. 1. by way of first legal mortgage, all present and future right, title and interest of the company from time to time in freehold, leasehold or commonhold property (whether registered or unregistered) together with all present and future buildings, fixtures (including trade and tenant’s fixtures), plant and machinery on any such property and the benefit of all rights, covenants, easements and privileges appurtenant to, or for the benefit of, the same from time to time (and the proceeds of sale from time to time of any of the same and “property” means any of them;. 2. by way of first fixed charge:. A. all properties not charged by clause 1 above from time to time;. B. all present and future rights, licenses, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to any property; and. C. any present or future legal and/or equitable rights or interests (including the benefit of all licences in any part of the world) of each chargor in or relating to any patents, inventions, registered designs, trade marks, domain names, applications for the registration of any of the foregoing and the right to apply therefor in any part of the world, design rights including community designs, database rights, topography rights, copyrights and rights in the nature of copyright, trade names, logos and get-up, know-how and trade secrets, and any similar or equivalent rights arising or subsisting anywhere in the world, together with any present and future fees, royalties and other income or rights derived from or incidental to any of the foregoing and the benefit of all present and future agreements relating to the use of, licensing or exploitation of any such rights.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Andrew Lapping
    Transaktionen
    • 28. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 12. Feb. 2014
    Geliefert am 12. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Sept. 2012
    Geliefert am 25. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 08. Dez. 2009
    Geliefert am 10. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • United Steels Limited
    Transaktionen
    • 10. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Aug. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 04. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 29. Mai 2009
    Geliefert am 09. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £850,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets including book debts and machinery, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ecf Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 29. Mai 2009
    Geliefert am 09. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £850,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets including book debts and machinery, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ecf Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. März 2009
    Geliefert am 20. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bibby Financial Services Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 20. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 22. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental chattel mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 2007
    Geliefert am 02. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assets being audi A3 2.0TDI sport 5 door hatchback chassis no WAUZZZ8P15A135358 yom 2005 RJ05 gbf, ford focus c-max 1.6TDCI zetec estate chassis no WF0MXXGCDM3M26288 yom 2004 KA04 usx, ford mondeo lx tdci chassis no WFD05XXGBB56L39037 KG06 ybz for details of further assets charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Apr. 2007
    Geliefert am 02. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for itself and each associate) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC (As Agent and Trustee for Itself and Each Associate)
    Transaktionen
    • 02. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 14. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of mortgage over land and chattels
    Erstellt am 19. Apr. 2007
    Geliefert am 30. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for itself first and then each associate) and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property under t/no DU173092 & DU221943 and k/a land on the south side of heighington lane newton aycliffe assigns all the goodwill and the full benefit of mortgaged licences, assigns the benefit of all guarantees or covenants by any security or sureties of any lessee's obligations under any lease underlease or licence of the property, assigns all of its right title and interest in the mortgaged chattel assets and by way of fixed charge all other fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 14. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 29. Sept. 1995
    Geliefert am 12. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as or being land at grindon way heighington park industrial estate newton aycliffe in the county of durham (also k/as land to the south of heby way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the mortgagor at the mortgaged premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 16. März 1992
    Geliefert am 26. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south side of heighington lane newton aycliffe county durham title no. DU173092.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 26. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. März 1992
    Geliefert am 26. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 26. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 18. Sept. 1991
    Geliefert am 21. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 21. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 12. Jan. 1988
    Geliefert am 16. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 16. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AANE REALISATIONS (NE) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Mai 2020Beginn der Verwaltung
    09. Nov. 2022Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Saunders
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praktiker
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Allan Watson Graham
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praktiker
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Matthew Ingram
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praktiker
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0