HALLBEAT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HALLBEAT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01797949 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HALLBEAT LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HALLBEAT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Allandale Court Waterpark Road M7 4JN Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALLBEAT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. März 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HALLBEAT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. März 2021 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. März 2020 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. März 2019 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. März 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. März 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. März 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. März 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. März 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2014 bis 30. März 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sir Weis als Direktor am 30. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HALLBEAT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIS, Rachel | Sekretär | 1 Allandale Court Waterpark Road M7 4JN Manchester | British | 26417370001 | ||||||
| WEIS, Aubrey | Geschäftsführer | 1 Allandale Court Waterpark Road M7 4JN Manchester | England | British | 9344520001 | |||||
| WEIS, Sir | Geschäftsführer | 1 Allandale Court Waterpark Road M7 4JN Manchester | England | British | 135286870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HALLBEAT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowhurst Ltd | 06. Apr. 2016 | Waterpark Road M7 4JN Salford 41 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HALLBEAT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Direct and third party legal charge | Erstellt am 24. Feb. 2005 Geliefert am 08. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from aubrey weis to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the west side of peasley cross lane, st helens, merseyside t/n MS278840. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment by way of charge of rental income | Erstellt am 01. Juni 2000 Geliefert am 14. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interest the property known as land and buildings on the north side of higher ardwick arwick greater manchester title no. GM309142. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juni 2000 Geliefert am 14. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The leasehold land and buildings on the north side of higher ardwick greater manchester title number GM309142 all buildings and fixtures including trade fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Apr. 1996 Geliefert am 15. Apr. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a united glass limited warehouse peasley cross lane st helens lancs registered as land and buildings on the west side of peasley cross lane st helens t/no MS278840 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge and mortgage | Erstellt am 04. März 1996 Geliefert am 21. März 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £1,100,000 and all other monies due or to become due from the company and/or ingledene fashions limited to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H-land and buildings to the west side of transit way honicknowle devon t/n-DN197776. L/h-land on the north side of higher ardwick greater machester t/n-GM309142. Floating charge over all the undertaking and all property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Dez. 1987 Geliefert am 04. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1-5 thames industrial estate higher ardwick manchester title no gm 309142 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 21. März 1985 Geliefert am 29. März 1985 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2/6 southern industrial estate, walkolen worsley greater manchester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. Juli 1984 Geliefert am 06. Juli 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H falcon house, victoria street, chadderton, greater manchester & l/h property adjoining title no gm 342694 gm 342695. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. März 1984 Geliefert am 12. Apr. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a falcon house (formerly falcon mill) victoria street chadderton, greater manchester l/h property adjoining and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0