LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01800891 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HARGREAVES PHOTOGRAPHIC LIMITED | 16. März 1984 | 16. März 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christiane Brock als Geschäftsführer am 30. Mai 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 018008910009, erstellt am 06. Juni 2016 | 44 Seiten | MR01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Christiane Brock als Direktor am 25. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Colin Halpern als Geschäftsführer am 25. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joseph Clark als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joseph Clark als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andreas Schaefer als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joseph Clark als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andreas Schaefer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Urgo als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAEFER, Andreas | Sekretär | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | 179466190001 | |||||||
SCHAEFER, Andreas | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | Germany | German | Chartered Accountant | 171085060001 | ||||
CLARK, Joseph Ogilvie | Sekretär | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | 159523260001 | |||||||
RICHARDSON, Jonathan Charles | Sekretär | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | British | Director | 118293300001 | |||||
ROSS, Norma Ethel | Sekretär | 14 Leathwood Maghull L31 6AT Liverpool Merseyside | British | 9050900001 | ||||||
SMITH, Stephen Anthony | Sekretär | 12 Chestnut Avenue HA6 1HR Northwood Middlesex | British | Director | 6780200001 | |||||
UNDERWOOD, Paul Laurence | Sekretär | Hill Barn 44a Wappenham Road Helmdon NN13 5QA Brackley Northamptonshire | British | Chartered Accountant | 81277620001 | |||||
BROCK, Christiane | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | Germany | German | Company Director | 205502210001 | ||||
CLARK, Joseph Ogilvie | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | Executive | 72081060002 | ||||
CUNNINGHAM, Anthony Gerald | Geschäftsführer | Cleeve House Weathercock Lane MK17 8NP Woburn Sands Bedfordshire | British | Company Director | 11015530001 | |||||
FISCHER, Andrew Olaf | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | German | Company Director | 70312740034 | ||||
FISHER, Ian | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 51776160030 | ||||
FLETCHER, Alan Thomas | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 14669590002 | ||||
HALPERN, Colin | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | United States | American | Director | 112008300001 | ||||
HARGREAVES, Derek | Geschäftsführer | Greystones The Serpentine North L23 6TJ Blundellsands Liverpool Merseyside England | British | Photographic Dealer | 63245210001 | |||||
HARGREAVES, Neil Rowland | Geschäftsführer | 102 Manor Road Crosby L23 7UU Liverpool Merseyside | British | Accountant | 8697030002 | |||||
KING, Andrea Dorothy | Geschäftsführer | 45 Amberleigh Close Appleton Thorn WA4 4TD Warrington Cheshire | British | Sales Manager | 27567210004 | |||||
LAHERT, Anthony Peter | Geschäftsführer | Woodside Hedgerley Hill SL2 3RL Hedgerley Berkshire | United Kingdom | Irish | Company Director | 79618120001 | ||||
NEWMAN, Francis David Mayow | Geschäftsführer | 31 Springfield Park Twyford RG10 9JG Reading Berkshire | United Kingdom | British | Digital Sales Director | 31790420001 | ||||
RICHARDSON, Jonathan Charles | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | Director | 118293300001 | ||||
SMITH, Stephen Anthony | Geschäftsführer | The Tudor House Week St Mary EX22 6UL Holsworthy | United Kingdom | British | Director | 6780200002 | ||||
STANFORD, Jeffery John | Geschäftsführer | 17 Bowling Leys Middleton MK10 9BD Milton Keynes Buckinghamshire | British | Company Director | 68776690001 | |||||
UNDERWOOD, Paul Laurence | Geschäftsführer | Hill Barn 44a Wappenham Road Helmdon NN13 5QA Brackley Northamptonshire | England | British | Chartered Accountant | 81277620001 | ||||
URGO, Christopher John | Geschäftsführer | Promandis House Bradbourne Drive MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes Buckinghamshire | Usa | American | Chief Financial Officer | 159423310001 |
Hat LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 06. Juni 2016 Geliefert am 06. Juni 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a);. (Ii) all licences to enter upon or us land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets);. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q).. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets), together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which shawbrook may designate as "specified real property".. All defined terms are as defined in the composite guarantee and debenture. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture to the debenture and | Erstellt am 01. Feb. 2011 Geliefert am 11. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each loan party to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The supplemental specified equipment, being: 1 canon eos 1DMKIV serial no 931001099, canon eos 7D, serial no 1580815795, 1 canon eos 7D, serial no 1580816048, and all spare parts and replacements for and all modificiations and additions to the supplemental specified equipment, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Loan and security agreement | Erstellt am 30. Juni 2009 Geliefert am 14. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigned pledged and granted all of its collateral see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Juni 2009 Geliefert am 10. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each loan party to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to the form 395). see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Feb. 1988 Geliefert am 29. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a land at orrell mount, hawthorne road bootle, merseyside and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1988 Geliefert am 18. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land on the north easterly side of hawthorne road litherland lancashire. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 09. Okt. 1987 Geliefert am 15. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H- 33/35 warbreck moor, walton, liverpool, merseyside and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1987 Geliefert am 14. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-31 warbreck moor walton, liverpool, merseyside and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 02. Jan. 1987 Geliefert am 07. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0