LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEEDS PHOTOVISUAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01800891
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HARGREAVES PHOTOGRAPHIC LIMITED 16. März 198416. März 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Christiane Brock als Geschäftsführer am 30. Mai 2016

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 018008910009, erstellt am 06. Juni 2016

    44 SeitenMR01

    Ernennung von Mrs Christiane Brock als Direktor am 25. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Colin Halpern als Geschäftsführer am 25. Feb. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 250,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 12. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 250,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 26. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 250,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Joseph Clark als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Joseph Clark als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Andreas Schaefer als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Joseph Clark als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Andreas Schaefer als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Urgo als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    5 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SCHAEFER, Andreas
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    179466190001
    SCHAEFER, Andreas
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    GermanyGermanChartered Accountant171085060001
    CLARK, Joseph Ogilvie
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    159523260001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector118293300001
    ROSS, Norma Ethel
    14 Leathwood
    Maghull
    L31 6AT Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    14 Leathwood
    Maghull
    L31 6AT Liverpool
    Merseyside
    British9050900001
    SMITH, Stephen Anthony
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    Sekretär
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    BritishDirector6780200001
    UNDERWOOD, Paul Laurence
    Hill Barn 44a Wappenham Road
    Helmdon
    NN13 5QA Brackley
    Northamptonshire
    Sekretär
    Hill Barn 44a Wappenham Road
    Helmdon
    NN13 5QA Brackley
    Northamptonshire
    BritishChartered Accountant81277620001
    BROCK, Christiane
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    GermanyGermanCompany Director205502210001
    CLARK, Joseph Ogilvie
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritishExecutive72081060002
    CUNNINGHAM, Anthony Gerald
    Cleeve House
    Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Cleeve House
    Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Bedfordshire
    BritishCompany Director11015530001
    FISCHER, Andrew Olaf
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomGermanCompany Director70312740034
    FISHER, Ian
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director51776160030
    FLETCHER, Alan Thomas
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director14669590002
    HALPERN, Colin
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United StatesAmericanDirector112008300001
    HARGREAVES, Derek
    Greystones
    The Serpentine North
    L23 6TJ Blundellsands
    Liverpool Merseyside
    England
    Geschäftsführer
    Greystones
    The Serpentine North
    L23 6TJ Blundellsands
    Liverpool Merseyside
    England
    BritishPhotographic Dealer63245210001
    HARGREAVES, Neil Rowland
    102 Manor Road
    Crosby
    L23 7UU Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    102 Manor Road
    Crosby
    L23 7UU Liverpool
    Merseyside
    BritishAccountant8697030002
    KING, Andrea Dorothy
    45 Amberleigh Close
    Appleton Thorn
    WA4 4TD Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    45 Amberleigh Close
    Appleton Thorn
    WA4 4TD Warrington
    Cheshire
    BritishSales Manager27567210004
    LAHERT, Anthony Peter
    Woodside
    Hedgerley Hill
    SL2 3RL Hedgerley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Woodside
    Hedgerley Hill
    SL2 3RL Hedgerley
    Berkshire
    United KingdomIrishCompany Director79618120001
    NEWMAN, Francis David Mayow
    31 Springfield Park
    Twyford
    RG10 9JG Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    31 Springfield Park
    Twyford
    RG10 9JG Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishDigital Sales Director31790420001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector118293300001
    SMITH, Stephen Anthony
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    Geschäftsführer
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    United KingdomBritishDirector6780200002
    STANFORD, Jeffery John
    17 Bowling Leys
    Middleton
    MK10 9BD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    17 Bowling Leys
    Middleton
    MK10 9BD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director68776690001
    UNDERWOOD, Paul Laurence
    Hill Barn 44a Wappenham Road
    Helmdon
    NN13 5QA Brackley
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Hill Barn 44a Wappenham Road
    Helmdon
    NN13 5QA Brackley
    Northamptonshire
    EnglandBritishChartered Accountant81277620001
    URGO, Christopher John
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    UsaAmericanChief Financial Officer159423310001

    Hat LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 06. Juni 2016
    Geliefert am 06. Juni 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a);. (Ii) all licences to enter upon or us land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets);. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q).. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets), together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which shawbrook may designate as "specified real property".. All defined terms are as defined in the composite guarantee and debenture.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Shawbrook Bank Limited T/a Shawbrook Business Credit
    Transaktionen
    • 06. Juni 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    Supplemental debenture to the debenture and
    Erstellt am 01. Feb. 2011
    Geliefert am 11. Feb. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each loan party to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The supplemental specified equipment, being: 1 canon eos 1DMKIV serial no 931001099, canon eos 7D, serial no 1580815795, 1 canon eos 7D, serial no 1580816048, and all spare parts and replacements for and all modificiations and additions to the supplemental specified equipment, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Capital Finance, Inc. (As Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties, the Agent)
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Loan and security agreement
    Erstellt am 30. Juni 2009
    Geliefert am 14. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigned pledged and granted all of its collateral see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Capital Finance Inc. as Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 14. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2009
    Geliefert am 10. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each loan party to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Capital Finance, Inc., as Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 10. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Feb. 1988
    Geliefert am 29. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a land at orrell mount, hawthorne road bootle, merseyside and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Feb. 1988
    Geliefert am 18. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land on the north easterly side of hawthorne road litherland lancashire. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 08. Aug. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Okt. 1987
    Geliefert am 15. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H- 33/35 warbreck moor, walton, liverpool, merseyside and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 1987
    Geliefert am 14. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-31 warbreck moor walton, liverpool, merseyside and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 02. Jan. 1987
    Geliefert am 07. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0