PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01804716 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?
- Formgebung und Verarbeitung von Flachglas (23120) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 9th Floor 3 Hardman Street M3 3HF Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KITE GLASS LIMITED | 31. März 2006 | 31. März 2006 |
| EFCO LIMITED | 21. Mai 1984 | 21. Mai 1984 |
| CHALKCIRCLE LIMITED | 30. März 1984 | 30. März 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 18 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Aug. 2017 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Aug. 2016 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Aug. 2015 | 16 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Aug. 2014 | 19 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 2.12B | |||||||||||
Kündigung eines Administrators | 1 Seiten | 2.38B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Arkwright House Parsonage Gardens Manchester M3 2LF* am 07. März 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Feb. 2014 | 17 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 10 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 2 Seiten | 2.23B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 29 Avro Way Brooklands Business Park Weybridge Surrey KT13 0YZ* am 27. Sept. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 33 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed kite glass LIMITED\certificate issued on 19/08/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 06. Okt. 2011 | 17 Seiten | RP04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Bostock Smith als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS, Theofiel Joannes | Geschäftsführer | Rietstraat 7/2 8400 Oostende FOREIGN Belgium | Belgium | Belgian | 61916960002 | |||||
| REED, Leroy Felix | Geschäftsführer | 3 Hardman Street M3 3HF Manchester 9th Floor | United Kingdom | British | 112412170001 | |||||
| SEYNAEVE, Geraldine | Geschäftsführer | Eksterenberg 50 Essene Affligem 1790 Belgium | Belgium | Belgian | 135686140001 | |||||
| BOSTOCK SMITH, Nicholas | Sekretär | 29 Avro Way Brooklands Business Park KT13 0YZ Weybridge Surrey | British | 112412260001 | ||||||
| CAMPBELL, Carol | Sekretär | 55 Alpha Road KT5 8RU Surbiton Surrey | British | 70049080002 | ||||||
| GRAY, Tim | Sekretär | 10 Ferry Road KT7 0XZ Thames Ditton Surrey | British | 87216190001 | ||||||
| WOOD, Martin James | Sekretär | Rosemary Cottage 1 Vyne Road Sherborne St John RG24 9HX Basingstoke Hampshire | British | 45073950001 | ||||||
| APPLIN, David Jonathon | Geschäftsführer | Whiteways Tangmere Road, Tangmere PO20 6HW Chichester West Sussex | British | 64050710001 | ||||||
| CLEDWYN-DAVIES, Denys Norman | Geschäftsführer | Long Meadow Duckington Lane Broxton CH3 9HS Chester Cheshire | British | 30931460001 | ||||||
| HARRIS, Helmut Werner | Geschäftsführer | 41 Highland Drive GU13 8TH Fleet Hampshire | British | 28866820001 | ||||||
| LEON, Jack Ronald | Geschäftsführer | Sefton Hockering Road GU22 7HG Woking Surrey | British | 17315360001 | ||||||
| MURRAY, Keith Alexander | Geschäftsführer | 5 Barricane GU21 7RB Woking Surrey | England | British | 111744600001 | |||||
| NYS, Theofiel Joannes | Geschäftsführer | Mechelbaan 510 2870 Putte Belgium | Belgian | 61916960001 | ||||||
| SEYNAEVE, Geraldine | Geschäftsführer | Eksterenberg 50 Essene Affligem 1790 Belgium | Belgium | Belgian | 135686140001 | |||||
| SEYNAEVE, Jean-Pierre Arthur Marie | Geschäftsführer | Seyntexlaan 2 8700 Tielt FOREIGN Belgium | Belgian | 61917020001 | ||||||
| VERHOEVEN, Robert Joseph | Geschäftsführer | Halve Maanstraat 24 2890 Sint-Amands FOREIGN Belgium | Belgian | 61917120001 | ||||||
| VICKERS, Kenneth | Geschäftsführer | 32 Francis Way GU15 1EX Camberley Surrey | British | 69739400002 | ||||||
| WOOD, Martin James | Geschäftsführer | Rosemary Cottage 1 Vyne Road Sherborne St John RG24 9HX Basingstoke Hampshire | England | British | 45073950001 | |||||
| BMT NV | Geschäftsführer | Kortrijksesteenweg 1097 B Sint-Denijs-Westrem 9051 Belgium | 132095170001 | |||||||
| EUROVLAS NV | Geschäftsführer | 8700 Tielt Seyntexlaan 3 Belgium | 130904300001 |
Hat PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 25. Jan. 1999 Geliefert am 03. Feb. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. Juli 1997 Geliefert am 11. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise | |
Kurze Angaben F/H land k/a unit h shilton industrial estate rugby warwickshire t/n WK330199, the fixed assets as described in part iii of the form M395. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 1994 Geliefert am 09. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit h shilton industrial estate rugby warwickshire with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 10. Apr. 1992 Geliefert am 14. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed & floating charge d/d 30/06/86 | |
Kurze Angaben All goodwill & uncalled capital....see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral chattel mortgage | Erstellt am 22. Jan. 1990 Geliefert am 25. Jan. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from efco holdings limited to the chargeee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben By way of assignment of the plant machinery chattels or other equipment: serial no. 88015426 - billco 60 "eh washing machine come with pre-spray unit. Located at forsyth road, sheerwater, woking, surrey GU21 5RZ. Together with additions alterations accessories replacements and renewals of component parts thereto (please see doc M395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral chattel mortgage | Erstellt am 14. Juni 1988 Geliefert am 17. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from efco billco limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The plant machinery chattels or other equipment with any part or parts thereof and all additions alterations accessories (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 14. Juni 1988 Geliefert am 17. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from efco billco limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben (Please see doc for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 30. Juni 1986 Geliefert am 07. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 17. Juli 1984 Geliefert am 26. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or efco-billco limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 1984 Geliefert am 23. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 31. Mai 1984 Geliefert am 06. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A) all estates or interests in any f/h or l/h properties b) all stocks and shares c) all book debts d) the goodwill of the company e) the undertaking of the company (see doc M11 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0