LEASECONTRACTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEASECONTRACTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01810100
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEASECONTRACTS LIMITED?

    • Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich LEASECONTRACTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LEASECONTRACTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    JORDANS 160 PUBLIC LIMITED COMPANY18. Apr. 198418. Apr. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEASECONTRACTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEASECONTRACTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2023

    9 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2022

    9 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2021

    9 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2020

    9 SeitenLIQ03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom zum Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 17. Okt. 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Sept. 2019

    LRESSP

    Ernennung von Oakwood Corporate Secretary Limited als Sekretär am 23. Juli 2019

    2 SeitenAP04

    Notification of Key Leasing Limited as a person with significant control on 23. Juli 2019

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Ige Usa Investments Limited as a person with significant control on 23. Juli 2019

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juni 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Norris Andrew Geldard am 04. Feb. 2019

    2 SeitenCH01

    Change of details for Ige Usa Investments as a person with significant control on 23. Nov. 2018

    2 SeitenPSC05

    Beendigung der Bestellung von Anthony William Greenway als Geschäftsführer am 30. Sept. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Norris Andrew Geldard als Direktor am 10. Sept. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul Stewart Girling als Direktor am 10. Sept. 2018

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    20 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom zum 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT am 17. Aug. 2018

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juni 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Notification of Ige Usa Investments as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Wer sind die Geschäftsführer von LEASECONTRACTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer7038430
    146358090001
    GELDARD, Norris Andrew
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish244576750001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    ABBOTT, Courtenay
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Sekretär
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    172560620001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    Sekretär
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    British45103500001
    ESSEX, Alicia
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    Sekretär
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    British55569560002
    FRENCH, Ann
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Sekretär
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    161504050001
    JOHNSON, Paul Robert
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Sekretär
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    British106143590001
    KERSHAW, Simon John
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    British106236300001
    PATMORE, Ian Robert
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    Sekretär
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    British64498630002
    PEERMOHAMED, Zahra
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    Sekretär
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    192967230001
    RYLATT, Diane
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    Sekretär
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    British46068950001
    TAYLOR, Timothy John
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    British42497260001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Sekretär
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ANDERSON, Roger
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    British60138290001
    BECQUE, Geoffrey Frederick
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish14428770001
    BURR, Jonathan Charles
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish49902210001
    CHAPMAN, Mark Andrew
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    Geschäftsführer
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    British54283410002
    CHAPMAN, Mark Andrew
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    Geschäftsführer
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    British54283410001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    EnglandBritish45103500001
    D'ADDA, Alessandro Pietro
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish47772540001
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Geschäftsführer
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Australian28868820001
    DUFF, Paul Anthony
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    British122035530001
    FARRAR, Daniel
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    British42497200001
    FITZPATRICK, Hugh Alan Taylor
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish139406230001
    FORD, Toby Duncan
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    United KingdomBritish148654320001
    GREEN, Richard William
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    British121346530001
    GREENWAY, Anthony William
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish202871130001
    HUDDART, Steven John
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    EnglandEnglish191546760001
    JEANS, Roderick Manning
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    British50601570001
    JENKINS, John Michael
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    Geschäftsführer
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    EnglandBritish115008010001
    KILLEEN, Gary Francis Paul
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    EnglandEnglish81330540001
    LANGDON, Michael Robert Finch
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    Geschäftsführer
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    EnglandBritish1483050001
    LOMAS, Paul John
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish127596100001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LEASECONTRACTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    23. Juli 2019
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer1500252
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3255766
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat LEASECONTRACTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge agreement
    Erstellt am 02. Aug. 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £404,822.57 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements date 7/6/95 contract no 1030474 vehicle hire agreement model vauxhall brava 2.5I a/c no 34. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 02. Aug. 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £45,553.63 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements :- date 2.6.95 contract no 1030728 vehicle hire agreement model ford transit 2.5 regn no M289 yhj a/c/no 22. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 02. Aug. 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £160,099.17 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 02. Aug. 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £349,787.92 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights title and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 02. Aug. 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £87,116.29 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 02. Aug. 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £13,933.14 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 02. Aug. 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £27,772.02 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First charge
    Erstellt am 28. Juni 1995
    Geliefert am 12. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12TH december 1994 and/or this charge
    Kurze Angaben
    The company assigns and charges to the bank by way of first fixed legal charge:- (I) all the benefits rights and title of the company in the contracts; and (ii) each and every motor vehicle from time to time subject of the contracts (the "motor vehicles"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 12. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment
    Erstellt am 26. Juni 1995
    Geliefert am 01. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    Kurze Angaben
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements :- sub-hirer sony united kingdom limited ford mondeo 2OI glx h/back regn no M301 mpd. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Finances PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment
    Erstellt am 04. Mai 1995
    Geliefert am 09. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    Kurze Angaben
    All rights benefits and interest present and future in and to sub-hire agreements made between various sub-hirers. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Finance PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment
    Erstellt am 19. Apr. 1995
    Geliefert am 26. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreemnts
    Kurze Angaben
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees :- customer no 021766 schedule no 000015 agreement no 01/308/01/513884 reg no M29 eea rover 214SE1 41 customer ref 1028472. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nws Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 23. März 1995
    Geliefert am 08. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £222,479.54 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights title and interest of the company in the attached schedule contract no 1027675 agreement vehicle contract purchase reg no M217 odp make rover 2.0I. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 23. März 1995
    Geliefert am 29. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £221,528.88 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All the rights title and interest of the company in and under the agreements ,as specified in the schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements,all monies from time to time payable under any insurance payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 29. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 23. März 1995
    Geliefert am 29. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,555.25 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under or pursuant to the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and under the said agreements ,all monies now or hereafter to become payable under the agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all monies from time to time payable under the insurance in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 29. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 23. März 1995
    Geliefert am 29. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £229,169.13 together with all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    Specific charge over all the rights and interests of the company under the agreements specified in the schedule, all monies now or hereafter to become payable under the said agreements , the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all insurances payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 29. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment
    Erstellt am 09. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreements
    Kurze Angaben
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nws Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master assignment
    Erstellt am 05. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agrements
    Kurze Angaben
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedules attached to the form 395 entered into pursuant to the master assignment.
    Berechtigte Personen
    • Nws Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 25. Nov. 1994
    Geliefert am 02. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £359,353.33 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements date-22.9.94, Contract no.-1025575, Type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-48, reg no-M113 xow, make/model-honda civic. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 25. Nov. 1994
    Geliefert am 02. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £135,919.45 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements date-8.11.94, Contract no-1025865, type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-42, reg no-M108 njb, make/model-renault 19. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 25. Nov. 1994
    Geliefert am 02. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £36,467.67 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements date-25.10.94, Contract no.-1026204, Type of agreement-schedule to master agreement, period of agt-12, reg no.-M791 jpf, make/model-rover 200 1.4I. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 25. Nov. 1994
    Geliefert am 02. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £58,680.10 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements date-28.9.94, Contract no.-1026224, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-24, reg no.-L416 kto, make/model-vw passat. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 25. Nov. 1994
    Geliefert am 02. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £47,047.49 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements date-18.10.94, Contract no-1026870, type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-28, reg no.-L753JCF, make/model-vauxhall frontera. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 25. Nov. 1994
    Geliefert am 02. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £270,688.25 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements date-9.11.94, Contract no.-1027231, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-36, reg no.-L688 sav, make/model-rover 600 2.01. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master assignment and certificte of assignment
    Erstellt am 03. Nov. 1994
    Geliefert am 04. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement of even date
    Kurze Angaben
    All rights benefit and interest present and future in and 70 sub-hiring agreements :- ford granada 2.01 scorpio 4 dr saloon sin auto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Finance PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 13. Juli 1994
    Geliefert am 16. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £107,344.53 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement.
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the agreements specified in the attached schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements. The vehicles comprised in and the subject of the said agreements as specified in the said schedule, and all monies from time to time payable under any insurance in respect of the said vehicles. The terms applicable to the charge agreement restrict the creation of any other charge whatsoever over the charged property.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LEASECONTRACTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Juni 2024Soll aufgelöst werden am
    26. Sept. 2019Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0