SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01814719 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED?
- (6603) /
Wo befindet sich SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o RSM TENON RECOVERY 3rd Floor Lyndean House 43-46 Queens Road BN1 3XB Brighton East Sussex |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
R.F. BAILEY (UNDERWRITING AGENCIES) LIMITED | 16. Aug. 1984 | 16. Aug. 1984 |
HARVESTBOND LIMITED | 09. Mai 1984 | 09. Mai 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Jan. 2012 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 18 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:c/o replacement of liquidator | 16 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Monks Gate House Brighton Road Monks Gate Horsham West Sussex RH13 6JD United Kingdom am 17. Dez. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Jephcott am 26. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVANS, Sally Maria | Sekretär | The Flat 2 South Way BN9 9LL Newhaven East Sussex | British | Hr Manager | 70233920001 | |||||
JEPHCOTT, Mark Lanwer | Geschäftsführer | Monks Gate RH13 6JD Nr Horsham Monks Gate House West Sussex | England | British | Accountant | 149128840001 | ||||
ASPINALL, Lawrence | Sekretär | 4 Clarence Place Windmill Hill DA12 1LD Gravesend Kent | British | 108025510001 | ||||||
BRANDON, James Roderick Vivian | Sekretär | 20a Stanley Road SW19 8RF London | British | Chartered Accountant | 22233590004 | |||||
FORRESTER, Fiona Maureen | Sekretär | 22 Elm Bank Gardens Barnes SW13 0NT London | British | 87730350001 | ||||||
GORDON, Anthony John Ramsay | Sekretär | The Bell House Harborough Hall Lane, Messing CO5 9UA Colchester Essex | British | Finance Director | 69424310001 | |||||
GORDON, Anthony John Ramsay | Sekretär | The Bell House Harborough Hall Lane, Messing CO5 9UA Colchester Essex | British | Financial Director | 69424310001 | |||||
JEPHCOTT, Mark | Sekretär | Jenners RH17 7QL Wivelsfield Green East Sussex | British | 37760460001 | ||||||
SAUNDERS, Patricia Margaret | Sekretär | 15 Cross Road SS7 1RP Benfleet Essex | British | 76398070001 | ||||||
TRACE, David John Arthur | Sekretär | 88 Burbage Road SE24 9HE London | British | Finance Director | 69865770001 | |||||
WHITTINGTON MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Sekretär | 33 Creechurch Lane EC3A 5EB London | 100196290002 | |||||||
ASPINALL, Lawrence | Geschäftsführer | 4 Clarence Place Windmill Hill DA12 1LD Gravesend Kent | England | British | Chartered Accountant | 108025510001 | ||||
BAILEY, Ralph Francis | Geschäftsführer | 10 Grove Terrace NW5 1PH London | British | Underwriter | 13525480001 | |||||
BRANDON, James Roderick Vivian | Geschäftsführer | 20a Stanley Road SW19 8RF London | British | Chartered Accountant | 22233590004 | |||||
CHAPMAN, Donald Shelton | Geschäftsführer | 14552 183rd Avenue Ne Woodinville FOREIGN King Washington 98072 Usa | American | Insurance Company Officer | 62141630001 | |||||
CHARKIN, Michael Anthony | Geschäftsführer | 150 Ireton Avenue KT12 1EN Walton-On-Thames Starlings England | British | Consultant | 132715460001 | |||||
DESBOROUGH, Graham | Geschäftsführer | Highlands 9 Oldfield Road BR4 2LE Bromley Flat 3 Kent | United Kingdom | British | 139605880001 | |||||
DOROW, Alvin Wayne | Geschäftsführer | 1607 2nd Avenue North FOREIGN Seattle King 98109 3133 Usa | American | Insurance | 79236960001 | |||||
FLISHER, John Rankine | Geschäftsführer | 130 The Water Gardens W2 2DE London | British | 10816020001 | ||||||
GALE, Jonathan David | Geschäftsführer | Brownings Stockers Hill Road, Rodmersham ME9 0PL Sittingbourne Kent | British | Underwriter | 65234100002 | |||||
GORDON, Anthony John Ramsay | Geschäftsführer | The Bell House Harborough Hall Lane, Messing CO5 9UA Colchester Essex | British | Financial Director | 69424310001 | |||||
HANBURY, Nigel John | Geschäftsführer | Hill Ash Farm West Harting GU31 5NY Petersfield Hampshire | England | British | Company Director | 37953650001 | ||||
HAZLEWOOD, David | Geschäftsführer | 3 Glen Avenue CO3 3RP Colchester Essex | British | Lloyds Underwriting Agent | 10433970001 | |||||
JACKSON, Robin Anthony Gildart | Geschäftsführer | Greenvale Farm Browns Lane Cross In Hand TN21 0QJ Heathfield East Sussex | British | Underwriter Retired | 17588050002 | |||||
LAUER, Dale Ellis | Geschäftsführer | 14103 205th Avenue Ne Woodinville Wa 98072 Usa | Usa | President Chief Executive Offi | 80853380001 | |||||
MUMFORD, John Edward | Geschäftsführer | Thorndon Approach Herongate CM13 3PA Brentwood Rowlandson House Essex | England | British | Consultant | 131981410001 | ||||
OLSEN, Philip Vernon | Geschäftsführer | 34 Lebanon Park TW1 3DG Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Insurance Consultant | 20752310002 | ||||
PIERSON, Rodney Allan | Geschäftsführer | 15737 N E 134th Street 98052 Redmond King County Washington Usa | American | Insurance Company Officer | 60263430001 | |||||
PRYKE, John William | Geschäftsführer | Ridgetop 188 Hanging Hill Lane Hutton CM13 2QH Brentwood Essex | Uk | British | Underwriter | 10567650001 | ||||
STURROCK, Ian Thornton Stewart | Geschäftsführer | 13 Craven Hill Gardens W2 3EH London | British | Corporate Services Director | 12847630001 | |||||
TAYLOR, John Joseph | Geschäftsführer | 14 The Grove DA6 8HF Bexleyheath Kent | British | Members Agent | 3787030001 | |||||
TRACE, David John Arthur | Geschäftsführer | 88 Burbage Road SE24 9HE London | United Kingdom | British | Finance Director | 69865770001 | ||||
WHITE, Graham John | Geschäftsführer | Toad Hall Glebe House 38 High Street Melbourn SG8 6DZ Royston Hertfordshire | England | British | Insurance Broker | 116735630001 | ||||
WILKINSON, Duncan James | Geschäftsführer | 356 Rochester Road ME20 7ED Aylesford Kent | United Kingdom | British | Insurance | 93991610002 |
Hat SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge over experience account | Erstellt am 07. Jan. 2005 Geliefert am 27. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the members of the lloyd's syndicates to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the deposit, the experience account, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit and the experience account and by way of floating charge all entitlements to interest on the deposit being £18,346,448.67. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SYNDICATE 138 AGENCY LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0