ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED

ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01817913
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    • Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TOREX RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED12. Juni 200212. Juni 2002
    AMERSHAM MEDICAL SYSTEMS LIMITED21. Mai 198421. Mai 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2013 bis 30. Sept. 2013

    3 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Thomson als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Kapitalaufstellung am 24. Juni 2013

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Company business 29/03/2013
    RES13

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Ernennung von David William Hart Gray als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Gareth Wilson als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    15 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    34 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Beendigung der Bestellung von Adrian Stevens als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    17 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2012 bis 31. März 2012

    1 SeitenAA01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Charles Stevens am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew James Edward Thomson am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gareth Antony Wilson am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrea Fiumicelli am 12. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* am 18. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* am 05. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357740001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    BritishComputer Consultant17678130002
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Sekretär
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Sekretär
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Sekretär
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    British5361780001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162045740001
    CLARKE, Robert Samuel
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishSales & Marketing44712370001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Geschäftsführer
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    COWLES, Neil
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    BritishDirector79753520001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director17678130002
    DAY, Robert William
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector66520250001
    EALES, Gillian Margaret
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    BritishBusiness Administrator16296060001
    FRANKS, Nigel
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director39004110002
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector45513680001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MACKAY, James Gordon
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant178097680001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    BritishDoctor5361780001
    MORRIS, Eamonn
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector65876940001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    RAWCLIFFE, Richard William
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    BritishDirector86831530001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Geschäftsführer
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    RICHARDS, Paul
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector82595090001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WATSON, Robert John
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director16296070002
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Geschäftsführer
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishDirector105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishFinance Director74738270002

    Hat ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 13. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of accession
    Erstellt am 27. Nov. 2007
    Geliefert am 13. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principal borrower, each chargor and each other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H suite 304 spirella building bridge road letchworth garden city herts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Trustee and Agent for the Lenders as Defined in the Facility Agreement)(the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 24. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Erstellt am 13. Apr. 2006
    Geliefert am 28. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998
    Erstellt am 08. Aug. 2002
    Geliefert am 16. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Apr. 2001
    Geliefert am 07. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0