ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01817913 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Royal Pavilion Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Hampshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TOREX RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED | 12. Juni 2002 | 12. Juni 2002 |
AMERSHAM MEDICAL SYSTEMS LIMITED | 21. Mai 1984 | 21. Mai 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2013 bis 30. Sept. 2013 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Thomson als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. Juni 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Ernennung von David William Hart Gray als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gareth Wilson als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 34 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Stevens als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2012 bis 31. März 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Charles Stevens am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew James Edward Thomson am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gareth Antony Wilson am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrea Fiumicelli am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* am 18. Aug. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* am 05. Aug. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAY, David William Hart | Sekretär | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | British | 177357740001 | ||||||
FIUMICELLI, Andrea | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Italy | Italian | Company Director | 135619020001 | ||||
CRABTREE, Nicholas Patrick | Sekretär | Sherwood 11 Green Lane Chesham Bois HP6 5LN Amersham Buckinghamshire | British | Computer Consultant | 17678130002 | |||||
EDELMAN, Howard Todd | Sekretär | Elizabeth Bay Road 2011 Elizabeth Bay 84/108 Nsw Australia | Australian | Company Secretary | 126124430005 | |||||
HILL, Teifion Mark | Sekretär | 59 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7HZ Stockport Cheshire | British | 100105520001 | ||||||
HORN, Nigel David | Sekretär | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||
MEIRE, Hylton Bruce | Sekretär | 30 Durham Avenue BR2 0QB Bromley Kent | British | 5361780001 | ||||||
WILSON, Gareth Antony | Sekretär | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | 162045740001 | |||||||
CLARKE, Robert Samuel | Geschäftsführer | 4 Lyne Way Warners End HP1 3PL Hemel Hempstead Hertfordshire | British | Sales & Marketing | 44712370001 | |||||
COHEN, Gary Michael | Geschäftsführer | 178 Hopetoun Avenue, Watsons Bay Nsw 2030 Australia | Australia | Australian | Company Director | 125992970001 | ||||
COWLES, Neil | Geschäftsführer | 37 Oldborough Drive CV35 9HQ Loxley Warwickshire | British | Director | 79753520001 | |||||
CRABTREE, Nicholas Patrick | Geschäftsführer | Sherwood 11 Green Lane Chesham Bois HP6 5LN Amersham Buckinghamshire | England | British | Finance Director | 17678130002 | ||||
DAY, Robert William | Geschäftsführer | Weathertop Blackmires Lane, Silverstone NN12 8UZ Towcester Northamptonshire | British | Director | 66520250001 | |||||
EALES, Gillian Margaret | Geschäftsführer | 20 Woodside Road Bickley BR1 2ES Bromley Kent | British | Business Administrator | 16296060001 | |||||
FRANKS, Nigel | Geschäftsführer | 8 Herston Close HP21 9UR Aylesbury Buckinghamshire | British | Operations Director | 39004110002 | |||||
GARRINGTON, Stephen John | Geschäftsführer | 15 Chesterton Close Hunt End B97 5XS Redditch Worcestershire | British | Director | 45513680001 | |||||
GRAHAM, Stephen Paul | Geschäftsführer | Brackenridge Mereside Road WA16 6QR Mere Cheshire | United Kingdom | British | Director | 97528710001 | ||||
HENRY, William Patrick | Geschäftsführer | 9 Grafton Road GL50 2ET Cheltenham Gloucestershire | England | American | Company Director | 119049370001 | ||||
JAMES, Gavin Keith, Mr. | Geschäftsführer | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | Finance Director | 44173560008 | ||||
KUMAR, Ravi | Geschäftsführer | 14 Parkham Close Daisy Hill Westhaughton BL5 2GT Bolton Lancashire | British | Company Director | 101025710001 | |||||
MACKAY, James Gordon | Geschäftsführer | Daventry Road OX16 3JT Banbury Isoft Group Plc Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 178097680001 | ||||
MACKAY, James Gordon | Geschäftsführer | Pogles Wood Widmoor HP10 0JG Wooburn Green Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 178097680001 | ||||
MEIRE, Hylton Bruce | Geschäftsführer | 30 Durham Avenue BR2 0QB Bromley Kent | British | Doctor | 5361780001 | |||||
MORRIS, Eamonn | Geschäftsführer | 25 Coppinger Wood IRISH Blackrock Co Dublin Ireland | Ireland | Irish | Director | 65876940001 | ||||
PEARMAN, Mark Chalice | Geschäftsführer | The Old Rectory Honiley CV8 1NP Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 57516220003 | ||||
RAWCLIFFE, Richard William | Geschäftsführer | 113 Towngate Eccleston PR7 5QS Chorley Lancashire England | British | Director | 86831530001 | |||||
RICHARDS, Paul | Geschäftsführer | The Barn Green Lane South Newington OX15 4JH Banbury | United Kingdom | British | Company Director | 126777780001 | ||||
RICHARDS, Paul | Geschäftsführer | The New Barn Grange Farm South Newington OX15 4JW Banbury Oxfordshire | British | Director | 82595090001 | |||||
STEVENS, Adrian Charles | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Company Director | 76964750002 | ||||
THOMSON, Andrew James Edward | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 147270780001 | ||||
WATSON, Robert John | Geschäftsführer | Holly House Felden Lane Felden HP3 0BF Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | Managing Director | 16296070002 | ||||
WHELAN, John | Geschäftsführer | 26 Lynton Park Road SK8 6JA Cheadle Hulme Cheshire | Uk | British | Director | 105872500001 | ||||
WHISTON, Timothy Andrew | Geschäftsführer | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | England | British | Director | 69575560002 | ||||
WOODBRIDGE, Mark Gavin | Geschäftsführer | The Bungalow Marton CV23 9RS Rugby Warwickshire | British | Finance Director | 74738270002 |
Hat ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Erstellt am 30. Dez. 2009 Geliefert am 13. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of accession | Erstellt am 27. Nov. 2007 Geliefert am 13. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental guarantee and debenture | Erstellt am 24. Aug. 2006 Geliefert am 31. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the principal borrower, each chargor and each other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H suite 304 spirella building bridge road letchworth garden city herts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 24. Aug. 2006 Geliefert am 31. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003 | Erstellt am 13. Apr. 2006 Geliefert am 28. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998 | Erstellt am 08. Aug. 2002 Geliefert am 16. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Apr. 2001 Geliefert am 07. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0