PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01829656 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o PITMANS LLP 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift C/O Pitmans Llp 47 Castle Street Reading Berkshire RG1 7SR verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Pitsec Ltd als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Parry als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Danielle Rios Royston als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Simon Price als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Redwood House Rectory Lane Berkhamsted Hertfordshire HP4 2DH* am 24. Juli 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Monica Tourlamain als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Samuel Jackson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christina Baker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITSEC LTD | Sekretär | Castle St RG1 7SR Reading 47 Berkshire United Kingdom |
| 129561800001 | ||||||||||
| PRICE, Andrew Simon | Geschäftsführer | Congress Avenue Suite 2650 TX78701 Austin 401 Texas Usa | United States | American | 167804590001 | |||||||||
| ROYSTON, Danielle Rios | Geschäftsführer | Congress Avenue Suite 2650 TX78701 Austin 401 Texas Usa | Usa | Usa | 168963450001 | |||||||||
| CLIFFORD, Paul Leighton | Sekretär | Waldegrave Gardens TW1 4PH Twickenham 43 Middlesex | British | 2779380001 | ||||||||||
| MCANDREW, Jonathan Paul | Sekretär | 125 Sandringham Road WD2 4BD Watford Hertfordshire | British | 39300770001 | ||||||||||
| PARRY, David Richard | Sekretär | 17 Park View Road HP4 3EY Berkhamstead Hertfordshire | British | 46936220001 | ||||||||||
| PARRY, David Richard | Sekretär | 17 Park View Road HP4 3EY Berkhamstead Hertfordshire | British | 46936220001 | ||||||||||
| POONWASIE, Rudy | Sekretär | 167 Holtwhites Hill EN2 8BX Enfield Middlesex | British | 69416810001 | ||||||||||
| RANKIN, Karen | Sekretär | 19 Church Road Ivinghoe LU7 9EH Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 38798560001 | ||||||||||
| PITSEC LIMITED | Sekretär | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | 38734010001 | |||||||||||
| BAKER, Christina Jane | Geschäftsführer | Bullbeggars Lane HP4 2RS Berkhamsted The Cottage Hertfordshire | England | British | 40935520004 | |||||||||
| CHICK, Gareth John | Geschäftsführer | The Old Bakery Bakers Lane Upper Tadmarton OX15 5TB Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 111772860002 | |||||||||
| CLIFFORD, Paul Leighton | Geschäftsführer | Waldegrave Gardens TW1 4PH Twickenham 43 Middlesex | England | British | 2779380001 | |||||||||
| COWAN, Gerald | Geschäftsführer | 94 Aldenham Road WD2 2EX Watford Hertfordshire | British | 39898290001 | ||||||||||
| JACKSON, Samuel | Geschäftsführer | 36 London Road HP4 2NE Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 30036970004 | |||||||||
| NEWMAN, Martin Berndt | Geschäftsführer | 2 St Andrews Close RG45 6UP Crowthorne Berkshire | German | 51678280001 | ||||||||||
| RANKIN, Karen | Geschäftsführer | 19 Church Road Ivinghoe LU7 9EH Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 38798560001 | ||||||||||
| SELVEY, Garth Robert | Geschäftsführer | Glebe House 17 Rupert Avenue HP12 3NG High Wycombe Bucks | United Kingdom | British | 33898630001 | |||||||||
| SKINNER, Gordon William Ford | Geschäftsführer | 8 Framewood Manor Framewood Road SL2 4QR Fumer Buckinghamshire | British | 35216360001 | ||||||||||
| TOURLAMAIN, Monica Mary | Geschäftsführer | Trees The Crescent PO20 8EE West Wittering West Sussex | United Kingdom | British | 40935570002 | |||||||||
| WRIGHT, Frederick Allan, Mr. | Geschäftsführer | 100 Wycombe Road SL7 3JE Marlow Buckinghamshire | England | British | 37125870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologic Limited | 06. Apr. 2016 | 47 Castle Street RG1 7SR Reading C/O Pitmans England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PROLOGIC COMPUTER CONSULTANTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 05. Juli 2004 Geliefert am 15. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 05. Juli 2004 Geliefert am 15. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of a life policy | Erstellt am 01. Nov. 2000 Geliefert am 10. Nov. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Life policy with cassidy davis insurance group (policy number Y0064/02) dated 27 october 2000 assuring the life of christina jane brown for the sum of £500,000 exclusive of bonus. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of a life policy | Erstellt am 03. Okt. 2000 Geliefert am 18. Okt. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Life policy with scottish provident (policy number 10046769) assuring the life of samuel jackson for the sum of £500,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of a life policy | Erstellt am 03. Okt. 2000 Geliefert am 18. Okt. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Life policy with scottish provident (policy no. 10046777) assuring the life of monica mary tourlamain for the sum of £500,000 exclusive of bonus. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 25. Nov. 1999 Geliefert am 27. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a contract of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Nov. 1999 Geliefert am 27. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 25. Nov. 1999 Geliefert am 27. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All money including bonuses tht has accrued or may become payable under policy number 118662 and the benefit of all options and rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 25. Nov. 1999 Geliefert am 27. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All money including bonuses tht has accrued or may become payable under policy number 118767 and the benefit of all options and rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 25. Nov. 1999 Geliefert am 27. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All money including bonuses tht has accrued or may become payable under policy number a 12624857 y and the benefit of all options and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 23. Mai 1995 Geliefert am 01. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 1988 Geliefert am 12. Dez. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0