PU REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePU REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01829741
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PU REALISATIONS LIMITED?

    • (2852) /
    • (3162) /

    Wo befindet sich PU REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    D T E House
    Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PU REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    POWER UNITS (1953) LIMITED10. Dez. 198410. Dez. 1984
    J.L.M. ENGINEERING SERVICES LIMITED21. Sept. 198421. Sept. 1984
    E.R.F.SERVICES LIMITED03. Juli 198403. Juli 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PU REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2008
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Okt. 2009
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PU REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis31. Dez. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung14. Jan. 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PU REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für PU REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2013

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Feb. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Aug. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Feb. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Aug. 2011

    7 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Feb. 2011

    6 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Feb. 2010

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    14 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Aug. 2009

    10 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    33 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten403a

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed power units (1953) LIMITED\certificate issued on 05/02/09
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    31 Seiten395

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von PU REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOLE, Andrew Gavin
    15 Brenig Close
    CF62 7BL Barry
    South Glamorgan
    Sekretär
    15 Brenig Close
    CF62 7BL Barry
    South Glamorgan
    British119287960001
    EVANS, Robert William
    Beech Court
    Broadway Llanblethian
    CF71 7EY Cowbridge
    Geschäftsführer
    Beech Court
    Broadway Llanblethian
    CF71 7EY Cowbridge
    WalesWelsh112999710001
    HONEY, Debra Louise
    Olchfa Lodge 303 Gower Road
    Sketty
    SA2 7AA Swansea
    West Glamorgan
    Sekretär
    Olchfa Lodge 303 Gower Road
    Sketty
    SA2 7AA Swansea
    West Glamorgan
    British66216040001
    HONEY, Michael Brian
    11 Hollybush Drive
    Tycoch
    SA2 9JD Swansea
    West Glamorgan
    Sekretär
    11 Hollybush Drive
    Tycoch
    SA2 9JD Swansea
    West Glamorgan
    British22847910001
    RILEY, Vance Henry
    Maes-Y-Coed 6 Penybryn Road
    Brynmenyn
    CF32 9HT Bridgend
    Mid Glamorgan
    Sekretär
    Maes-Y-Coed 6 Penybryn Road
    Brynmenyn
    CF32 9HT Bridgend
    Mid Glamorgan
    British51297170001
    DOVEY, Leonard
    16 Charlemont House
    Rochestown Road
    IRISH Cork
    Eire
    Geschäftsführer
    16 Charlemont House
    Rochestown Road
    IRISH Cork
    Eire
    IrelandBritish3963570003
    HANBURY, Clive Andrew
    117 Maes Ty Canol
    Baglan
    SA12 8US Port Talbot
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    117 Maes Ty Canol
    Baglan
    SA12 8US Port Talbot
    West Glamorgan
    British22847920001
    HONEY, Michael Brian
    Olchfa Lodge 303 Gower Road
    Sketty
    SA2 7AA Swansea
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    Olchfa Lodge 303 Gower Road
    Sketty
    SA2 7AA Swansea
    West Glamorgan
    United KingdomBritish22847910002

    Hat PU REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 17. Dez. 2008
    Geliefert am 20. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bibby Financial Services Limited
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    All assets debenture
    Erstellt am 29. Nov. 2007
    Geliefert am 04. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2005
    Geliefert am 28. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Sept. 2004
    Geliefert am 11. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Sept. 1996
    Geliefert am 16. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at olchfa house gower road sketty swansea t/n WA799270 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Nov. 1995
    Geliefert am 20. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a alexandra house 307/315 cowbridge road east canton cardiff and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Juli 1995
    Geliefert am 18. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 11. Mai 1992
    Geliefert am 14. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement entitled "prompt credit application"
    Erstellt am 02. Mai 1991
    Geliefert am 15. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £28923.74 being the total amount payable by the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement.
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to all sums payable under the insurance. (Please see M395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Apr. 1991
    Geliefert am 03. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 26. März 1991
    Geliefert am 04. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Nov. 1989
    Geliefert am 30. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or caird group PLC and/or caird environmental limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 15. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 06. Dez. 1985
    Geliefert am 17. Dez. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 04. Apr. 1985
    Geliefert am 16. Apr. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1985Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Sept. 1984
    Geliefert am 22. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1984Registrierung einer Belastung

    Hat PU REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    2
    DatumTyp
    05. Feb. 2009Beginn der Verwaltung
    08. Feb. 2010Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Poxon
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Praktiker
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Paul Reeves
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    John Malcolm Titley
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Praktiker
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    3
    DatumTyp
    08. Feb. 2010Beginn der Liquidation
    14. Aug. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Poxon
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancashire
    Praktiker
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancashire
    Paul Reeves
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    John Malcolm Titley
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancs
    Praktiker
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancs

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0