EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01831705 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?
- Eigenhandel mit Wertpapieren (64991) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharines Way E1W 1DD London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED | 31. März 2004 | 31. März 2004 |
LCF ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED | 19. Juli 2000 | 19. Juli 2000 |
L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED | 10. Sept. 1984 | 10. Sept. 1984 |
PATHALTON LIMITED | 11. Juli 1984 | 11. Juli 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 15 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Carlton Gardens London SW1Y 5AA zum C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD am 24. Sept. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 4 Carlton Gardens London SW1Y 5AA geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sabine Rabald als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gareth Austin Rippon Long als Geschäftsführer am 30. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Nicholas John Hay als Geschäftsführer am 31. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 31. Dez. 2016
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 22 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Denis Joseph Claude Gilles De Montigny als Geschäftsführer am 30. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John William Hewitson als Geschäftsführer am 31. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Denis Joseph Claude Gilles De Montigny als Direktor am 07. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUTTS, Eric Joseph | Geschäftsführer | Tower Bridge House St Katharines Way E1W 1DD London C/O Mazars Llp | France | English | Investment Banker | 195873440001 | ||||
HORNER, Elizabeth Anne | Geschäftsführer | Tower Bridge House St Katharines Way E1W 1DD London C/O Mazars Llp | England | British | General Counsel | 147119570001 | ||||
COOPER, Anne Sieona Petie | Sekretär | Greygates Warren Road TN6 1QN Crowborough East Sussex | British | 52030630001 | ||||||
MADDISON, Patrick James Robson | Sekretär | Oak Tree Cottage Maddox Lane Little Bookham KT23 3BT Leatherhead Surrey | British | 16217330001 | ||||||
MADDISON, Patrick James Robson | Sekretär | Oak Tree Cottage Maddox Lane Little Bookham KT23 3BT Leatherhead Surrey | British | 16217330001 | ||||||
ALEXANDER, John Bernard | Geschäftsführer | Old Rectory OX44 7JG Great Haseley Oxfordshire | England | United Kingdom | Merchant Banker | 23013570001 | ||||
ALTMANN, David Peter | Geschäftsführer | Priory Cottage South Mill Street Steventon OX13 6SP Abingdon Oxfordshire | British | Stockbroker | 30828020003 | |||||
BONFIELD, John Anthony | Geschäftsführer | 30 Burghley Road SW19 5HN London | British | Stockbroker | 56236200001 | |||||
BRIANCE, Richard Henry | Geschäftsführer | 13 Holland Street W8 4NA London The Old House England | England | British | Ceo | 16636440001 | ||||
DE MONTIGNY, Denis Joseph Claude Gilles | Geschäftsführer | Carlton Gardens SW1Y 5AA London 4 | Luxembourg | Luxembourger | Accountant | 200877180001 | ||||
DRUMMOND, John Leitch | Geschäftsführer | Latimers Wendens Ambo CB11 4LQ Saffron Walden Essex | British | Investment Advisor | 30828010001 | |||||
ELMAN, Andrew Mark | Geschäftsführer | Carlton Gardens SW1Y 5AA London 4 England | United Kingdom | British | Banker | 59954220004 | ||||
FORDHAM, Kevin Lindsay | Geschäftsführer | 159 Forest Road TN2 5JP Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Investment Banker | 29835100001 | ||||
FUNAKI, Hiroshi | Geschäftsführer | Orion House 5 Upper St Martins Lane WC2H 9EA London | England | British | Head Of Research | 156927690001 | ||||
HAY, Andrew Nicholas John | Geschäftsführer | 10 Favart Road SW6 4AZ London | United Kingdom | British | Banker | 64172700001 | ||||
HEATHFIELD, Claire Louise | Geschäftsführer | 53 Warwick Gardens W14 8PL London | England | British | Investment Advisor | 75061300002 | ||||
HEWITSON, John William | Geschäftsführer | Carlton Gardens SW1Y 5AA London 4 England | England | English | Sales Trader | 170530830001 | ||||
JONES BATEMAN, Richard Stephen | Geschäftsführer | Bretton House Fosseway GL54 1JU Stow On The Wold Gloucestershire | British | Investment Advisor | 30828030002 | |||||
JOUINOT, Patrick-Joel | Geschäftsführer | 6 Darlan Road SW6 5BT London | England | French | Investment Banker | 104267410001 | ||||
LAMBOURNE, Douglas Ivan | Geschäftsführer | 55 Waldemar Avenue W13 9PZ London | British | Investment Banker | 87042370001 | |||||
LONG, Gareth Austin Rippon | Geschäftsführer | Carlton Gardens SW1Y 5AA London 4 England | England | English | Settlements Manager | 171854950001 | ||||
MADDISON, Patrick James Robson | Geschäftsführer | Oak Tree Cottage Maddox Lane Little Bookham KT23 3BT Leatherhead Surrey | England | British | Accountant | 16217330001 | ||||
PRITCHARD, Huw Brentnall | Geschäftsführer | 6 Davema Close BR7 5QZ Chislehurst Kent | Great Britain | British | Chartered Accountant | 53794300001 | ||||
RABALD, Sabine | Geschäftsführer | Carlton Gardens SW1Y 5AA London 4 | France | Swiss | Control And Compliance | 196552860001 | ||||
REGAN, Peter William | Geschäftsführer | 3 Pimms Close Weylea Farm GU4 7YG Guildford Surrey | British | Stockbroker | 53794420001 | |||||
SCHLIEMANN, Henrik Oliver | Geschäftsführer | Carlton Gardens SW1Y 5AA London 4 England | England | German | Investment Banker | 68742850002 | ||||
SOPHER, Richard Moshe | Geschäftsführer | 3 Upper Belgrave Street SW1X 8BD London | United Kingdom | British | Investment Advisor | 35899030001 | ||||
STEER, Ian Peter | Geschäftsführer | Denstone Berry Lane WD3 5EY Chorley Wood Hertfordshire | British | Banker/Consultant | 37588490001 | |||||
THISTLETHWAYTE, Mark Edward | Geschäftsführer | Fairfield House East Street, Hambledon PO7 4RY Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | Investment Manager | 107579860001 | ||||
TUTT, Stephen Brian Reginald | Geschäftsführer | Carlton Gardens SW1Y 5AA London 4 England | England | British | Chartered Accountant | 174717210001 | ||||
VELTMAN, Willem Laurens | Geschäftsführer | 55b Harrington Gardens SW7 4JZ London | Dutch | Investment Adviser | 62997050001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmond De Rothschild (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | Carlton Gardens SW1Y 5AA London 4 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Crest security deed | Erstellt am 22. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All sums and payments receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from any stock account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security deed | Erstellt am 22. Juni 2000 Geliefert am 05. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental security deed which is supplemental to a security deed dated 12TH july 1996 | Erstellt am 02. Nov. 1999 Geliefert am 18. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All debts, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee which arise out of or in connection with the facility agreement (as defined in the principal deed) | |
Kurze Angaben The principal deed was amended to include a first fixed charge on all sums and payanebts form time to time after the date of the supplemental security deed receivable by or for the account of the company by reason of or in respect of the closing out or liquidation of any unsettled contract relating to any stocks in crest.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Custody agreement | Erstellt am 04. Mai 1998 Geliefert am 15. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the custody agreement | |
Kurze Angaben All cash and securities held in any account opened by the chargee in the name of the chargor pursuant to the custody agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Declaration of pledge of securities and claims | Erstellt am 17. Okt. 1997 Geliefert am 04. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A. and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A. banque generale du luxembourg S.A. banque internationale a luxembourg S.A. credit commercial de france kredietbank N.V. kredietbank S.A. luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules) | |
Kurze Angaben All present and future securities bonds notes certificates of deposit instruments or rights representing property rights or claims and the balance from time to time of the cash account(s) and all currencies of the pledgor with cedel bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security deed | Erstellt am 12. Juli 1996 Geliefert am 24. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation any such debts obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined) | |
Kurze Angaben All sums and payments receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from the eligible stock account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A charge in favour of the international stock exchange of the united kingdom and the republic of ireland limited | Erstellt am 10. Juni 1993 Geliefert am 15. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing all monies due or to become due under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All shares,stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities which are from time to time registered in the name of any stock exchange nominee company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system | Erstellt am 27. Dez. 1991 Geliefert am 06. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee relating to or resulting from the borrowers use of the euroclear system on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All "collateral" (as defined on form 395) including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (see 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0