EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED

EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01831705
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    • Eigenhandel mit Wertpapieren (64991) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LCF EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED31. März 200431. März 2004
    LCF ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED19. Juli 200019. Juli 2000
    L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED10. Sept. 198410. Sept. 1984
    PATHALTON LIMITED11. Juli 198411. Juli 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    15 SeitenLIQ13
    A8EE98TD

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Carlton Gardens London SW1Y 5AA zum C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD am 24. Sept. 2018

    2 SeitenAD01
    A7ECKH2J

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 4 Carlton Gardens London SW1Y 5AA geändert

    2 SeitenAD02
    A7ECKH2B

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01
    A7ECKH1N

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600
    A7ECKH2R

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 06. Sept. 2018

    LRESSP

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04
    X7DPWN14

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    2 SeitenMR04
    X7DPWYBV

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04
    X7DPX7IZ

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04
    X7DPYDK8

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X7ABW6OA

    Beendigung der Bestellung von Sabine Rabald als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018

    1 SeitenTM01
    X6YT9UE1

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    25 SeitenAA
    A6A8PJYP

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01
    X6ACQYMI

    Beendigung der Bestellung von Gareth Austin Rippon Long als Geschäftsführer am 30. Juni 2017

    1 SeitenTM01
    X69NZYXL

    Beendigung der Bestellung von Andrew Nicholas John Hay als Geschäftsführer am 31. März 2017

    1 SeitenTM01
    X63PZMSZ

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 31. Dez. 2016

    • Kapital: GBP 2,000,000
    3 SeitenSH01
    X5YW6OXR

    Beschlüsse

    Resolutions
    22 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01
    X5B2X18Z

    Beendigung der Bestellung von Denis Joseph Claude Gilles De Montigny als Geschäftsführer am 30. Juni 2016

    1 SeitenTM01
    X5A7L11K

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    24 SeitenAA
    A5A4ONEA

    Beendigung der Bestellung von John William Hewitson als Geschäftsführer am 31. März 2016

    1 SeitenTM01
    X54R1DGO

    Ernennung von Mr Denis Joseph Claude Gilles De Montigny als Direktor am 07. Okt. 2015

    2 SeitenAP01
    X4HWLBLZ

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 14. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 1,000,000
    SH01
    X4FXSQS3

    Wer sind die Geschäftsführer von EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COUTTS, Eric Joseph
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    Geschäftsführer
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    FranceEnglishInvestment Banker195873440001
    HORNER, Elizabeth Anne
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    Geschäftsführer
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    EnglandBritishGeneral Counsel147119570001
    COOPER, Anne Sieona Petie
    Greygates
    Warren Road
    TN6 1QN Crowborough
    East Sussex
    Sekretär
    Greygates
    Warren Road
    TN6 1QN Crowborough
    East Sussex
    British52030630001
    MADDISON, Patrick James Robson
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    Sekretär
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    British16217330001
    MADDISON, Patrick James Robson
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    Sekretär
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    British16217330001
    ALEXANDER, John Bernard
    Old Rectory
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Old Rectory
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    EnglandUnited KingdomMerchant Banker23013570001
    ALTMANN, David Peter
    Priory Cottage South Mill Street
    Steventon
    OX13 6SP Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Priory Cottage South Mill Street
    Steventon
    OX13 6SP Abingdon
    Oxfordshire
    BritishStockbroker30828020003
    BONFIELD, John Anthony
    30 Burghley Road
    SW19 5HN London
    Geschäftsführer
    30 Burghley Road
    SW19 5HN London
    BritishStockbroker56236200001
    BRIANCE, Richard Henry
    13 Holland Street
    W8 4NA London
    The Old House
    England
    Geschäftsführer
    13 Holland Street
    W8 4NA London
    The Old House
    England
    EnglandBritishCeo16636440001
    DE MONTIGNY, Denis Joseph Claude Gilles
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    Geschäftsführer
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    LuxembourgLuxembourgerAccountant200877180001
    DRUMMOND, John Leitch
    Latimers
    Wendens Ambo
    CB11 4LQ Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    Latimers
    Wendens Ambo
    CB11 4LQ Saffron Walden
    Essex
    BritishInvestment Advisor30828010001
    ELMAN, Andrew Mark
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Geschäftsführer
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    United KingdomBritishBanker59954220004
    FORDHAM, Kevin Lindsay
    159 Forest Road
    TN2 5JP Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    159 Forest Road
    TN2 5JP Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishInvestment Banker29835100001
    FUNAKI, Hiroshi
    Orion House
    5 Upper St Martins Lane
    WC2H 9EA London
    Geschäftsführer
    Orion House
    5 Upper St Martins Lane
    WC2H 9EA London
    EnglandBritishHead Of Research156927690001
    HAY, Andrew Nicholas John
    10 Favart Road
    SW6 4AZ London
    Geschäftsführer
    10 Favart Road
    SW6 4AZ London
    United KingdomBritishBanker64172700001
    HEATHFIELD, Claire Louise
    53 Warwick Gardens
    W14 8PL London
    Geschäftsführer
    53 Warwick Gardens
    W14 8PL London
    EnglandBritishInvestment Advisor75061300002
    HEWITSON, John William
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Geschäftsführer
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    EnglandEnglishSales Trader170530830001
    JONES BATEMAN, Richard Stephen
    Bretton House
    Fosseway
    GL54 1JU Stow On The Wold
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Bretton House
    Fosseway
    GL54 1JU Stow On The Wold
    Gloucestershire
    BritishInvestment Advisor30828030002
    JOUINOT, Patrick-Joel
    6 Darlan Road
    SW6 5BT London
    Geschäftsführer
    6 Darlan Road
    SW6 5BT London
    EnglandFrenchInvestment Banker104267410001
    LAMBOURNE, Douglas Ivan
    55 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Geschäftsführer
    55 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    BritishInvestment Banker87042370001
    LONG, Gareth Austin Rippon
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Geschäftsführer
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    EnglandEnglishSettlements Manager171854950001
    MADDISON, Patrick James Robson
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishAccountant16217330001
    PRITCHARD, Huw Brentnall
    6 Davema Close
    BR7 5QZ Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    6 Davema Close
    BR7 5QZ Chislehurst
    Kent
    Great BritainBritishChartered Accountant53794300001
    RABALD, Sabine
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    Geschäftsführer
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    FranceSwissControl And Compliance196552860001
    REGAN, Peter William
    3 Pimms Close Weylea Farm
    GU4 7YG Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Pimms Close Weylea Farm
    GU4 7YG Guildford
    Surrey
    BritishStockbroker53794420001
    SCHLIEMANN, Henrik Oliver
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Geschäftsführer
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    EnglandGermanInvestment Banker68742850002
    SOPHER, Richard Moshe
    3 Upper Belgrave Street
    SW1X 8BD London
    Geschäftsführer
    3 Upper Belgrave Street
    SW1X 8BD London
    United KingdomBritishInvestment Advisor35899030001
    STEER, Ian Peter
    Denstone Berry Lane
    WD3 5EY Chorley Wood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Denstone Berry Lane
    WD3 5EY Chorley Wood
    Hertfordshire
    BritishBanker/Consultant37588490001
    THISTLETHWAYTE, Mark Edward
    Fairfield House
    East Street, Hambledon
    PO7 4RY Waterlooville
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fairfield House
    East Street, Hambledon
    PO7 4RY Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishInvestment Manager107579860001
    TUTT, Stephen Brian Reginald
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Geschäftsführer
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    EnglandBritishChartered Accountant174717210001
    VELTMAN, Willem Laurens
    55b Harrington Gardens
    SW7 4JZ London
    Geschäftsführer
    55b Harrington Gardens
    SW7 4JZ London
    DutchInvestment Adviser62997050001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    06. Apr. 2016
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer01750485
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Crest security deed
    Erstellt am 22. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All sums and payments receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from any stock account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Sept. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security deed
    Erstellt am 22. Juni 2000
    Geliefert am 05. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental security deed which is supplemental to a security deed dated 12TH july 1996
    Erstellt am 02. Nov. 1999
    Geliefert am 18. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee which arise out of or in connection with the facility agreement (as defined in the principal deed)
    Kurze Angaben
    The principal deed was amended to include a first fixed charge on all sums and payanebts form time to time after the date of the supplemental security deed receivable by or for the account of the company by reason of or in respect of the closing out or liquidation of any unsettled contract relating to any stocks in crest.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Custody agreement
    Erstellt am 04. Mai 1998
    Geliefert am 15. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the custody agreement
    Kurze Angaben
    All cash and securities held in any account opened by the chargee in the name of the chargor pursuant to the custody agreement.
    Berechtigte Personen
    • Caroline Desbriere
    Transaktionen
    • 15. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Declaration of pledge of securities and claims
    Erstellt am 17. Okt. 1997
    Geliefert am 04. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A. and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A. banque generale du luxembourg S.A. banque internationale a luxembourg S.A. credit commercial de france kredietbank N.V. kredietbank S.A. luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules)
    Kurze Angaben
    All present and future securities bonds notes certificates of deposit instruments or rights representing property rights or claims and the balance from time to time of the cash account(s) and all currencies of the pledgor with cedel bank.
    Berechtigte Personen
    • The Guarantor (See Form 395)
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security deed
    Erstellt am 12. Juli 1996
    Geliefert am 24. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation any such debts obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined)
    Kurze Angaben
    All sums and payments receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from the eligible stock account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A charge in favour of the international stock exchange of the united kingdom and the republic of ireland limited
    Erstellt am 10. Juni 1993
    Geliefert am 15. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all monies due or to become due under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All shares,stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities which are from time to time registered in the name of any stock exchange nominee company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transaktionen
    • 15. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system
    Erstellt am 27. Dez. 1991
    Geliefert am 06. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee relating to or resulting from the borrowers use of the euroclear system on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All "collateral" (as defined on form 395) including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (see 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Sept. 2018Beginn der Liquidation
    26. Dez. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praktiker
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praktiker
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0