WHITEGATE TAVERNS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WHITEGATE TAVERNS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01838261 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WHITEGATE TAVERNS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WHITEGATE TAVERNS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WHITEGATE TAVERNS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHANHEATH LIMITED | 03. Aug. 1984 | 03. Aug. 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WHITEGATE TAVERNS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WHITEGATE TAVERNS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Jan. 2021 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom zum Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU am 30. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Apr. 2018 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirk Dyson Davis als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Smothers als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Mai 2016 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Lindsay Anne Keswick als Sekretär am 25. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Susan Stewart als Sekretär am 25. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ zum Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT am 07. März 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 22. Aug. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WHITEGATE TAVERNS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Sekretär | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | 207523810001 | |||||||
| SMOTHERS, Richard | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 242658700001 | |||||
| CUTHBERTSON, Colin | Sekretär | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Sekretär | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592810001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Sekretär | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445020001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Sekretär | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021410001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Sekretär | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Geschäftsführer | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Geschäftsführer | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| CUTHBERTSON, Colin | Geschäftsführer | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | England | British | 26369940001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| HOMER, Neville Rex | Geschäftsführer | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Geschäftsführer | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JACOBS, David Michael | Geschäftsführer | Riverside House Hall Cottages Lodden Drive RG10 8ND Reading Berkshire | British | 47141160001 | ||||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Geschäftsführer | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Geschäftsführer | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MILLER, Louise | Geschäftsführer | 13 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 63895470001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Geschäftsführer | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Geschäftsführer | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für WHITEGATE TAVERNS LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 01. März 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat WHITEGATE TAVERNS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 15. Dez. 2003 Geliefert am 31. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 19/21 flixton road, urmston, trafford greater manchester together with trade and other fixtures, goodwill, and the benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The stone room 3/a in the sub-basement of the manchester royal exchange together with trade and other fixtures, goodwill and benefits of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The barnaby rudge restaurant. 15 st. Ann's square, 2 old bank street, together with trade and other fixtures, goodwill, benefits of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Municipal buildings wellington road ashton under lyne greater manchester not known as fergusons restaurant toget her with trade and other fixtures good will and benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The old dukes restaurant, (formerly wellington inn drane street, and smith street, rochdale, lancashire. Together with trade and other fixtures, goodwill and benefits of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ferguson's restaurant, 2A northenden road, sale. Together with trade and other fixtures, goodwill and benefits of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H - manchester road, castleton greater manchester. K/a- the royal toby hotel. Togerher with trade and other fixtures, goodwill, and benefits of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the w of manchester rd, castleton, rochdale together with trade & other fixtures goodwill and the benefits of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Section 24 of the industrial building situate in longwood road trafford park, manchester with trade & other fixtures, goodwill and benefits of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. März 1985 Geliefert am 27. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing £436,333.29 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge (incl. Moneys in respect of trade payments (as defined in the charge). | |
Kurze Angaben 1) charge by way of legal mortgage on - ferguson's restaurant 2A northenden road, sale, cheshire. T/no:- gm 179649 2) fixed charge on machinery plant tool equipment the goodwill of the business, all bookdebts and other debts of the company present and future. Floating charge on all the undertakings and all property and assets of the borrower present and future (not subject to fixed charges under 1 & 2 abover) the debenture prohilats the creation of any further charges or of granting any leases without the written consent of wilsons brewery LTD. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WHITEGATE TAVERNS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0