T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED

T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameT.N. GREEN (POULTRY) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01839786
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED?

    • (5132) /

    Wo befindet sich T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis24. Nov. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Highfield Court Tollgate Chandlers Ford Eastleigh Hapshire SO53 3TZ zum 3 Hardman Street Manchester M3 3HF am 10. Jan. 2018

    2 SeitenAD01

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:Copy of C.O. to restore/appoint liquidators
    5 SeitenLIQ MISC OC

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    Seiten2.34B

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    2 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Aug. 2011

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Mai 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Nov. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Apr. 2009

    16 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    16 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Okt. 2008

    15 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    4 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    8 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    28 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DMC MGT LIMITED
    Dmc House
    Pullman Business Park Pullman Way
    BH24 1HD Ringwood
    Hampshire
    Sekretär
    Dmc House
    Pullman Business Park Pullman Way
    BH24 1HD Ringwood
    Hampshire
    70366380003
    MONAGHAN, Stephen Thomas
    Crime Villa Ashton Road
    Woodhouses Failsworth
    M35 9NL Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Crime Villa Ashton Road
    Woodhouses Failsworth
    M35 9NL Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector53611010001
    DUNNING, Mark Steven
    23 Lin Brook Drive
    BH24 3LJ Ringwood
    Hampshire
    Sekretär
    23 Lin Brook Drive
    BH24 3LJ Ringwood
    Hampshire
    British40907890003
    NEWTON, Michael Bursley
    18 Wharncliffe Road
    BH23 5DD Highcliffe
    Dorset
    Sekretär
    18 Wharncliffe Road
    BH23 5DD Highcliffe
    Dorset
    British32606230001
    PRICE, David Michael
    Little Monnington The Cliff
    Bryanston
    DT11 0PP Blandford
    Dorset
    Sekretär
    Little Monnington The Cliff
    Bryanston
    DT11 0PP Blandford
    Dorset
    British33946250001
    UNSWORTH, Stella Jane
    26 Southwood Avenue
    BH6 3QB Bournemouth
    Dorset
    Sekretär
    26 Southwood Avenue
    BH6 3QB Bournemouth
    Dorset
    British60278070001
    CORCORAN, Edward William
    45 Marine Drive East
    Barton On Sea
    BH25 7DX New Milton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    45 Marine Drive East
    Barton On Sea
    BH25 7DX New Milton
    Hampshire
    BritishDirector3679320001
    DUNNING, Mark Steven
    23 Lin Brook Drive
    BH24 3LJ Ringwood
    Hampshire
    Geschäftsführer
    23 Lin Brook Drive
    BH24 3LJ Ringwood
    Hampshire
    BritishChartered Accountant40907890003
    PICKETT, John Stewart
    Greenhayes
    Sway Road
    SO42 7RX Brockenhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Greenhayes
    Sway Road
    SO42 7RX Brockenhurst
    Hampshire
    EnglandBritishDirector3679330001
    PRICE, David Michael
    Little Monnington The Cliff
    Bryanston
    DT11 0PP Blandford
    Dorset
    Geschäftsführer
    Little Monnington The Cliff
    Bryanston
    DT11 0PP Blandford
    Dorset
    BritishChartered Accountant33946250001
    TWAITES, Jonathan Iain
    18 The Mount
    Alwoodley
    LS17 7QU Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    18 The Mount
    Alwoodley
    LS17 7QU Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishSales Director56431310001
    WATSON, Neil George
    Streamside Cottage
    Ludwell
    SP7 9ND Shaftesbury
    Dorset
    Geschäftsführer
    Streamside Cottage
    Ludwell
    SP7 9ND Shaftesbury
    Dorset
    BritishDirector58411160002

    Hat T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 16. Nov. 1999
    Geliefert am 06. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge over all assets
    Erstellt am 01. Dez. 1997
    Geliefert am 05. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this fixed and floating charge
    Kurze Angaben
    All its present and future right title and interest in and to the following assets a) the f/h and l/h property both present and future and all buildings and fixtures (including trade fixtures) from time to time on such property and all fixed and other plant machinery vehicles computers and office and other equipment both present and future together with all rights easements and privileges relating to the same;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nmb-Heller Limited
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 01. Dez. 1997
    Geliefert am 04. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000 due or to become due from t n green (holdings) limited to the chargee under the terms of a secured loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • E W Corcoran
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Nov. 1994
    Geliefert am 25. Nov. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 25. Aug. 1992
    Geliefert am 10. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 16/01/91
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all uncalled capital patents and patent applications.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Jan. 1991
    Geliefert am 28. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 12. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat T.N. GREEN (POULTRY) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Apr. 2008Beginn der Verwaltung
    15. Mai 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nigel Ian Fox
    Rsm Tenon Restructuring Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Praktiker
    Rsm Tenon Restructuring Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Jeremy Nigel Ian Woodside
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    2
    DatumTyp
    15. Mai 2009Beginn der Liquidation
    27. Mai 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nigel Ian Fox
    Rsm Tenon Restructuring Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Praktiker
    Rsm Tenon Restructuring Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Jeremy Nigel Ian Woodside
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Lindsey J Cooper
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0