W.H. THOMAS & SONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | W.H. THOMAS & SONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01843026 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von W.H. THOMAS & SONS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich W.H. THOMAS & SONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tower Bridge House St. Katharines Way E1W 1DD London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von W.H. THOMAS & SONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GLENBLAKE LIMITED | 23. Aug. 1984 | 23. Aug. 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von W.H. THOMAS & SONS LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2010 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2011 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für W.H. THOMAS & SONS LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 14. Mai 2017 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 28. Mai 2017 |
Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für W.H. THOMAS & SONS LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für W.H. THOMAS & SONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Saint-Gobain House Binley Business Park Coventry CV3 2TT* am 17. Aug. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alun Roy Oxenham als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Edward Moore als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thierry Lambert als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Kenward als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Hindle als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Thierry Lambert am 24. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher Gabriel Kenward am 10. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Hindle am 08. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alun Roy Oxenham am 28. Apr. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von W.H. THOMAS & SONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXENHAM, Alun Roy | Sekretär | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House United Kingdom | British | 72478560002 | ||||||
MOORE, Philip Edward | Geschäftsführer | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House | United Kingdom | British | Director | 60599570002 | ||||
OXENHAM, Alun Roy | Geschäftsführer | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 72478560002 | ||||
BOYCE, Desmond William Samuel | Sekretär | 25 Lylehill Green BT39 0BF Ballyclare Antrim | Irish | 334259390001 | ||||||
HUGHES, William Terrance | Sekretär | Blue Pines Bent Lane WA13 9TQ Lymm Cheshire | British | 485150001 | ||||||
HUGHES, William Terrance | Sekretär | Blue Pines Bent Lane WA13 9TQ Lymm Cheshire | British | 485150001 | ||||||
LEA, Barbara | Sekretär | 18 Ashley Drive M33 4PQ Sale Cheshire | British | Company Secretary | 1257000001 | |||||
WALSH, Conor | Sekretär | 36 Rowley Meadows BT33 0RW Newcastle County Down | British | Accountant | 76182410001 | |||||
BROOMHEAD, Edwin | Geschäftsführer | 11 Duxbury Hall Road Duxbury PR7 4AT Chorley Lancashire | British | Director | 7171060001 | |||||
BURNDRED, John | Geschäftsführer | 27 Elizabeth Crescent CH4 7AY Chester Cheshire | British | Managing Director | 9854290001 | |||||
EDWARDS, Stephen Paul | Geschäftsführer | 11 Friars Avenue SY11 2JJ Oswestry Shropshire | British | Company Director | 41747570001 | |||||
GRIFFITHS, Christopher Wynne | Geschäftsführer | Penygeulan SY10 0BT Llansantffraid Powys | British | Company Director | 9854320001 | |||||
GRIFFITHS, Peter Ernest Wynne | Geschäftsführer | 80 New Ifton St Martins SY11 3AB Oswestry Salop | United Kingdom | British | Director | 9854300001 | ||||
HINDLE MBE, Peter, Dr | Geschäftsführer | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Merchant House United Kingdom | England | British | Chief Executive Officer | 142989910002 | ||||
HUGHES, William Terrance | Geschäftsführer | Blue Pines Bent Lane WA13 9TQ Lymm Cheshire | British | Company Director | 485150001 | |||||
JACKSON, David Reginald | Geschäftsführer | 65 Larkhill Road Kingswood Estate Copthorne SY3 8XJ Shrewsbury | British | Director | 27808950003 | |||||
KENWARD, Christopher Gabriel | Geschäftsführer | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Merchant House United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 265627840001 | ||||
LAMBERT, Thierry | Geschäftsführer | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Merchant House United Kingdom | French | Deputy General Delegate | 136578380002 | |||||
LEA, Barbara | Geschäftsführer | 18 Ashley Drive M33 4PQ Sale Cheshire | British | Company Secretary | 1257000001 | |||||
LYNCH, Eugene Gabriel | Geschäftsführer | 40 Crofthill BT8 6GX Belfast County Antrim | Northern Ireland | Irish | Director | 71079720001 | ||||
MILLS, David Edwin | Geschäftsführer | Old Leasowes Farm Formly New House Norbury SY9 5EA Bishops Castle Salop | British | Director | 35694090002 | |||||
ROURKE, Sean Joseph | Geschäftsführer | 18 Egerton Road Eccles M30 9LR Manchester Lancashire | British | Director | 69431930001 | |||||
TOLLAND, James Ansley Lambert | Geschäftsführer | 5 Whiterock Road BT23 6PR Killinchy County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | Chief Executive | 75450440001 | ||||
WALSH, John Graham | Geschäftsführer | 9 Duxbury Hall Road PR7 4AT Chorley Lancashire | British | Financial Director | 9854280001 |
Hat W.H. THOMAS & SONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Erstellt am 18. Mai 1999 Geliefert am 28. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 18. Mai 1999 Geliefert am 28. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at barkers green wem shropshire t/no: SL95592. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 18. Mai 1999 Geliefert am 28. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on the north west side of the A423 rodmeadows oswestry shropshire t/no: SL94832. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Mai 1999 Geliefert am 26. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 12. Dez. 1985 Geliefert am 02. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties &/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & the benefit of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 24. Juni 1985 Geliefert am 03. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 14 salop road oswestry shropshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat W.H. THOMAS & SONS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0