VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01844742 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?
- (5245) /
- (9305) /
Wo befindet sich VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Service House Shield Drive M28 2QB Worsley Manchester, |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VACLENSA LIMITED | 26. Apr. 1990 | 26. Apr. 1990 |
| VACUUM CLEANER SERVICES LIMITED | 29. Nov. 1984 | 29. Nov. 1984 |
| RIGCARE LIMITED | 31. Aug. 1984 | 31. Aug. 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Francis Ferguson am 01. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Joseph Foggon am 01. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian Philip Miller am 01. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(288) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRAHAN, Mark | Sekretär | Tarrant Close Winstanley WN3 6HR Wigan 2 Lancashire | British | 137483720001 | ||||||
| FERGUSON, Paul Francis | Geschäftsführer | Bellam Court Wardley, Swinton M27 9GD Manchester 25 England | England | British | 42007250006 | |||||
| FOGGON, James Joseph | Geschäftsführer | 1 Appleyard Close Agecroft Hall MJ7 8AZ Pendlebury Manchester | England | British | 79803810002 | |||||
| MILLER, Ian Philip | Geschäftsführer | Greenhalgh Lane Anderton PR6 9PH Chorley The Farmhouse Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 54364210004 | |||||
| FOGGON, Eileen | Sekretär | 255 Worsley Road Swinton M27 0YE Gtr Manchester | British | 80178660001 | ||||||
| FOGGON, James Joseph | Sekretär | 1 Appleyard Close Agecroft Hall MJ7 8AZ Pendlebury Manchester | British | 79803810002 | ||||||
| HARRIS, Anthony Joseph | Sekretär | 8 Doals Gate OL13 8JN Weir Lancashire | British | 79933150002 | ||||||
| WARD, David Joseph | Sekretär | 206 Crompton Way BL2 2RZ Bolton Lancashire | British | 54364240001 | ||||||
| CROOK, Brian | Geschäftsführer | 46 Hunts Field Clayton Le Woods PR6 7TT Preston Lancashire | British | 48246650001 | ||||||
| EASLEY, Michael Arthur | Geschäftsführer | 222 Barton Road Stretford M32 9RD Manchester Lancashire | British | 22785520001 | ||||||
| FOGGON, Eileen | Geschäftsführer | 255 Worsley Road Swinton M27 0YE Gtr Manchester | British | 80178660001 | ||||||
| FOGGON, John James | Geschäftsführer | 255 Worsley Road Swinton M27 0YE Manchester Lancashire | British | 22785530001 | ||||||
| HARRIS, Anthony Joseph | Geschäftsführer | 8 Doals Gate OL13 8JN Weir Lancashire | England | British | 79933150002 | |||||
| SEWELL, Kim | Geschäftsführer | 22 Holly Bank Mill Brow Marple Bridge SK6 5LL Stockport Cheshire | British | 54364220001 | ||||||
| SPENCER, Jennifer Aileen | Geschäftsführer | 8 Brookfield Drive Boothstown M28 1JY Manchester | British | 48246520001 | ||||||
| WARD, David Joseph | Geschäftsführer | 206 Crompton Way BL2 2RZ Bolton Lancashire | British | 54364240001 |
Hat VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment of hire contract(s) | Erstellt am 31. Juli 2003 Geliefert am 06. Aug. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The entire benefit of the hire contracts and all the payments due under the hire contracts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 22. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as vaclensa limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns by way of first fixed legal mortgage the equipment assigns absolutely the proceeds of all policies of insurance now or in the future taken out by the mortgagor in respect of the equipment and the benefit of all options and rights devolving upon the mortgagor under any such policy of insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of hire contract(s) | Erstellt am 22. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The entire benefit of the hire contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Dez. 1993 Geliefert am 23. Dez. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/as land at wardley industrial estate swinton greater manchester together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 01. Apr. 1992 Geliefert am 16. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit b 47 lansdowne road monton eccles manchester t/no. GM465205 assignment of goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1992 Geliefert am 16. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £17,400 & all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H property k/a 47 lansdowne road monton eccles manchester GM465205. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Feb. 1986 Geliefert am 18. Feb. 1986 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juni 1985 Geliefert am 24. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement d/d 21.6.85. | |
Kurze Angaben All the book and other debts due to the company from time to time howsoever by way of a first fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0