VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED

VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01844742
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?

    • (5245) /
    • (9305) /

    Wo befindet sich VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Service House
    Shield Drive
    M28 2QB Worsley
    Manchester,
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VACLENSA LIMITED26. Apr. 199026. Apr. 1990
    VACUUM CLEANER SERVICES LIMITED 29. Nov. 198429. Nov. 1984
    RIGCARE LIMITED31. Aug. 198431. Aug. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 07. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 100,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Francis Ferguson am 01. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für James Joseph Foggon am 01. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ian Philip Miller am 01. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GARRAHAN, Mark
    Tarrant Close
    Winstanley
    WN3 6HR Wigan
    2
    Lancashire
    Sekretär
    Tarrant Close
    Winstanley
    WN3 6HR Wigan
    2
    Lancashire
    British137483720001
    FERGUSON, Paul Francis
    Bellam Court
    Wardley, Swinton
    M27 9GD Manchester
    25
    England
    Geschäftsführer
    Bellam Court
    Wardley, Swinton
    M27 9GD Manchester
    25
    England
    EnglandBritish42007250006
    FOGGON, James Joseph
    1 Appleyard Close
    Agecroft Hall
    MJ7 8AZ Pendlebury
    Manchester
    Geschäftsführer
    1 Appleyard Close
    Agecroft Hall
    MJ7 8AZ Pendlebury
    Manchester
    EnglandBritish79803810002
    MILLER, Ian Philip
    Greenhalgh Lane
    Anderton
    PR6 9PH Chorley
    The Farmhouse
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Greenhalgh Lane
    Anderton
    PR6 9PH Chorley
    The Farmhouse
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish54364210004
    FOGGON, Eileen
    255 Worsley Road
    Swinton
    M27 0YE Gtr Manchester
    Sekretär
    255 Worsley Road
    Swinton
    M27 0YE Gtr Manchester
    British80178660001
    FOGGON, James Joseph
    1 Appleyard Close
    Agecroft Hall
    MJ7 8AZ Pendlebury
    Manchester
    Sekretär
    1 Appleyard Close
    Agecroft Hall
    MJ7 8AZ Pendlebury
    Manchester
    British79803810002
    HARRIS, Anthony Joseph
    8 Doals Gate
    OL13 8JN Weir
    Lancashire
    Sekretär
    8 Doals Gate
    OL13 8JN Weir
    Lancashire
    British79933150002
    WARD, David Joseph
    206 Crompton Way
    BL2 2RZ Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    206 Crompton Way
    BL2 2RZ Bolton
    Lancashire
    British54364240001
    CROOK, Brian
    46 Hunts Field
    Clayton Le Woods
    PR6 7TT Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    46 Hunts Field
    Clayton Le Woods
    PR6 7TT Preston
    Lancashire
    British48246650001
    EASLEY, Michael Arthur
    222 Barton Road
    Stretford
    M32 9RD Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    222 Barton Road
    Stretford
    M32 9RD Manchester
    Lancashire
    British22785520001
    FOGGON, Eileen
    255 Worsley Road
    Swinton
    M27 0YE Gtr Manchester
    Geschäftsführer
    255 Worsley Road
    Swinton
    M27 0YE Gtr Manchester
    British80178660001
    FOGGON, John James
    255 Worsley Road
    Swinton
    M27 0YE Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    255 Worsley Road
    Swinton
    M27 0YE Manchester
    Lancashire
    British22785530001
    HARRIS, Anthony Joseph
    8 Doals Gate
    OL13 8JN Weir
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Doals Gate
    OL13 8JN Weir
    Lancashire
    EnglandBritish79933150002
    SEWELL, Kim
    22 Holly Bank Mill Brow
    Marple Bridge
    SK6 5LL Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    22 Holly Bank Mill Brow
    Marple Bridge
    SK6 5LL Stockport
    Cheshire
    British54364220001
    SPENCER, Jennifer Aileen
    8 Brookfield Drive
    Boothstown
    M28 1JY Manchester
    Geschäftsführer
    8 Brookfield Drive
    Boothstown
    M28 1JY Manchester
    British48246520001
    WARD, David Joseph
    206 Crompton Way
    BL2 2RZ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    206 Crompton Way
    BL2 2RZ Bolton
    Lancashire
    British54364240001

    Hat VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment of hire contract(s)
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 06. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The entire benefit of the hire contracts and all the payments due under the hire contracts.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 22. Apr. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as vaclensa limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assigns by way of first fixed legal mortgage the equipment assigns absolutely the proceeds of all policies of insurance now or in the future taken out by the mortgagor in respect of the equipment and the benefit of all options and rights devolving upon the mortgagor under any such policy of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of hire contract(s)
    Erstellt am 22. Apr. 2002
    Geliefert am 25. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The entire benefit of the hire contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Dez. 1993
    Geliefert am 23. Dez. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as land at wardley industrial estate swinton greater manchester together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 1992
    Geliefert am 16. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit b 47 lansdowne road monton eccles manchester t/no. GM465205 assignment of goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1992
    Geliefert am 16. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £17,400 & all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 47 lansdowne road monton eccles manchester GM465205.
    Berechtigte Personen
    • Mynshul Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Feb. 1986
    Geliefert am 18. Feb. 1986
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 21. Juni 1985
    Geliefert am 24. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement d/d 21.6.85.
    Kurze Angaben
    All the book and other debts due to the company from time to time howsoever by way of a first fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • Kellock Factors Limited
    Transaktionen
    • 24. Juni 1985Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0