SCOTIA HOLDINGS PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSCOTIA HOLDINGS PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01849887
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SCOTIA HOLDINGS PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich SCOTIA HOLDINGS PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SCOTIA HOLDINGS PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EFAMOL HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY20. Sept. 198420. Sept. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SCOTIA HOLDINGS PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für SCOTIA HOLDINGS PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 24. Mai 2018

    2 Seiten2.15

    Mitteilung über die Aufhebung des Verwaltungsbeschlusses

    28 Seiten2.19

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2018

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2017

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2017

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2016

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2016

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2015

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2015

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2014

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2013

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2013

    2 Seiten2.15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Mitre House 160 Aldersgate Street London EC1A 4DD* am 15. Feb. 2013

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2012

    2 Seiten2.15

    Beendigung der Bestellung von Michael Redmond als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2012

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2011

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2011

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2010

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2010

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2009

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2009

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2008

    2 Seiten2.15

    Wer sind die Geschäftsführer von SCOTIA HOLDINGS PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLARK, Alan Stuart
    Kings Barn
    Bentworth
    GU34 5JU Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Kings Barn
    Bentworth
    GU34 5JU Alton
    Hampshire
    British67234920002
    MCKINNON, James, Sir
    April Meadow, 9 Leigh Hill Road
    KT11 2HS Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    April Meadow, 9 Leigh Hill Road
    KT11 2HS Cobham
    Surrey
    British30043200002
    LAFFERTY, Gerard
    Tempar 4 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Sekretär
    Tempar 4 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    British44542890004
    MARR, Catriona Frances
    167 Malden Road
    KT3 6AA New Malden
    Surrey
    Sekretär
    167 Malden Road
    KT3 6AA New Malden
    Surrey
    British6408230002
    BARBER, Michael
    Church Farmhouse Framingham Lane
    NR14 7HF Bramerton
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Church Farmhouse Framingham Lane
    NR14 7HF Bramerton
    Norfolk
    United KingdomBritish62450560001
    BLACKWELL, Christopher Paul, Dr
    1 Gibson Grove
    FK15 0NS Dunblane
    Perthshire
    Geschäftsführer
    1 Gibson Grove
    FK15 0NS Dunblane
    Perthshire
    British79770360001
    BOILY, Jeffrey Oscar
    4 Essex Road
    EH4 6LE Edinburgh
    Barton Scotland
    Geschäftsführer
    4 Essex Road
    EH4 6LE Edinburgh
    Barton Scotland
    Canadian48253910001
    CLARKSON, Sherri Margaret
    Fernfield
    1 Melville Place
    FK9 4HE Bridge Of Allan
    Geschäftsführer
    Fernfield
    1 Melville Place
    FK9 4HE Bridge Of Allan
    Canadian22631870003
    DOW, Robert James
    Dundarach 1 Craiglockhart Park
    Craiglockhart
    EH14 1ER Edinburgh
    Geschäftsführer
    Dundarach 1 Craiglockhart Park
    Craiglockhart
    EH14 1ER Edinburgh
    ScotlandBritish54627380003
    GLYNN-WILLIAMS, William Ifan
    Fleet View
    The Pound
    SL6 9QD Cookham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Fleet View
    The Pound
    SL6 9QD Cookham
    Berkshire
    British45244950001
    GRAHAM, Stuart Twentyman
    Whitecorft Way
    BR3 3AG Beckenham
    Kent
    Geschäftsführer
    Whitecorft Way
    BR3 3AG Beckenham
    Kent
    British31704780002
    HALE, Arthur James, Doctor
    Millstream
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Millstream
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37648880001
    HERSLOF, Bengt, Dr
    Brunbarsvagen 2
    S-114 21
    FOREIGN Stockholm
    Sweden
    Geschäftsführer
    Brunbarsvagen 2
    S-114 21
    FOREIGN Stockholm
    Sweden
    Swedish56510570001
    HORROBIN, David Frederick, Dr
    50 Kenilworth Road
    FK9 4RS Bridge Of Allan
    Geschäftsführer
    50 Kenilworth Road
    FK9 4RS Bridge Of Allan
    British80992730001
    KEEN, Nigel John
    19 Pembroke Square
    W8 6PA London
    Geschäftsführer
    19 Pembroke Square
    W8 6PA London
    EnglandBritish166130001
    LAFFERTY, Gerard
    Tempar 4 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Geschäftsführer
    Tempar 4 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish44542890004
    LAWTHER, William Michael
    Corrienessen House
    Aberfoyle
    FK8 3TQ Stirling
    Scotland
    Geschäftsführer
    Corrienessen House
    Aberfoyle
    FK8 3TQ Stirling
    Scotland
    British78490730002
    MACLEOD, Calum Alexander, Dr
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish1085020001
    MCADAM, James
    Tara 222 Thameside
    Laleham Village
    TW18 1UQ Staines
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Tara 222 Thameside
    Laleham Village
    TW18 1UQ Staines
    Middlesex
    British36630440001
    MORROW, Ian, Sir
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    British1890700002
    REDMOND, Michael
    7 Corsbie Close
    IP33 3ST Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    7 Corsbie Close
    IP33 3ST Bury St. Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish43087190004
    SELKIRK, Alastair Brereton, Doctor
    303 Lanark Road
    EH14 2LL Edinburgh
    Geschäftsführer
    303 Lanark Road
    EH14 2LL Edinburgh
    British59306120002

    Hat SCOTIA HOLDINGS PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage of patents
    Erstellt am 07. Apr. 1997
    Geliefert am 25. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The attached schedule includes covenants by restrictions on the company which protect and further define the charges and which together with further warranties and undertakings in the security must be read as part of the charges created. Charged rights means all and any of the patents patent application and other rights causes of action and interests assured assigned or charged. Patent includes utility models. The patents- country of registration-usa, breif description-calcium excretion, patent number-5318991. Country of registration-south africa, breif description-calcium excretion, patent number-92/3915. Country of registration-taiwan, brief description-calcium excretion, patent number-N1-60818.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of trade marks tradenames and goodwill
    Erstellt am 24. Jan. 1997
    Geliefert am 13. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the united kingdom registered trade marks listed in the schedule to form 395 under registration no's 291863, 92993 and DD652750 (and as further defined), and all other united kingdom registered trade marks presently belonging to or acquired by the company in the future; all the united kingdom applications for trade marks presently belonging to or acquired by the company in the future; all present and future rights and causes of action in respect of infringement of any of the rights referred to above; all non-united kingdom trade marks (as defined on form 395) all rights in passing off and all goodwill of the business of the company present and future; all licences and benefits of licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of patents
    Erstellt am 24. Jan. 1997
    Geliefert am 13. Feb. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the patents including untility models and rights in inventions as further defined in the schedule hereto together with all other patents and rights in inventions and the full benefit of all rights attaching to the same and the benefit of any licences under the charged rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of patents
    Erstellt am 12. Okt. 1995
    Geliefert am 20. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the patents and rights in inventions presently belonging to or hereafter acquired by or belonging to the company throughout the world. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of patents
    Erstellt am 09. Feb. 1995
    Geliefert am 17. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the inventions and patents listed in the schedule to form 395 all the applications for patents listed in the schedule all present and future rights and causes of action whenever and wherever accrued during the subsistence of the security and all rights and interest of the company howsoever arising during the subsistence of the security please refer to form 395 and continuation sheet for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of patents
    Erstellt am 06. Juli 1994
    Geliefert am 13. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The company as beneficial owner assigns to the bank:-a)all the inventions and patents presently belonging to or hereafter acquired by or belonging to the company during the subsistence of the security throughout the world.b)all the applications for patents listed in the schedule hereto,together with all other applications for patents both present and future made by the company.c)all present and future rights and causes of action whenever and wherever accrued.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over patents
    Erstellt am 30. Juni 1993
    Geliefert am 21. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    "Charged rights" means all patents,patent applications and other rights "patents" means U.K. letters patent or the equivalent in other local jurisdictions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Okt. 1992
    Geliefert am 02. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries (as defined in the charge) under or pursuant to the facility documents and the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Kleinwort Benson Limited
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 20. Aug. 1992
    Geliefert am 27. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £171,691.10 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title & interest in & to all sums payable under the insurance as from time to time varied or extended & the benefit of all powers & remedies.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of patents
    Erstellt am 26. März 1992
    Geliefert am 14. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All patents & application for patents as described in the first & second schedule to the form 395 first fixed charge on all rights & interest (for full details refer to doc M395 ref M413C).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 18. März 1992
    Geliefert am 02. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M512C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Apr. 1991
    Geliefert am 22. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH april 1991 and this charge
    Kurze Angaben
    (See form 395 tc ref M85 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 04. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of deposit
    Erstellt am 17. Jan. 1990
    Geliefert am 06. Feb. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 12.9.85
    Kurze Angaben
    £9,375.
    Berechtigte Personen
    • Cheverell Estates Limited
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Jan. 1989
    Geliefert am 26. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Please refer to form M395 ref M609C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juni 1986
    Geliefert am 03. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Please see doc M21. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    • 02. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Secured loan stock
    Erstellt am 19. Dez. 1985
    Geliefert am 03. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 08. Juli 1985
    Geliefert am 17. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge on all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    • 19. Juni 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SCOTIA HOLDINGS PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Jan. 2001Beginn der Verwaltung
    24. Mai 2018Verwaltung entlassen
    Verwaltungsordnung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher John Wilkinson Hill
    Ernst & Young
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Ernst & Young
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Andrew James Rodney Wollaston
    Ernst & Young
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Ernst & Young
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Colin Peter Dempster
    Ernst & Young
    10 George Street
    Edinburgh
    Eh2 2dz
    Praktiker
    Ernst & Young
    10 George Street
    Edinburgh
    Eh2 2dz
    Thomas Merchant Burton
    Ernst & Young Llp
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Shagun Sunil Dubey
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0