BERISFORD TREASURY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBERISFORD TREASURY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01855793
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BERISFORD TREASURY LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich BERISFORD TREASURY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BERISFORD TREASURY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BERISFORD PROPERTY CONSTRUCTION LIMITED06. Apr. 198806. Apr. 1988
    MANORDREAM LIMITED16. Okt. 198416. Okt. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BERISFORD TREASURY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für BERISFORD TREASURY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 09. Mai 2012

    • Kapital: GBP 225,224
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Ernennung von Graham Philip Brisley Veal als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Adrian David Gray als Direktor

    3 SeitenAP01

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von BERISFORD TREASURY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Geschäftsführer
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Geschäftsführer
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Geschäftsführer
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Sekretär
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    CAHILL, Niamh
    1 Walton House
    N7 7PD London
    Sekretär
    1 Walton House
    N7 7PD London
    British12415660001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Sekretär
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Geschäftsführer
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Geschäftsführer
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    LEES, David William
    Rodmell Grange Mill Lane
    Rodmell
    BN7 3HS Lewes
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Rodmell Grange Mill Lane
    Rodmell
    BN7 3HS Lewes
    East Sussex
    British6191760001
    NOBLE, Andrew Villiers
    386 Malden Road
    KT4 7NJ Worcester Park
    Surrey
    Geschäftsführer
    386 Malden Road
    KT4 7NJ Worcester Park
    Surrey
    British64593020001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    WIMMS, Richard Alan
    14 Sopwell Lane
    AL1 1RR St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    14 Sopwell Lane
    AL1 1RR St Albans
    Hertfordshire
    British14029320001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Geschäftsführer
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Geschäftsführer
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    Hat BERISFORD TREASURY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A deed of amendment
    Erstellt am 30. Sept. 1991
    Geliefert am 16. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For amending and supplemental to a second banking debenture dated 26/9/90
    Kurze Angaben
    See 395 for details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Sept. 1990
    Geliefert am 09. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to national westminster bank PLC (the "second security agent") and the banks (as defined) or any of them under the terms of I) the indebtedness agreements and ii) the coffee refinancing agreement and all monies due from berisford international PLC under the subordinated guarantee
    Kurze Angaben
    Please see 395 for full details.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminstr Bank PLC(The "Second Security Agent")
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Jan. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Sept. 1990
    Geliefert am 09. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obbgor (as defined) to natural westminster bank PLC (the "security agent") and the banks (as defined) or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements to which such obligon is a party
    Kurze Angaben
    Please see 395 for full details.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further charge
    Erstellt am 06. Mai 1987
    Geliefert am 15. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become die from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a supplemental agreement dated 6 may 87 and this charge
    Kurze Angaben
    All & every interest of the company in all that f/h property k/as 51 eastcheap london EC3 title no. Ln 120282.
    Berechtigte Personen
    • A P Bank Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Inst legal charge
    Erstellt am 30. Mai 1986
    Geliefert am 03. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from th e company and/or all or any of the other companies named therein to a p bank limited for itself and as agent for the banks pursuant to the loan and letter of credit facility dated 2ND may 1986 and this charge
    Kurze Angaben
    The f/hold property k/as and being 51 eastcheap londn EC3 t/n ln 120282 first floating charge over the indertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • A P Bank Limitedas Agent for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 03. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 1986
    Geliefert am 03. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to a p bank limited for itself and as agent for the banks pursuent to the loan and letter of credit facility dated 2ND may 1986 and this charge
    Berechtigte Personen
    • A P Bank Limitedas Agent for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 03. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 1986
    Geliefert am 03. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any or the other companies named therein to ap bank limited for itself and as agent for the banks pursuant to the loan and letter of credit facility dated 2ND may 1986 and this charge
    Kurze Angaben
    The 51 eastcheap partnership receivable account with barclays bank PLC (lombard stree branch) accont no 90892726 as continuing security.
    Berechtigte Personen
    • A P Bank Limitedas Agent for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 03. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Sept. 1985
    Geliefert am 28. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the pricipal charge dated 9TH april 1985, the principal and further facility letter dated 2ND april 1985 and 16TH august 1985 and this charge.
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as 51 eastcheaf, london EC3 t/n ln 120282 for futrehr details doc 15.
    Berechtigte Personen
    • A.P. Bank Limited
    Transaktionen
    • 28. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Apr. 1985
    Geliefert am 25. Apr. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chrgee under the terms of a facility letter dated 2 april 1985
    Kurze Angaben
    F/Hold 51 east cheap london EC3. Title no. Ln 120282.
    Berechtigte Personen
    • A.P. Bank Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1985Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0