BLUEROOM PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBLUEROOM PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01856852
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BLUEROOM PROPERTIES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BLUEROOM PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    305 Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BLUEROOM PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KINGDOMWIDE LIMITED24. März 199924. März 1999
    NORTH BRITISH URBAN RENEWAL LIMITED18. Okt. 198418. Okt. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLUEROOM PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für BLUEROOM PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 23. Feb. 2023

    • Kapital: GBP 36,000,000
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2022 bis 30. März 2022

    1 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 52 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 51 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 50 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 48 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 47 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 46 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 49 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 45 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 44 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 43 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von BLUEROOM PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARTIN, Christopher Paul
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    Sekretär
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    British64640450003
    WEIGHTMAN, Timothy John
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    Geschäftsführer
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    United KingdomBritish202735610003
    BINKS, Steven
    1 The Orchard
    Spen Lane, Treales
    PR4 3EZ Preston
    Lancashire
    Sekretär
    1 The Orchard
    Spen Lane, Treales
    PR4 3EZ Preston
    Lancashire
    British63761990005
    BINKS, Steven
    1 The Orchard
    Spen Lane, Treales
    PR4 3EZ Preston
    Lancashire
    Sekretär
    1 The Orchard
    Spen Lane, Treales
    PR4 3EZ Preston
    Lancashire
    British63761990005
    FORDYCE, Gordon Alexander Robert
    21 Woodlands Avenue
    BB2 5NW Blackburn
    Lancashire
    Sekretär
    21 Woodlands Avenue
    BB2 5NW Blackburn
    Lancashire
    British59210210001
    REEVES, Martin Leslie
    Glendale
    Gryfe Road
    PA11 3AL Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Sekretär
    Glendale
    Gryfe Road
    PA11 3AL Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British28069150002
    TOLSON, David Martin
    19 Greencroft
    Penwortham
    PR1 9LA Preston
    Lancashire
    Sekretär
    19 Greencroft
    Penwortham
    PR1 9LA Preston
    Lancashire
    British17778420001
    TRAINOR, Wendy Louise
    4 The Pavilions Portway
    PR2 2YB Preston
    Lancashire
    Sekretär
    4 The Pavilions Portway
    PR2 2YB Preston
    Lancashire
    British124873460001
    BINKS, Steven
    1 The Orchard
    Spen Lane, Treales
    PR4 3EZ Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    1 The Orchard
    Spen Lane, Treales
    PR4 3EZ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish63761990005
    BLAKEY, Colin
    133 Eastern Way
    Darras Hall
    NE20 9RH Ponteland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    133 Eastern Way
    Darras Hall
    NE20 9RH Ponteland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish18947160001
    COWANS, David
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    Geschäftsführer
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    EnglandBritish,Irish108543490012
    COX OBE, Sebert Leslie
    Spurtop House
    Whitehall Lane
    DH8 7TA Iveston
    County Durham
    Geschäftsführer
    Spurtop House
    Whitehall Lane
    DH8 7TA Iveston
    County Durham
    EnglandBritish299375250001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    12 The Parade
    CO14 8EH Walton On The Naze
    Essex
    Geschäftsführer
    12 The Parade
    CO14 8EH Walton On The Naze
    Essex
    British46176700001
    SHAW, David John
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    United KingdomBritish110422430008
    SOIN, Simran Bir Singh
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    United KingdomBritish129897450001
    SOUTHWORTH, John Damian
    109 Brampton Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6SG Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    109 Brampton Drive
    Bamber Bridge
    PR5 6SG Preston
    Lancashire
    British100572890002
    THE NORTH BRITISH HOUSING ASSOCIATION LTD
    4 The Pavilions
    Ashton On Ribble
    PR2 2YB Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    4 The Pavilions
    Ashton On Ribble
    PR2 2YB Preston
    Lancashire
    3688860001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BLUEROOM PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Places For People Group Limited
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    06. Apr. 2016
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Guarantee
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England & Wales
    Registrierungsnummer03777037
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat BLUEROOM PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 18. Mai 2004
    Geliefert am 26. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land comprised in t/no NN79342 being land at 30/40 campbell street northampton. All rights title and interest in all income and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 2004
    Geliefert am 14. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold land being city buildings fish stret northampton t/n HN15488. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 2004
    Geliefert am 05. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land known as 1-19 (excluding 13) monarch's gate and 21C st andrews rd,sheffield S11 9AL; syk 448981 and the proceeds of sale thereof and benefit of any covenants for title and any money payable thereon; all rights,title and interest in and to all income and claims payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 05. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 2004
    Geliefert am 05. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land known as 1-14 white house court,st olaves court,york YO30 7DB; t/no nyk 285198;and the proceeds of sale thereof and benefit of any covenants for title and any money payable thereon; all rights,title and interest in and to all income and claims payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 05. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 10TH november 2003 and
    Erstellt am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 25. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations & liabilities of the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 13 hamilton square (otherwise known as campbell close) hamilton t/n LAN166306, plot 14 hamilton square (otherwise known as campbell close) hamilton t/n 166305, plot 15 hamilton square (otherwise known as campbell close) hamilton t/n LAN166307. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee & Its Successors & Assignees Assecurity Trustee
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Apr. 2003
    Geliefert am 29. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The freehold land known as 159 bermondsey street london SE1 3UW t/n TGL197969 and the leasehold car parking spaces numbers 31-39 inclusive service road 175 bermondsey street london SE1 t/n TGL194034, TGL196126, TGL196127, TGL196128, TGL196129, TGL196130, TGL196131, TGL196132, TGL196133 & TGL196134. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 08. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the borrower to the chargee as security trustee (the "security trustee") for the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land together with the 23 residential apartments k/a 1-23 (inclusive) and 2 commercial units comprised in brockway house 257 holloway road london N7 part t/no: NGL509021. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20 march 2003 and
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    34 flatted dwellinghouses (formerly k/a plot numbers 69 to 102 inclusive erected or to be erected within the blocks numbered 4, 5, 6 and 7) k/a block 170 flats 1 to 9 (inclusive), block 172 flats 1 to 8 (inclusive), block 176 flats 1 to 8 and block 178 flats 1 to 9 (inclusive) forming part of a development at gyle meadow, gylemuir road edinburgh in the city of edinburgh and county of midlothian. For details of further property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20 march 2003 and
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    24 and 25 riverside drive, aberdeen t/n ABN41486 under exception of the subjects k/a 24A riverside drive, aberdeen t/n ABN62906. 26 riverside drive, aberdeen t/n ABN43595. For details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20 march 2003 and
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Area or piece of ground lying in the parish of belhelvie and county of aberdeen extending to 1 acre 0.685 of an acre. 10 parking spaces lying generally to the north of pettens close, balmedie in the parish of belhelvie and county of aberdeen. Area of ground extending to 22 square metres at pettens close t/n ABN7560. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20 march 2003 and
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1-35 (inclusive) (but excluding number 13) bloomfield court, aberdeen t/n ABN4312.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20 march 2003 and
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Ground lying generally to the east and south of castle heather drive, inverness in the county of inverness. Flat 5 castle heather drive, inverness (formerly plot 252 of the castle heather village development) t/n INV3516. Flat 45 castle heather drive, inverness (formerly plot number 239 of the castle heather village development) t/n INV3216. For details of further property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20 march 2003 and
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Piece of ground in the city of edinburgh and county of midlothian extending to 0.75 of an acre. Flat 130/5 gylemuir road, edinburgh t/n MID26889; flat 132/1 gylemuir road, edinburgh t/n MID35188. For details of further property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20 march 2003 and
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1/1, 6 waterside place, glasgow t/n GLA161715; 2/1, 6 waterside place, glasgow t/n GLA161714; 1/2, 10 waterside place, glasgow t/n GLA160678. For details of further property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20 march 2003 and
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Area of ground extending to 0.81 of an acre lying west of the morrison homes housing development k/a grandfield, on the west side of craighall road, edinburgh in the city of edinburgh and county of midlothian. That area or piece of ground extending to 25 metres sq lying to the northwest of but not adjacent to craighall gardens, edinburgh in the county of midlothian. Flat 6/6 grandfield, craighall road, edinburgh t/n MID26184. For details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land comprised in title numbers LT219475, LT89810 and LT236942 and k/a 1-16 (excluding 13) 1 norton street leicester LE1 5TN, 17-27, 2 lower brown street leicester LE1 5TH and 28-41, 22 york road leicester LE1 5TS the proceeds of sale the benefit of any covenants for title and all rights title interest and claims in connection with or in reference to the charged property including rental income service charges and licence fees and proceeds of any sale of any interest in the charge property and the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 2002
    Geliefert am 18. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 219 long lane bermondsey SE1 4PR t/no.TGL80377 and all buildings erections fixtures and fittings fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 2002
    Geliefert am 18. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 31-33 suffolk road t/no.DT58885 and all buildings erections fixtures and fittings fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 03. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) f/hold land with 20 flats erected thereon nd known as 1-20 (inc) meadow court,george close,canvey island,essex; EX604355 and EX607477; (ii) f/hold land known as 2-4 winbourne rd,poole,dorset together with 16 flats erected thereon and known as flats 1-17 (excluding 13) 2 denmark road together with the ground floor commercial unit; DT149583 and DT272035; the proceeds of sale thereof and benefit of any covenants for title and any money payable thereon; all rights,title and interest in and to all income and claims and the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 03. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 20TH february 2002
    Erstellt am 13. Feb. 2002
    Geliefert am 01. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that flatted dwellinghouse being the south west most flat on the first floor above the ground floor known as and forming plot "73" and lying in the county of fife forming part of the development at dalgety bay fife which subjects hereinbefore disponed form part and portion of all and whole the subjects and others registered in the land register of scotland title number FFE019414.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 20TH february 2002
    Erstellt am 13. Feb. 2002
    Geliefert am 01. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that flatted dwellinghouse being the north east most flat on the third floor above the ground floor known as and forming plot "70" and lying in the county of fife forming part of the development at dalgety bay fife which subjects form part and portion of all and whole the subjects and others registered in the land register of scotland under title number FFE019414.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 20TH february 2002
    Erstellt am 13. Feb. 2002
    Geliefert am 01. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that flatted dwellinghouse being the south west most flat on the second floor above the ground floor known as and forming plot "75" and lying in the county of fife forming part of the development at dalgety bay fife which subjects form part and portion of all and whole the subjects and others registered in the land register of scotland under title number FFE019414.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 20TH february 2002
    Erstellt am 13. Feb. 2002
    Geliefert am 01. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that flatted dwellinghouse being the south west most flat on the third floor above the ground floor known as and forming plot "77" and lying in the county of fife forming part of the development at dalgety bay fife which subjects form part and portion of all and whole the subjects and others registered in the land register of scotland under title number FFE019414.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 20TH february 2002
    Erstellt am 13. Feb. 2002
    Geliefert am 01. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that flatted dwellinghouse being the north east most flat on the first floor above the ground floor known as and forming plot "66" and lying in the county of fife forming part of the development at dalgety bay fife which subjects form part and portion of all and whole the subjects and others registered in the land register of scotland under title number FFE019414.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 20TH february 2002
    Erstellt am 13. Feb. 2002
    Geliefert am 01. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that flatted dwellinghouse being the south west most flat on the first floor above the ground floor known as and forming plot "67" and lying in the county of fife forming part of the development at dalgety bay fife which subjects form part and portion of all and whole the subjects and others registered in the land register of scotland under title number FFE019414.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0